Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

93
Vol. 134, No. 18 Vol. 134, n o 18 Canada Gazette Gazette du Canada Part I Partie I OTTAWA, SATURDAY, APRIL 29, 2000 OTTAWA, LE SAMEDI 29 AVRIL 2000 NOTICE TO READERS AVIS AU LECTEUR The Canada Gazette is published under authority of the Statutory Instruments Act. It consists of three parts as described below: La Gazette du Canada est publiée conformément aux dispositions de la Loi sur les textes réglementaires. Elle est composée des trois parties suivantes : Part I Material required by federal statute or regulation to be published in the Canada Gazette other than items identified for Parts II and III below — Published every Saturday Partie I Textes devant être publiés dans la Gazette du Canada conformément aux exigences d’une loi fédérale ou d’un règlement fédéral et qui ne satisfont pas aux critères des Parties II et III — Publiée le samedi Part II Statutory Instruments (Regulations) and other classes of statutory instruments and documents — Published January 5, 2000, and at least every second Wednesday thereafter Partie II Textes réglementaires (Règlements) et autres catégories de textes réglementaires et de documents — Publiée le 5 janvier 2000 et au moins tous les deux mercredis par la suite Part III Public Acts of Parliament and their enactment proclamations — Published as soon as is reasonably practicable after Royal Assent Partie III Lois d’intérêt public du Parlement et les proclamations énonçant leur entrée en vigueur — Publiée aussitôt que possible après la sanction roy ale The Canada Gazette is available in most public libraries for consultation. On peut consulter la Gazette du Canada dans la plupart des bibliothèques publiques. To subscribe to, or obtain copies of, the Canada Gazette, contact bookstores selling Government publications as listed in the telephone directory or write to: Canadian Government Publishing, Public Works and Government Services Canada, Ottawa, Canada K1A 0S9. On peut s’abonner à la Gazette du Canada ou en obtenir des exemplaires en s’adressant aux agents libraires associés énumérés dans l’annuaire téléphonique ou en s’adressant à : Les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Canada K1A 0S9. Canada Gazette Part I Part II Part III Gazette du Canada Partie I Partie II Partie III Yearly subscription Abonnement annuel Canada $135.00 $67.50 $28.50 Canada 135,00 $ 67,50 $ 28,50 $ Outside Canada US$135.00 US$67.50 US$28.50 Extérieur du Canada 135,00 $US 67,50 $US 28,50 $US Per copy Exemplaire Canada $2.95 $3.50 $4.50 Canada 2,95 $ 3,50 $ 4,50 $ Outside Canada US$2.95 US$3.50 US$4.50 Extérieur du Canada 2,95 $US 3,50 $US 4,50 $US

Transcript of Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Page 1: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no 18

CanadaGazette

Gazettedu Canada

Part I Partie IOTTAWA, SATURDAY, APRIL 29, 2000 OTTAWA, LE SAMEDI 29 AVRIL 2000

NOTICE TO READERS AVIS AU LECTEUR

The Canada Gazetteis published under authority of theStatutory Instruments Act. It consists of threeparts as describedbelow:

La Gazette du Canadaest publiée conformément auxdispositions de laLoi sur les textes réglementaires. Elle estcomposée des troisparties suivantes :

Part I Material required by federal statute or regulation tobepublished in theCanada Gazetteother than itemsidentified for Parts II and III below — Publishedevery Saturday

Partie I Textes devant êtrepubliés dans laGazette duCanada conformément aux exigences d’une loifédérale ou d’un règlement fédéral etqui ne satisfontpas aux critères des Parties II et III — Publiée lesamedi

Part II Statutory Instruments (Regulations) and other classesof statutory instruments and documents — PublishedJanuary 5, 2000, and at least every secondWednesday thereafter

Partie II Textes réglementaires (Règlements) et autres catégoriesde textes réglementaires et de documents — Publiée le5 janvier 2000 et au moins tous les deux mercredispar lasuite

Part III Public Acts of Parliament and their enactmentproclamations — Published as soon as is reasonablypracticable after Royal Assent

Partie III Lois d’intérêtpublic du Parlement et lesproclamationsénonçant leur entrée en vigueur — Publiée aussitôtquepossible après la sanction royale

The Canada Gazetteis available in mostpublic libraries forconsultation.

On peut consulter laGazette du Canadadans laplupart desbibliothèquespubliques.

To subscribe to, or obtain copies of, the Canada Gazette,contact bookstores selling Governmentpublications as listedin the telephone directory or write to: Canadian GovernmentPublishing, Public Works and Government Services Canada,Ottawa, Canada K1A 0S9.

On peut s’abonner à laGazette du Canadaou en obtenir desexemplaires en s’adressant aux agents libraires associés énumérésdans l’annuaire téléphonique ou en s’adressant à : LesÉditionsdu gouvernement du Canada, Travauxpublics et Servicesgouvernementaux Canada, Ottawa, Canada K1A 0S9.

Canada Gazette Part I Part II Part III Gazette du Canada Partie I Partie II Partie III

Yearly subscription Abonnement annuelCanada $135.00 $67.50 $28.50 Canada 135,00 $ 67,50 $ 28,50 $Outside Canada US$135.00 US$67.50 US$28.50 Extérieur du Canada 135,00 $US 67,50 $US 28,50 $US

Per copy ExemplaireCanada $2.95 $3.50 $4.50 Canada 2,95 $ 3,50 $ 4,50 $Outside Canada US$2.95 US$3.50 US$4.50 Extérieur du Canada 2,95 $US 3,50 $US 4,50 $US

Page 2: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

REQUESTS FOR INSERTION DEMANDES D’INSERTION

Requests for insertion should be directed to the CanadaGazette Directorate, Public Works and Government ServicesCanada, 350 Albert Street, 5th Floor, Ottawa, Ontario K1A 0S5,(613) 991-1351 (Telephone), (613) 991-3540 (Facsimile).

Les demandes d’insertion doivent être envoyées à laDirection de la Gazette du Canada, Travauxpublics et Servicesgouvernementaux Canada, 350, rue Albert, 5e étage, Ottawa(Ontario) K1A 0S5, (613) 991-1351 (téléphone), (613) 991-3540(télécopieur).

Bilingual texts received as late as six working days before thedesired Saturday’s date of publication will, if time and otherresourcespermit, be scheduled forpublication that date.

Un texte bilingue reçu auplus tard sixjours ouvrables avant ladate deparution demandéeparaîtra, le temps et autres ressourcesle permettant, le samedi visé.

Each client will receive a free copy of the Canada Gazetteforevery week during which a notice ispublished.

Pour chaque semaine deparution d’un avis, le client recevra unexemplaire gratuit de laGazette du Canada.

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, represented by theMinister of Public Works and Government Services, 2000Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par leministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, 2000

Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2000

Page 3: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

_______ _______

* Notices are listed alphabetically in the Index. * Les avis sont énumérés alphabétiquement dans l’index.

Le 29 avril 2000 Gazette du Canada Partie I 1333

TABLE OF CONTENTS TABLE DES MATIÈRES

No. 18 — April 29, 2000 No 18 — Le 29 avril 2000

Government House*........................................................ 1334Résidence du Gouverneurgénéral* ................................. 1334(orders, decorations and medals) (ordres, décorations et médailles)

Government Notices*...................................................... 1335Avis du Gouvernement*.................................................. 1335

Parliament ParlementHouse of Commons ...................................................... 1339 Chambre des communes ............................................... 1339Bills assented to ............................................................ 1339 Projets de loi sanctionnés.............................................. 1339

Commissions*................................................................. 1340Commissions*................................................................. 1340(agencies, boards and commissions) (organismes, conseils et commissions)

Miscellaneous Notices*................................................... 1348Avis divers* ..................................................................... 1348(banks; mortgage, loan, investment, insurance andrailway companies; otherprivate sector agents)

(banques; sociétés deprêts, de fiducie etd’investissements; compagnies d’assurances et dechemins de fer; autres agents du secteurprivé)

Proposed Regulations* .................................................... 1359Règlementsprojetés*....................................................... 1359(including amendments to existing regulations) (y compris les modifications aux règlements existants)

Index ................................................................................ 1361Index ................................................................................ 1362

Supplements Suppléments

Office of the Superintendent of Financial Institutions Bureau du surintendant des institutions financières

Page 4: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

1334 Canada Gazette Part I April 29, 2000

GOVERNMENT HOUSE RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

AWARDS TO CANADIANS DÉCORATIONS À DES CANADIENS

The Chancellery of Honours has announced that the CanadianGovernment has approved the following awards to Canadians:

La Chancellerie des distinctions honorifiques annonceque leGouvernement du Canada a approuvé l’octroi des distinctionshonorifiques suivantes à des Canadiens :

From the Government of AustriaCross of Honour for Science and Artsto Professor Frederick C. Engelmann

Du Gouvernement de l’Autrichela Croix d’honneur de la Science et des Artsau professeur Frederick C. Engelmann

From the Government of GermanyOfficer’s Cross of the Order of Meritto Professor Peter Conrad Werner Hoffmann

Du Gouvernement de l’Allemagnela Croix d’Officier de l’Ordre du Mériteau professeur Peter Conrad Werner Hoffmann

From the Government of Great BritainOfficer of the Order of the British Empireto Mrs. Susan Anne Scott Parker Leigh

Du Gouvernement de la Grande-BretagneOfficier de l’Ordre de l’Empire britanniqueà Mme Susan Anne Scott Parker Leigh

From the Government of HungarySmall Cross of the Order of Meritto Rev. Dr. Jozsef Pungur

Du Gouvernement de la Hongriela petite Croix de l’Ordre du Mériteau révérend docteur Jozsef Pungur

From the Government of NorwayNorwegian Participation Medalto Mr. Ivan Joseph Chiasson

Mr. Harry Ray Putney

Du Gouvernement de la Norvègela Médaille norvégienne de Participationà M. Ivan Joseph Chiasson

M. Harry Ray Putney

From the Government of PolandCommander’s Cross of the Order of Meritto Mr. Jan ZurakowskiKnight’s Cross of the Order of Meritto MGen Hugh Cameron Ross, O.M.M., C.D.

Mr. Marian WojdanGold Cross of the Order of Meritto Mr. Henryk Antonowicz

Mr. Jan Zygmunt ArmataMs. Maria Halas

Du Gouvernement de la Polognela Croix de Commandeur de l’Ordre du Mériteà M. Jan Zurakowskila Croix de chevalier de l’Ordre du Mériteau Mgén Hugh Cameron Ross, O.M.M., C.D.à M. Marian Wojdanla Croix d’or de l’Ordre du Mériteà M. Henryk Antonowicz

M. Jan Zygmunt ArmataMme Maria Halas

From the Government of SwedenRoyal Order of the Polar Starto Mr. Ronald E. Shirkey

Du Gouvernement de la Suèdel’Ordre royal de l’Étoile polaireà M. Ronald E. Shirkey

From the Government of the U.S.A.Soldier’s Medalto CWO Joseph D. Vienneau, C.D.Meritorious Service Medalto Capt Jerome E. Carell

LCol John Dick, C.D.Maj John D. Graham, C.D.Cdr Laurence M. Hickey, C.D.LCol David D. Peart, C.D.

Du Gouvernement des É.-U.A.la Médaille du Soldatà l’ Adjuc Joseph D. Vienneau, C.D.la Médaille du Service méritoireaux Capt Jerome E. Carell

Lcol John Dick, C.D.Maj John D. Graham, C.D.Cdr Laurence M. Hickey, C.D.Lcol David D. Peart, C.D.

LGEN (Ret’d) JAMES C. GERVAIS, C.M.M., C.D.Deputy Secretary

Le sous-secrétaire

LGÉN (retraité) JAMES C. GERVAIS, C.M.M., C.D.[18-1-o] [18-1-o]

Page 5: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Le 29 avril 2000 Gazette du Canada Partie I 1335

GOVERNMENT NOTICES AVIS DU GOUVERNEMENT

DEPARTMENT OF HEALTH MINISTÈRE DE LA SANTÉ

FOOD AND DRUGS ACT LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Food and Drug Regulations— Amendment Règlement sur les aliments et drogues— Modification

Interim Marketing Authorization Autorisation de mise en marchéprovisoire

Provision currently exists in theFood and Drug Regulationsfor the use of the alpha-amylase enzyme produced by Bacilluslicheniformisand differentgenetically modified strains ofBacil-lus licheniformisat levels of use consistent withgood manufac-turing practice in theproduction of brewers’ mash, distillers’mash and on starch used in theproduction of dextrins, maltose,dextrose,glucose andglucose solids. Health Canada has receiveda submission topermit the use of the alpha-amylase enzyme pro-duced by Bacillus licheniformisgenetically modified to containmultiple copies of its natural alpha-amylasegene in theproduc-tion of the aboveproducts. Evaluation of available data supportsthe safety and effectiveness of this use of the alpha-amylase en-zyme produced by Bacillus licheniformisgenetically modified tocontain multiple copies of its natural alpha-amylasegene.

Il existe actuellement une disposition dans leRèglement sur lesaliments et droguesqui autorise l’utilisation de l’enzyme alpha-amylase obtenue àpartir de Bacillus licheniformiset de diffé-rentes souchesgénétiquement modifiées deBacillus licheniformisà une concentration conforme aux bonnespratiques industriellesdans laproduction de moût de bière, de moût de distillerie et dansl’amidon entrant dans laproduction des dextrines, du maltose, dudextrose, duglucose et des solides deglucose. Santé Canada areçu une demande visant l’utilisation de l’alpha-amylase obtenueà partir de Bacillus licheniformismodifié génétiquement de ma-nière à contenir des copies multiples de songène naturel de l’en-zyme alpha-amylase dans laproduction desproduits susmention-nés. L’évaluation des données disponibles confirme l’innocuité etl’efficacité de cette utilisation de l’enzyme alpha-amylase obtenueà partir de Bacillus licheniformismodifié génétiquement de ma-nière à contenir des copies multiples de songène naturelpourl’enzyme alpha-amylase.

The use of this alpha-amylase enzyme, as indicated above, willbenefit the industry by providing an alternative and more efficientmethod for theproduction of brewers’ mash, distillers’ mash,dextrins, maltose, dextrose,glucose (glucose syrup) and glucosesolids (dried glucose syrup), thus improving yield andproductivity.

L’utilisation de cette alpha-amylase, comme il est mentionnéci-dessus, sera avantageusepour l’industrie enpermettant l’accèsà une méthode différente etplus efficacepour la production demoût de bière, de moût de distillerie, des dextrines, du maltose,du dextrose, duglucose (sirop de glucose) et des solides deglu-cose (sirop de glucose déshydraté), améliorant ainsi le rendementet laproductivité.

Therefore, it is the intention of Health Canada to amend theFood and Drug Regulationsto permit the use of the alpha-amylase enzyme produced by Bacillus licheniformisgeneticallymodified to contain multiple copies of its natural alpha-amylasegene for thepurposes outlined above at a maximum level of useconsistent withgood manufacturing practice.

Santé Canada sepropose donc de modifier leRèglement sur lesaliments et droguesafin d’y autoriser l’utilisation de l’alpha-amylase obtenue àpartir deBacillus licheniformismodifié géné-tiquement de manière à contenir des copies multiples de songènenaturelpour l’enzyme alpha-amylase, aux fins décrites ci-dessus,selon une limite de tolérance conforme aux bonnespratiquesindustrielles.

As a means to improve the responsiveness of the regulatorysystem, an Interim Marketing Authorization (IMA) is being is-sued topermit the immediate use of this alpha-amylase enzyme asindicated above while the regulatory process to amend the Regu-lations formally is undertaken.

Dans le but d’améliorer la souplesse du système de réglemen-tation, Santé Canada émet une autorisation de mise en marchéprovisoire (AMP) autorisant l’utilisation immédiate de cettealpha-amylase, conformément aux indications ci-dessus,pendantque le processus officiel de modification du Règlement suit soncours.

April 14, 2000 Le 14 avril 2000

DIANE C. GORMANActing Assistant Deputy Minister

Health Protection Branch

La sous-ministre adjointe intérimaireDirection générale de la protection de la santé

DIANE C. GORMAN

[18-1-o] [18-1-o]

DEPARTMENT OF HEALTH MINISTÈRE DE LA SANTÉ

FOOD AND DRUGS ACT LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Food and Drug Regulations— Amendment Règlement sur les aliments et drogues— Modification

Interim Marketing Authorization Autorisation de mise en marchéprovisoire

Provision currently exists in theFood and Drug Regulationsfor the use ofglucose isomerase enzyme produced by Strepto-myces rubiginosusATCC No. 21,175 at levels consistent withgood manufacturing practice in the production of glucose

Le Règlement sur les aliments et droguesautorise actuellementl’utilisation de l’enzyme glucose-isoméraseprovenant deStrep-tomyces rubiginosusATCC no 21,175 à une concentration con-forme aux bonnespratiques industrielles dans laproduction de

Page 6: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

1336 Canada Gazette Part I April 29, 2000

(glucose syrup) to be partially or completely isomerized to fruc-tose. Health Canada has received a submission topermit the useof the glucose isomerase (wild type) enzyme produced by Strep-tomyces rubiginosusgenetically modified to contain multiplecopies of glucose isomerasegene in theproduction of high fruc-tose corn syrups. Evaluation of available data supports the safetyand effectiveness of this use of theglucose isomerase enzymeproduced by Streptomyces rubiginosusgenetically modified tocontain multiple copies of the glucose isomerasegene fromStreptomyces rubiginosus.

glucose (sirop de glucose) à êtrepartiellement ou complètementtransformé en fructosepar isomérisation. Santé Canada a reçuune demandepour que soit autorisée l’utilisation de l’enzymeglucose-isomérase (type sauvage) provenant deStreptomycesrubiginosusmodifié génétiquement de manière à contenir descopies multiples dugènepour la glucose-isomérase dans lapro-duction de sirop de maïs à haute teneur en fructose. L’évaluationdes données disponibles confirme l’innocuité et l’efficacité decette application de l’enzyme glucose-isoméraseprovenant deStreptomyces rubiginosusmodifié génétiquement de manière àcontenir des copies multiples dugènepour laglucose-isomérase.

The use of thisglucose isomerase enzyme will benefit industryby providing an alternative source of this food enzyme in theproduction of the above-mentionedproduct.

L’industrie bénéficiera de l’utilisation de cetteglucose-isomérase, en ayant accès à une source alternative de cette en-zyme alimentairepour la production de sirop de maïs à hauteteneur en fructose.

Therefore, it is the intention of Health Canada to amend theFood and Drug Regulationsto permit the use of theglucoseisomerase enzyme produced by Streptomyces rubiginosusgeneti-cally modified to contain multiple copies of the glucoseisomerasegene fromStreptomyces rubiginosusin the productionof high fructose corn syrups at a level consistent withgood manu-facturing practice.

Santé Canada sepropose donc de modifier leRèglement surles aliments et droguesafin d’autoriser l’utilisation de l’enzymeglucose-isoméraseprovenant deStreptomyces rubiginosusmodi-fié génétiquement de manière à contenir des copies multiples dugène pour la glucose-isomérase dans laproduction de sirop demaïs à haute teneur en fructose selon une limite de tolérance con-forme aux bonnespratiques industrielles.

As a means to improve the responsiveness of the regulatorysystem, an Interim Marketing Authorization (IMA) is being is-sued topermit the immediate use of thisglucose isomerase en-zyme as indicated above while the regulatory process to amendthe Regulations formally is undertaken.

Dans le but d’améliorer la souplesse du système de réglemen-tation, Santé Canada émet une autorisation de mise en marchéprovisoire (AMP) autorisant l’utilisation immédiate de cetteglucose-isomérase, conformément aux indications ci-dessus,pen-dantque leprocessus officiel de modification du Règlement suitson cours.

April 14, 2000 Le 14 avril 2000

DIANE C. GORMANActing Assistant Deputy Minister

Health Protection Branch

La sous-ministre adjointe intérimaireDirection générale de la protection de la santé

DIANE C. GORMAN[18-1-o] [18-1-o]

DEPARTMENT OF HEALTH MINISTÈRE DE LA SANTÉ

FOOD AND DRUGS ACT LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Food and Drug Regulations— Amendment Règlement sur les aliments et drogues— Modification

Interim Marketing Authorization Autorisation de mise en marchéprovisoire

Provision currently exists in theFood and Drug Regulationsfor the use of the enzyme pullulanaseproduced by Bacillus aci-dopullulyticusNCIB 11647 and by Bacillus licheniformisSE2-Pul-int211 (pUBCDEBRA11DNSI) at levels consistent withgood manufacturing practice in theproduction of starch-derivedsweeteners and a variety of bakery products. Health Canada hasreceived a submission topermit the use of thepullulanase enzymeproduced by a Bacillus licheniformisorganismgenetically modi-fied to contain thepullulanasegene fromBacillus deramificansintheproduction of brewer’s mash, bread, flour, whole wheat flour,unstandardized bakery products and on starch used in thepro-duction of dextrins, maltose, dextrose,glucose,glucose solids orfructose syrups and solids. Evaluation of available data supportsthe effectiveness and safety of these uses of thepullulanaseenzyme produced by a Bacillus licheniformisorganism geneti-cally modified to contain thepullulanasegene from Bacillusderamificans.

Le Règlement sur les aliments et droguesautorise actuellementl’utilisation de l’enzyme pullulanaseprovenant deBacillus aci-dopullulyticusNCIB 11647 et deBacillus licheniformisSE2-Pul-int211 (pUBCDEBRA11DNSI) à des concentrations conformesavec les bonnespratiques industrielles dans laproduction d’édul-corants dérivés de l’amidon et d’une variété deproduits de bou-langerie. Santé Canada a reçu une demande visant l’utilisation dela pullulanase obtenue àpartir d’un microorganisme de l’espèceBacillus licheniformismodifié génétiquement de manière à con-tenir legènepour lapullulanase duBacillus deramificansdans laproduction de moût de bière, depain, de farine, de farine de bléentier, deproduits de boulangerie non normalisés et dans l’ami-don entrant dans laproduction des dextrines, du maltose, du dex-trose, duglucose, de solides deglucose ou de sirops et solides defructose. L’évaluation des données disponibles confirme l’inno-cuité et l’efficacité de ces utilisations de l’enzyme pullulanaseobtenue àpartir d’un microorganisme de l’espèce Bacillus li-cheniformismodifié génétiquement de manière à contenir legènepour lapullulanase duBacillus deramificans.

The use of thispullulanase enzyme will benefit industry byproviding an alternative source of this food enzyme in thepro-duction of the above-mentionedproducts.

L’utilisation de cette enzymepullulanase sera avantageusepourl’industrie puisqu’elle permettra l’accès à une source différentede cette enzyme alimentaire dans laproduction desproduitssusmentionnés.

Page 7: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Le 29 avril 2000 Gazette du Canada Partie I 1337

Therefore, it is the intention of Health Canada to amend theFood and Drug Regulationsto permit the use of thepullulanaseenzyme produced by Bacillus licheniformisgenetically modifiedto contain thepullulanasegene fromBacillus deramificansin theproduction of brewer’s mash, bread, flour, whole wheat flour,unstandardized bakery products and on starch used in thepro-duction of dextrins, maltose, dextrose,glucose,glucose solids orfructose syrups and solids at a level consistent withgood manu-facturing practice.

Santé Canada sepropose donc de modifier leRèglement sur lesaliments et droguesafin d’autoriser l’utilisation de l’enzymepullulanaseprovenant de l’espèceBacillus licheniformisgénéti-quement modifié de manière à contenir legènepour la pullula-nase duBacillus deramificansdans laproduction de moût debière, depain, de farine, de farine de blé entier, deproduits deboulangerie non normalisés et dans l’amidon entrant dans lapro-duction des dextrines, du maltose, du dextrose, duglucose, desolides deglucose ou de sirops et solides de fructose à une con-centration compatible avec les bonnespratiques industrielles.

As a means to improve the responsiveness of the regulatorysystem, an Interim Marketing Authorization (IMA) is being is-sued topermit the immediate use of thispullulanase enzyme asindicated above while the regulatory process to amend the Regu-lations formally is undertaken.

Dans le but d’améliorer la souplesse du système de réglemen-tation, Santé Canada émet une autorisation de mise en marchéprovisoire (AMP) autorisant l’utilisation immédiate de cettepul-lulanase, conformément aux indications ci-dessus,pendantque leprocessus de modification du Règlement suit son cours.

April 14, 2000 Le 14 avril 2000

DIANE C. GORMANActing Assistant Deputy Minister

Health Protection Branch

La sous-ministre adjointe intérimaireDirection générale de la protection de la santé

DIANE C. GORMAN[18-1-o] [18-1-o]

DEPARTMENT OF HEALTH MINISTÈRE DE LA SANTÉ

FOOD AND DRUGS ACT LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Food and Drug Regulations —Amendment Règlement sur les aliments et drogues —Modification

Interim Marketing Authorization Autorisation de mise en marchéprovisoire

Provision currently exists in theFood and Drug Regulationsfor the use of thepullulanase enzyme produced by Bacillus aci-dopullulyticusNCIB 11647 and by Bacillus licheniformisSE2-Pul-int211 (pUBCDEBRA11DNSI) at levels consistent withgood manufacturing practice in theproduction of starch-derivedsweeteners and a variety of bakery products. Health Canada hasreceived a submission topermit the use ofpullulanaseproducedby a Bacillus subtilisorganismgenetically modified to contain thepullulanasegene fromBacillus naganoensisin the production ofbrewer’s mash, distillers’ mash, bread, flour, whole wheat flour,unstandardized bakery products and on starch used in thepro-duction of dextrins, maltose, dextrose,glucose andglucose solidsat a level consistent withgood manufacturing practice. Evaluationof available data supports the effectiveness and safety of theseuses of pullulanaseproduced by a Bacillus subtilis organismgenetically engineered to contain thepullulanase gene fromBacillus naganoensis.

Le Règlement sur les aliments et droguesautorise actuellementl’utilisation de l’enzyme pullulanaseprovenant deBacillus aci-dopullulyticusNCIB 11647 et deBacillus licheniformisSE2-Pul-int211 (pUBCDEBRA11DNSI) à des concentrations conformesavec les bonnespratiques industrielles dans laproduction d’édul-corants dérivés de l’amidon et d’une variété deproduits de bou-langerie. Santé Canada a reçu une demande visant l’utilisation dela pullulanase obtenue àpartir d’un microorganisme de l’espèceBacillus subtilismodifié génétiquement de manière à contenir legène pour la pullulanase duBacillus naganoensisdans lapro-duction de moût de bière, de moût de distillerie, depain, de fa-rine, de farine de blé entier, deproduits de boulangerie non nor-malisés et dans l’amidon entrant dans laproduction des dextrines,du maltose, du dextrose, duglucose et de solides deglucose à desconcentrations conformes aux bonnespratiques industrielles.L’évaluation des données disponibles confirme l’innocuité etl’efficacité de ces utilisations de l’enzyme pullulanase obtenue àpartir d’un microorganisme de l’espèceBacillus subtilismodifiégénétiquement de manière à contenir legènepour la pullulanasedu Bacillus naganoensis.

The use of thispullulanase enzyme will benefit industry byproviding an alternative source of this food enzyme in thepro-duction of the above-mentionedproducts.

L’utilisation de cette enzymepullulanase sera avantageusepourl’industrie puisqu’elle permettra l’accès à une source différentede cette enzyme alimentaire dans laproduction desproduitssusmentionnés.

Therefore, it is the intention of Health Canada to amend theFood and Drug Regulationsto permit the use of thepullulanaseenzyme produced by a Bacillus subtilis organism geneticallymodified to contain thepullulanase gene from Bacillus na-ganoensisin the production of brewer’s mash, distillers’ mash,bread, flour, whole wheat flour, unstandardized bakery productsand on starch used in theproduction of dextrins, maltose, dex-trose,glucose andglucose solids at a level consistent withgoodmanufacturing practice.

Santé Canada sepropose donc de modifier leRèglement sur lesaliments et droguesafin d’autoriser l’utilisation de l’enzymepullulanaseprovenant d’un microorganisme de l’espèceBacillussubtilisgénétiquement modifié de manière à contenir legènepourla pullulanase deBacillus naganoensisdans la production demoût de bière, de moût de distillerie, depain, de farine, de farinede blé entier, deproduits de boulangerie non normalisés et dansl’amidon entrant dans laproduction des dextrines, du maltose, dudextrose, duglucose et de solides deglucose à une concentrationcompatible avec les bonnespratiques industrielles.

As a means to improve the responsiveness of the regulatorysystem, an Interim Marketing Authorization (IMA) is being

Dans le but d’améliorer la souplesse du système de réglemen-tation, Santé Canada émet une autorisation de mise en marché

Page 8: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

1338 Canada Gazette Part I April 29, 2000

issued topermit the immediate use of thispullulanase enzyme asindicated above while the regulatory process to amend the Regu-lations formally is undertaken.

provisoire (AMP) autorisant l’utilisation immédiate de cettepul-lulanase, conformément aux indications ci-dessus,pendantque leprocessus de modification du Règlement suit son cours.

April 14, 2000 Le 14 avril 2000

DIANE C. GORMANActing Assistant Deputy Minister

Health Protection Branch

La sous-ministre adjointe intérimaireDirection générale de la protection de la santé

DIANE C. GORMAN[18-1-o] [18-1-o]

OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF FINANCIALINSTITUTIONS

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONSFINANCI ÈRES

BANK ACT LOI SUR LES BANQUES

Habib Canadian Bank Banque Habib Canadienne

Notice is hereby given of the issuance on April 5, 2000,pursu-ant to section 22 of theBank Act, of letterspatent incorporatingHabib Canadian Bank.

Avis est par les présentes donné de l’émission en date du5 avril 2000, conformément à l’article 22 de laLoi sur les ban-ques, de lettrespatentes constituant la Banque Habib Canadienne.

April 18, 2000 Le 18 avril 2000

JOHN PALMERSuperintendent of Financial Institutions

Le surintendant des institutions financièresJOHN PALMER

[18-1-o] [18-1-o]

Page 9: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Le 29 avril 2000 Gazette du Canada Partie I 1339

PARLIAMENT PARLEMENT

HOUSE OF COMMONS CHAMBRE DES COMMUNES

Second Session, Thirty-Sixth Parliament Deuxième session, trente-sixième législature

PRIVATE BILLS PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

Standing Order 130 respecting notices of intended applicationsfor private bills waspublished in theCanada Gazette, Part I, onOctober 16, 1999.

L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande deprojets de loi d’intérêtprivé a étépublié dans la Partie I de laGazette du Canadadu 16 octobre 1999.

For further information, contact the Private Members’ BusinessOffice, House of Commons, Centre Block, Room 134-C, Ottawa,Ontario K1A 0A6, (613) 992-6443.

Pour obtenir d’autres renseignements,prière de communiqueravec le Bureau des affaires émanant des députés, Chambre descommunes,Édifice du Centre, Pièce 134-C, Ottawa (Ontario)K1A 0A6, (613) 992-6443.

ROBERT MARLEAUClerk of the House of Commons

Le greffier de la Chambre des communesROBERT MARLEAU

ROYAL ASSENT SANCTION ROYALE

Thursday, April 13, 2000 Le jeudi 13 avril 2000

This day at 6 p.m., Her Excellency the Governor General,pro-ceeded to the Chamber of the Senate, in the Parliament Buildings,and took her seat at the foot of the Throne. The Members of theSenate being assembled, Her Excellency the Governor Generalwas pleased to command the attendance of the House of Com-mons, and that House being present, the following Bills wereassented to in Her Majesty’s name by Her Excellency the Gover-nor General:

Aujourd’hui à 18 h, Son Excellence la Gouverneuregénérale,est venue à la Chambre du Sénat, en l’Hôtel du Parlement et apris place aupied du Trône. Les membres du Sénat étant assem-blés, il aplu à Son Excellence la Gouverneuregénérale d’ordon-ner à la Chambre des communes d’êtreprésente, et, cette Cham-bre étantprésente, Son Excellence la Gouverneuregénérale, aunom de Sa Majesté, a sanctionné lesprojets de loi suivants :

An Act to support andpromote electronic commerce by pro-tecting personal information that is collected, used or dis-closed in certain circumstances, by providing for the use ofelectronic means to communicate or record information ortransactions and by amending the Canada Evidence Act, theStatutory Instruments Act and the Statute Revision Act(Bill C-6, Chapter 05/2000)

Loi visant à faciliter et àpromouvoir le commerce électroniqueen protégeant les renseignementspersonnels recueillis, utili-sés ou communiqués dans certaines circonstances, enpré-voyant l’utilisation de moyens électroniques pour commu-niquer ou enregistrer de l’information et des transactions eten modifiant la Loi sur lapreuve au Canada, la Loi sur lestextes réglementaires et la Loi sur la révision des lois(Projet de loi C-6, Chapitre 05/2000)

An Act to establish the Canadian Institutes of Health Research,to repeal the Medical Research Council Act and to makeconsequential amendments to other Acts(Bill C-13, Chapter 06/2000)

Loi portant création des Instituts de recherche en santé du Ca-nada, abrogeant la Loi sur le Conseil de recherches médi-cales et modifiant d’autres lois en conséquence(Projet de loi C-13, Chapitre 06/2000)

An Act to give effect to the Nisga’a Final Agreement(Bill C-9, Chapter 07/2000)

Loi portant mise en vigueur de l’Accord définitif nisga’a(Projet de loi C-9, Chapitre 07/2000)

PAUL C. BÉLISLEClerk of the Senate and

Clerk of the Parliaments

Le greffier du Sénat etgreffier des Parlements

PAUL C. BÉLISLE[18-1-o] [18-1-o]

Page 10: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

1340 Canada Gazette Part I April 29, 2000

COMMISSIONS COMMISSIONS

CANADIAN RADIO-TELEVISION ANDTELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DESTÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

NOTICE TO INTERESTED PARTIES AVIS AUX INTÉRESSÉS

The following notices are abridged versions of the Commis-sion’s original notices bearing the same number. The originalnotices contain a more detailed outline of the applications,including additional locations and addresses where the completefiles may be examined. The relevant material, including the no-tices and applications, is available for viewing during normalbusiness hours at the following offices of the Commission:— Central Building, Les Terrasses de la Chaudière, 1 Promenade

du Portage, Ground Floor, Hull, Quebec K1A 0N2, (819)997-2429 (Telephone), 994-0423 (TDD), (819) 994-0218(Facsimile);

— Bank of Commerce Building, Suite 1007, 1809 BarringtonStreet, Halifax, Nova Scotia B3J 3K8, (902) 426-7997(Telephone), 426-6997 (TDD), (902) 426-2721 (Facsimile);

— Kensington Building, Suite 1810, 275 Portage Avenue, Win-nipeg, Manitoba R3B 2B3, (204) 983-6306 (Telephone),983-8274 (TDD), (204) 983-6317 (Facsimile);

— 530–580 Hornby Street, Vancouver, British Columbia V6C3B6, (604) 666-2111 (Telephone), 666-0778 (TDD), (604)666-8322 (Facsimile);

— C.R.T.C. Documentation Centre, 405 De MaisonneuveBoulevard E, 2nd Floor, Suite B2300, Montréal, Quebec, H2L4J5, (514) 283-6607 (Telephone), 283-8316 (TDD), (514)283-3689 (Facsimile);

— C.R.T.C. Documentation Centre, 55 St. Clair Avenue E,Suite 624, Toronto, Ontario M4T 1M2, (416) 952-9096(Telephone), (416) 954-6343 (Facsimile);

— C.R.T.C. Documentation Centre, Cornwall ProfessionalBuilding, Room 103, 2125 11th Avenue, Regina, Saskatche-wan S4P 3X3, (306) 780-3422 (Telephone), (306) 780-3319(Facsimile);

— C.R.T.C. Documentation Centre, Scotia Place Tower Two,19th Floor, Suite 1909, 10060 Jasper Avenue, Edmonton, Al-berta T5J 3R8, (780) 495-3224 (Telephone), (780) 495-3214(Facsimile).

Les avisqui suivent sont des versions abrégées des avis origi-naux du Conseilportant le même numéro. Les avis originauxcontiennent une description plus détaillée de chacune desdemandes,y compris les lieux et adresses où l’onpeut consulterles dossiers complets. Tous les documents afférents,y compris lesavis et les demandes, sont disponibles pour examen durant lesheures normales d’affaires aux bureaux suivants du Conseil :— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, 1,promenade

du Portage, Rez-de-chaussée, Hull (Québec) K1A 0N2, (819)997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), (819) 994-0218(télécopieur);

— Édifice de la Banque de Commerce, Pièce 1007, 1809, rueBarrington, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8, (902)426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), (902) 426-2721(télécopieur);

— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winni-peg (Manitoba) R3B 2B3, (204) 983-6306 (téléphone),983-8274 (ATS), (204) 983-6317 (télécopieur);

— 530-580, rue Hornby, Vancouver (Colombie-Britannique)V6C 3B6, (604) 666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS),(604) 666-8322 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., 405, boulevard deMaisonneuve Est, 2e étage, Bureau B2300, Montréal (Québec)H2L 4J5, (514) 283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), (514)283-3689 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., 55, avenue St. ClairEst, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, (416) 952-9096 (téléphone), (416) 954-6343 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., Édifice Cornwall Pro-fessional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatche-wan) S4P 3X3, (306) 780-3422 (téléphone), (306) 780-3319(télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., Scotia Place TowerTwo, 19e étage, Bureau 1909, 10060, avenue Jasper, Edmon-ton (Alberta) T5J 3R8, (780) 495-3224 (téléphone), (780)495-3214 (télécopieur).

Interventions must be filed with the Secretary General, Cana-dian Radio-television and Telecommunications Commission,Ottawa, Ontario K1A 0N2, together withproof that a true copy ofthe intervention has been served upon the applicant, on or beforethe deadlinegiven in the notice.

Les interventions doiventparvenir au Secrétairegénéral, Con-seil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avecpreuvequ’une copie conformea été envoyée à la requérante, avant la date limite d’interventionmentionnée dans l’avis.

Secretary General Secrétaire général

CANADIAN RADIO-TELEVISION ANDTELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DESTÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DECISIONS DÉCISIONS

The complete texts of the decisions summarized below areavailable from the offices of the CRTC.

On peut seprocurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s’adressant au CRTC.

2000-102 April 17, 2000 2000-102 Le 17 avril 2000

Eternacom Inc.Sudbury, Ontario

Eternacom Inc.Sudbury (Ontario)

Approved — Broadcasting licence for a low-power English-language FM radioprogramming undertaking at Sudbury, expir-ing on August 31, 2006.

Approuvé — Licence de radiodiffusion visant l’exploitation, àSudbury, d’une entreprise deprogrammation de radio FM de fai-ble puissance de langue anglaise, expirant le 31 août 2006.

Page 11: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Le 29 avril 2000 Gazette du Canada Partie I 1341

2000-103 April 17, 2000 2000-103 Le 17 avril 2000

Roger de Brabant, on behalf of a company to beincorporatedTimmins, Ontario

Roger de Brabant, au nom d’une compagnie devant êtreincorporéeTimmins (Ontario)

Approved — Broadcasting licence for a low-power English-language FM radioprogramming undertaking at Timmins, expir-ing August 31, 2006.

Approuvé — Licence de radiodiffusion visant l’exploitation, àTimmins, d’une entreprise de programmation de radio FM defaible puissance de langue anglaise, expirant le 31 août 2006.

2000-104 April 17, 2000 2000-104 Le 17 avril 2000

CIRC Radio Inc.Toronto, Ontario

CIRC Radio Inc.Toronto (Ontario)

Approved — Increase in the effective radiatedpower for CIRV-FM Toronto from 1 000 watts to 1 800 watts.

Approuvé — Augmentation de lapuissance apparente rayonnéede CIRV-FM Toronto, de 1 000 watts à 1 800 watts.

[18-1-o] [18-1-o]

CANADIAN RADIO-TELEVISION ANDTELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DESTÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

PUBLIC HEARING 2000-3 AUDIENCE PUBLIQUE 2000-3

The Commission will hold apublic hearing commencing onJune 27, 2000, at 9 a.m. (Issue No. 1), at the Holiday Inn Select,99 Viger Avenue W, Montréal, Quebec, to consider thefollowing:

Le Conseil tiendra une audiencepublique àpartir du 27 juin2000, à 9 h (Premièrepartie), au Holiday Inn Select, 99, avenueViger Ouest, Montréal (Québec), afin d’étudier cequi suit :

1. Across CanadaAstral Television Networks Inc.

1. L’ensemble du CanadaAstral Télé Réseaux inc.

Acquisition of the assets of theprogramming undertaking(pay television) Super Écran currently held by Les ChaînesTélé Astral inc. The applicant is also requesting a broadcast-ing licence to continue the operation of this undertaking.

En vue d’acquérir l’actif de l’entreprise deprogrammation(télévisionpayante) Super Écranprésentement détenupar LesChaînes Télé Astral inc. Elle demande également une licencede radiodiffusion luipermettant depoursuivre l’exploitationde cette entreprise.

2. Across CanadaCanadian Broadcasting Corporation, Télé-Québec, BCEMédia inc., La Sept Arte and L’équipe Spectra

2. L’ensemble du CanadaSociété Radio-Canada, Télé-Québec, BCE Média inc., LaSept Arte et L’équipe Spectra

Broadcasting licence to carry on a French-language nationalprogramming undertaking (television specialty service) to bedistributed via satellite to broadcasting distribution undertak-ings. The service wouldprovideprogramming devoted to thearts and to culture and would be known as “Télé des arts.”

En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’ex-ploitation d’une entreprise nationale deprogrammation(service spécialisé de télévision) de langue française distribuépar satellite aux entreprises de distribution de radiodiffusion.Le service offrirait uneprogrammation consacrée aux arts età la culture et serait connu sous le nom « Télé des arts ».

3. Across CanadaCHUM Limited and Astral Média inc.

3. L’ensemble du CanadaCHUM Limitée et Astral Média inc.

Broadcasting licence to carry on a French-language nationalprogramming undertaking (television specialty service) to bedistributed via satellite to broadcasting distribution undertak-ings. The service wouldprovideprogramming devoted to thearts and to culture and would be known as “Rendez-vous desartistes.”

En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’ex-ploitation d’une entreprise nationale deprogrammation(service spécialisé de télévision) de langue française distribuépar satellite aux entreprises de distribution de radiodiffusion.Le service offrirait uneprogrammation consacrée aux arts età la culture et serait connu sous le nom « Rendez-vous desartistes ».

Atlantic and Quebec Region Région de l’Atlantique et du Québec

4. Halifax Regional Municipality (Halifax, Dartmouth, Bedfordand Sackville), Nova ScotiaMaritime TEL & TEL Limited (MTT)

4. Municipalité régionale de Halifax (Halifax, Dartmouth,Bedford et Sackville) [Nouvelle-Écosse]Maritime TEL & TEL Limited (MTT)

Broadcasting licence for a cable distribution undertakingin the Halifax regional municipality (Halifax, Dartmouth,Bedford and Sackville).

Demande une licence de radiodiffusion afin d’exploiter uneentreprise de distributionpar câble dans la municipalitérégionale de Halifax (Halifax, Dartmouth, Bedford etSackville).

5. Kennetcook, Nova ScotiaDewis Cable Incorporated

5. Kennetcook (Nouvelle-Écosse)Dewis Cable Incorporated

Page 12: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

1342 Canada Gazette Part I April 29, 2000

Acquisition of the assets of the radiocommunication distri-bution undertaking (subscription television) currently held byKennetcook CableVision Limited. The applicant is also re-questing a broadcasting licence to continue the operation ofthis undertaking.

La requérante désire acquérir l’actif de l’entreprise de distri-bution de radiocommunication (télévisionpar abonnement)présentement détenupar Kennetcook CableVision Limited.Elle demande également une licence de radiodiffusion luipermettant depoursuivre l’exploitation de cette entreprise.

6. Fredericton, New BrunswickJoy FM Network Inc.

6. Fredericton (Nouveau-Brunswick)Joy FM Network Inc.

Broadcasting licence to carry on an English-language FMradio programming undertaking at Fredericton. The newstation would operate on frequency 104.5 MHz (chan-nel 283LP) with an effective radiatedpower of 50 watts.

En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’ex-ploitation d’une entreprise deprogrammation de radio FM delangue anglaise à Fredericton. La nouvelle station serait ex-ploitée à la fréquence 104,5 MHz (canal 283FP) avec unepuissance apparente rayonnée de 50 watts.

7. Chicoutimi, QuebecRadiomutuel inc.

7. Chicoutimi (Québec)Radiomutuel inc.

To renew the broadcasting licence of the radioprogrammingundertaking CKRS Chicoutimi expiring August 31, 2000;and to replace the condition of licence concerning the indus-try’s code ongender portrayal by a suspensive condition,meaning that the application of the condition would be sus-pended, so long as the licensee remains a member ingoodstanding of the Canadian Broadcast Standards Council. Thelicensee also requests the removal of the condition of licencepresently in effect requiring the licensee to abide by the“Radiomutuel Policy on Content”; and of the Commission’sexpectation that Radiomutuel inform it as soon aspossible ofany legal action against CKRS or any judgment or out-of-court settlement resulting from legal action against CKRS orCKRS program hosts relating to on-air comments and thatRadiomutuelprovide a copy of the Radiomutuel Policy to theCKRSprogram hosts and to any person who requests it.

De renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise deprogrammation de radio CKRS Chicoutimiqui expire le31 août 2000; de remplacer la condition relative au code del’industrie sur la représentation non sexiste despersonnesparune condition suspensive, c’est-à-direque la condition nes’appliqueraitpas tant et aussi longtemps que la titulaire estmembre en règle du Conseil canadien des normes de la radio-télévision. La titulaire demande également le retrait de lacondition de licenceprésentement en vigueurqui exige que latitulaire respecte la « Politique de Radiomutuel en matière decontenu » et de l’attente du Conseilque Radiomutuell’informe dans lesplus brefs délais de toutepoursuite contreCKRS, ou toutjugement ou règlement hors cours résultantd’une poursuite contre CKRS ou les animateurs de CKRSportant sur despropos tenus en ondes etque Radiomutuelremette une copie de lapolitique de Radiomutuel aux anima-teurs de CKRS et à toutepersonnequi en fait la demande.

8. Grand-Remous and Quyon, QuebecTélécâble Blouin inc.

8. Grand-Remous et Quyon (Québec)Télécâble Blouin inc.

The applicant wishes to acquire the assets of the cable distri-bution undertakings serving the above-mentioned localities.

En vue d’acquérir les actifs des entreprises de distributionparcâble desservant les localités susmentionnées.

9. Katinniq (Raglan Mine), QuebecMaryann Van Walleghem

9. Katinniq (Mine Raglan) [Québec]Maryann Van Walleghem

For a broadcasting licence to carry on a radiocommunicationdistribution undertaking at Katinniq (Raglan Mine), to dis-tribute in non-encrypted mode, using one radio transmitteroperating on frequency 88.5 MHz (channel 203) with an ef-fective radiatedpower of 100 watts, theprogramming ofCITE-FM Montréal, Quebec.

En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’ex-ploitation d’une entrepise de distribution de radiocommuni-cation à Katinniq (Mine Raglan), afin de distribuer, sousforme non codée, en utilisant un émetteur radiophonique à lafréquence 88,5 MHz (canal 203) avec unepuissance appa-rente rayonnée de 100 watts, le service deprogrammation deCITE-FM Montréal (Québec).

10. La Pocatière and vicinity, QuebecVidéotron (RDL) ltée

10. La Pocatière et les environs (Québec)Vidéotron (RDL) ltée

To exclude from the authorized service area the areas ofSainte-Perpétue/Tourville, Saint-Damase-de-l’Islet and Saint-Cyrille-de-l’Islet.

Afin d’exclure de la zone de desserte autorisée les secteurs deSainte-Perpétue/Tourville, Saint-Damase-de-l’Islet et Saint-Cyrille-de-l’Islet.

11. Montréal, Rimouski and Québec, QuebecTQS inc.

11. Montréal, Rimouski, et Québec (Québec)TQS inc.

To renew the broadcasting licences of the televisionpro-gramming undertakings CFJP-TV Montréal and its transmit-ter CJPC-TV Rimouski, CFAP-TV Québec, as well as thelicence for the French-language television network expiringon August 31, 2001; to delete the condition of licence relatedto independentproduction expenditures, imposed in 1997, atthe time of the transfer of TQS to Quebecor; to amend itscommitment, taken at the time of the transfer, to always makesignificant use of the independentproduction sector to berelieved of the requirement of thepolicy on closed captioningrequiring that all local news and at least 90percent of the

Afin de renouveler les licences de radiodiffusion des entre-prises deprogrammation de télévision CFJP-TV Montréal etson émetteur CJPC-TV Rimouski, CFAP-TV Québec, ainsique celle du réseau de télévision de langue françaisequi ex-pirent le 31 août 2001; de supprimer la condition de licencereliée aux dépenses à laproduction indépendante, imposée en1997, au moment du transfert de TQS à Quebecor; de modi-fier son engagement,pris au moment du transfert, visant àtoujours utiliser laproduction indépendante de façon notable;d’être relevée de l’exigence de lapolitique sur le sous-titrageexigeant que toutes les nouvelles locales et au moins

Page 13: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Le 29 avril 2000 Gazette du Canada Partie I 1343

programming during a broadcasting day be closed captioned.The applicant proposes a level of closed captioning of30 percent the firstyear, with an increase to 75percent theseventhyear upon the development of the technology whichallows such a level and that it is financially viable.

90 p. 100 des émissions au cours de lajournée de radiodif-fusion soient sous-titrées. La requérantepropose un niveaude sous-titrage de 30 p. 100 la première année,jusqu’à75 p. 100 la septième année à conditionque la technologiesoit développée pour respecter ce niveau d’une façon finan-cièrement abordable.

12. Saint-Cyrille-de-l’Islet, QuebecVidéotron (RDL) ltée

12. Saint-Cyrille-de-l’Islet (Québec)Vidéotron (RDL) ltée

Broadcasting licence for a cable distribution undertaking inSaint-Cyrille-de-l’Islet.

Demande une licence de radiodiffusion afin d’exploiter uneentreprise de distributionpar câble à Saint-Cyrille-de-l’Islet.

13. Saint-Damase-de-l’Islet, QuebecVidéotron (RDL) ltée

13. Saint-Damase-de-l’Islet (Québec)Vidéotron (RDL) ltée

Broadcasting licence for a cable distribution undertaking inSaint-Damase-de-l’Islet.

Demande une licence de radiodiffusion afin d’exploiter uneentreprise de distributionpar câble à Saint-Damase-de-l’Islet.

14. Sainte-Perpétue/Tourville, QuebecVidéotron (RDL) ltée

14. Sainte-Perpétue/Tourville (Québec)Vidéotron (RDL) ltée

Broadcasting licence for a cable distribution undertaking inSainte-Perpétue/Tourville.

Demande une licence de radiodiffusion afin d’exploiter uneentreprise de distribution par câble à Sainte-Perpétue/Tourville.

15. Sainte-Marie-de-Beauce, Quebec9079-3670 Québec inc.

15. Sainte-Marie-de-Beauce (Québec)9079-3670 Québec inc.

Acquisition of the assets of the radioprogramming undertak-ing CHEQ-FM Sainte-Marie-de-Beauce. The applicant is alsorequesting a broadcasting licence to continue the operation ofthis undertaking, upon surrender of the current licence issuedto Gestion Overtime inc., under the same terms and condi-tions as the current licence.

En vue d’acquérir l’actif de l’entreprise deprogrammation deradio CHEQ-FM Sainte-Marie-de-Beauce. Elle demandeégalement une licence de radiodiffusion luipermettant depoursuivre l’exploitation de cette entreprise, à la rétrocessionde la licence actuelle émise à Gestion Overtime inc., selon lesmêmes conditionsque celles de la licence actuelle.

16. Windsor, QuebecCarrefourjeunesse emploi comté Johnson

16. Windsor (Québec)Carrefourjeunesse emploi comté Johnson

For a broadcasting licence to carry on a French-languageFM (type B) community radio programming undertakingat Windsor. The new station would operate on frequency92.9 MHz (channel 225LP) with an effective radiatedpowerof 35 watts.

En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’ex-ploitation d’une entreprise deprogrammation de radio com-munautaire FM (type B) de langue française à Windsor. Lanouvelle station serait exploitée à la fréquence 92,9 MHz(canal 225FP) avec unepuissance apparente rayonnée de35 watts.

Western Canada and Territories Region Région de l’Ouest du Canada et Territoires

17. Cypress Hills Provincial Park, SaskatchewanBrad Mason, Saskatchewan Environment and ResourceManagement

17. Parcprovincial Cypress Hills (Saskatchewan)Brad Masson, Saskatchewan Environment and ResourceManagement

To carry on an English-language low-power FM radiopro-gramming undertaking at Cypress Hills Provincial Park. Thenew station would operate on frequency 103.7 MHz (chan-nel 279LP) with an effective radiatedpower of 47 watts.

En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’ex-ploitation d’une entreprise deprogrammation de radio FM defaible puissance de langue anglaise auparc provincial Cy-press Hills. La nouvelle station serait exploitée à la fréquence103,7 MHz (canal 279FP) avec unepuissance apparenterayonnée de 47 watts.

18. Junction of the Trans-Canada Highway and Highway 21,SaskatchewanBrad Mason, Saskatchewan Environment and ResourceManagement

18. Jonction de la route transcanadienne et de la route 21(Saskatchewan)Brad Mason, Saskatchewan Environment and ResourceManagement

For a broadcasting licence to carry on an English-languagelow-power FM radioprogramming undertaking at the junc-tion of the Trans-Canada Highway and Highway 21. Thenew station would operate on frequency 103.5 MHz (chan-nel 278 LP) with an effective radiatedpower of 39 watts.

En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’ex-ploitation d’une entreprise deprogrammation de radio FM defaible puissance de langue anglaise à lajonction de la routetranscanadienne et de la route 21. La nouvelle station seraitexploitée à la fréquence 103,5 MHz (canal 278FP) avec unepuissance apparente rayonnée de 39 watts.

19. Nelson, British ColumbiaKootenay Co-Operative Radio

19. Nelson (Colombie-Britannique)Kootenay Co-Operative Radio

For a broadcasting licence to carry on an English-languageFM community, type B radio programming undertaking atNelson. The new station would operate on frequency

En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’ex-ploitation d’une entreprise deprogrammation de radio FMcommunautaire de type B, de langue anglaise à Nelson. La

Page 14: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

1344 Canada Gazette Part I April 29, 2000

93.5 MHz (channel 228A1) with an effective radiatedpowerof 70 watts.

nouvelle station serait exploitée à la fréquence 93,5 MHz(canal 228A1) avec unepuissance apparente rayonnée de70 watts.

Deadline for intervention: June 5, 2000 Date limite d’intervention : le 5 juin 2000

April 19, 2000 Le 19 avril 2000[18-1-o] [18-1-o]

CANADIAN RADIO-TELEVISION ANDTELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DESTÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

PUBLIC HEARING 2000-4 AUDIENCE PUBLIQUE 2000-4

The Commission will hold apublic hearing commencing onJune 27, 2000, at 9 a.m. (Issue No. 1), at the Conference Centre,Portage IV, 140 Promenade du Portage, Hull, Quebec, to considerthe following:

Le Conseil tiendra une audiencepublique àpartir du 27 juin2000, à 9 h (Premièrepartie), au Centre de conférence, Por-tage IV, 140, promenade du Portage, Hull (Québec), afin d’étu-dier cequi suit :

Ontario Region Région de l’Ontario

1. Big Trout Lake, OntarioPetaykawin Development Corporation

1. Big Trout Lake (Ontario)Petaykawin Development Corporation

For a broadcasting licence for a cable distribution undertakingat Big Trout Lake.

Licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise dedistributionpar câble à Big Trout Lake.

2. Kaministiquia, OntarioJoel Virtanen, on behalf of Northwest Broadcasting,a company to be incorporated

2. Kaministiquia (Ontario)Joel Virtanen, représentant Northwest Broadcasting,une société devant être constituée

For a broadcasting licence to carry on an English-languagelow-power FM radio programming undertaking at Kaminis-tiquia. The new station would operate on frequency104.5 MHz (channel 283LP) with an effective radiatedpowerof 50 watts.

En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’ex-ploitation d’une entreprise de programmation de radio FMde faible puissance de langue anglaise à Kaministiquia. Lanouvelle station serait exploitée à la fréquence 104,5 MHz(canal 283FP) avec unepuissance apparente rayonnée de50 watts.

3. Kapuskasing, OntarioAngela Demers, on behalf of AD Communications, a companyto be incorporated

3. Kapuskasing (Ontario)Angela Demers, représentant AD Communications,une société devant être constituée

For a broadcasting licence to carry on an English-languagelow-power FM radio programming undertaking at Kapuska-sing. The new station would operate on frequency 94.1 MHz(channel 231LP) with an effective radiatedpower of 50 watts.

En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’ex-ploitation d’une entreprise de programmation de radio FMde faible puissance de langue anglaise à Kapuskasing. Lanouvelle station serait exploitée à la fréquence 94,1 MHz(canal 231FP) avec unepuissance apparente rayonnée de50 watts.

4. London, Ottawa and Toronto, OntarioRogers Broadcasting Limited (“RBL”)

4. London, Ottawa et Toronto (Ontario)Rogers Broadcasting Limited (« RBL »)

To renew the broadcasting licence of the televisionprogram-ming undertaking CFMT-TV Toronto and its transmittersCFMT-TV-1 London and CFMT-TV-2 Ottawa expiringAugust 31, 2000; and to amend the broadcasting licence asmentioned in the notice ofpublic hearing.

En vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’en-treprise deprogrammation de télévision CFMT-TV Toronto etses émetteurs CFMT-TV-1 London et CFMT-TV-2 Ottawaquiexpire le 31 août 2000; et de modifier la licence de radio-diffusion, tel qu’il est mentionné dans l’avis d’audiencepublique.

5. Parry Sound, OntarioPlayland Broadcasting Limited

5. Parry Sound (Ontario)Playland Broadcasting Limited

To renew the broadcasting licence for the radioprogrammingundertaking CKLP-FM Parry Sound expiring August 31, 2000.

En vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’en-treprise deprogrammation de radio CKLP-FM Parry Sound,qui expire le 31 août 2000.

6. Red Lake, OntarioJR Radio

6. Red Lake (Ontario)JR Radio

For a broadcasting licence to carry on an English-language FMradio programming undertaking at Red Lake. The new stationwould operate on frequency 95.1 MHz (channel 236LP) withan effective radiatedpower of 50 watts.

En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’ex-ploitation d’une entreprise deprogrammation de radio FM delangue anglaise à Red Lake. La nouvelle station serait exploi-tée à la fréquence 95,1 MHz (canal 236FP) avec unepuissanceapparente rayonnée de 50 watts.

Page 15: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Le 29 avril 2000 Gazette du Canada Partie I 1345

7. Timmins, OntarioAngela Demers, on behalf of AD Communications, a companyto be incorporated

7. Timmins (Ontario)Angela Demers, représentant AD Communications,une société devant être constituée

For a broadcasting licence to carry on an English-languagelow-power FM radio programming undertaking at Timmins.The new station would operate on frequency 95.1 MHz(channel 236LP) with an effective radiatedpower of 32 watts.

En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’ex-ploitation d’une entreprise deprogrammation de radio FM defaible puissance de langue anglaise à Timmins. La nouvellestation serait exploitée à la fréquence 95,1 MHz (canal 236FP)avec unepuissance apparente rayonnée de 32 watts.

Deadline for intervention: June 5, 2000 Date limite d’intervention : le 5 juin 2000

April 19, 2000 Le 19 avril 2000[18-1-o] [18-1-o]

CANADIAN RADIO-TELEVISION ANDTELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DESTÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

PUBLIC NOTICE 2000-55 AVIS PUBLIC 2000-55

Affinit y Radio Group Inc. on behalf of Blackburn GroupIncorporatedLeamington, Sarnia, Wingham and Centreville, Ontario

Affinit y Radio Group Inc. au nom de Blackburn GroupIncorporatedLeamington, Sarnia, Wingham et Centreville (Ontario)

Change to the effective control of Blackburn Radio Inc. andSarnia Broadcasters (1993) Ltd., through the transfer of all of theissued and outstanding shares held by Blackburn Group Incor-porated, a wholly-owned subsidiary of Blackburn Radio Inc. andSarnia Broadcasters (1993) Ltd. being transferred to RadiontInc. Affinit y Radio Group Inc. is a wholly-owned subsidiary ofRadiont Inc. The said Radiont Inc. will also, indirectly, acquirethe 23.08percent interest that Blackburn Radio Inc. holds in Bea-Ver Communications Inc. The affected radio stations are CHYR-FM in Leamington, CFGX-FM, CHKS-FM and CHOK in Sarnia,as well as CKNX and CKNX-FM in Wingham and the transmitterCKNX-FM-2 in Centreville.

Changement du contrôle effectif de Blackburn Radio Inc. etSarnia Broadcasters (1993) Ltd.,par le transfert de toutes les ac-tions émises et en circulation détenuespar Blackburn Group In-corporated, une filiale àpart entière de Blackburn Radio Inc. etSarnia Broadcasters (1993) Ltd., à Radiont Inc. Affinity RadioGroup Inc. est une filiale àpart entière de Radiont Inc. La sociétéRadiont Inc. acquerra aussi, indirectement, lapart de 23,08p. 100que détient Blackburn Radio Inc. dans Bea-Ver CommunicationsInc. Les stations de radio touchées sont CHYR-FM à Leamington,CFGX-FM, CHKS-FM et CHOK à Sarnia, ainsique CKNX etCKNX-FM à Wingham et l’émetteur CKNX-FM-2 à Centreville.

April 17, 2000 Le 17 avril 2000[18-1-o] [18-1-o]

CANADIAN RADIO-TELEVISION ANDTELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DESTÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

PUBLIC NOTICE 2000-56 AVIS PUBLIC 2000-56

Atlantic and Quebec Region Région de l’Atlantique et du Québec

1. Frederiction, New BrunswickTelemedia Radio Atlantic Inc.

1. Fredericton (Nouveau-Brunswick)Telemedia Radio Atlantic Inc.

To amend the broadcasting licence of radio station CKHJ-FM Fredericton, by decreasing the effective radiatedpowerfrom 100 000 to 78 000 watts.

En vue de modifier la licence de radiodiffusion de la stationde radio CKHJ-FM Fredericton, de manière à diminuer lapuissance apparente rayonnée de 100 000 à 78 000 watts.

2. Grand Falls, New BrunswickTelemedia Radio Atlantic Inc.

2. Grand-Sault (Nouveau-Brunswick)Telemedia Radio Atlantic Inc.

To add a transmitter at Plaster Rock by using the presentlyapproved facilities of its CJCJ Woodstock transmitter CJCJ-2. Telemedia has filed a separate application to delete CJCJ-2 from the Woodstock station’s licence.

En vue d’ajouter un émetteur à Plaster Rock, en utilisant lesinstallations approuvéespour l’émetteur de CJCJ Woods-tock, CJCJ-2. Telemedia a déposé une demande distincteafin de supprimer CJCJ-2 de la licence de la station deWoodstock.

3. Woodstock, New BrunswickTelemedia Radio Atlantic Inc.

3. Woodstock (Nouveau-Brunswick)Telemedia Radio Atlantic Inc.

To cease broadcasting the signal of CJCJ from the transmit-ters CJCJ-1 Perth/Andover and CJCJ-2 Plaster Rock. The li-censee has stated that Perth/Andover is served by CIKX-FM,a Telemedia station in Grand Falls. Telemedia has also filed

En vue de cesser de distribuer le signal de CJCJ àpartir desémetteurs CJCJ-1 Perth/Andover et CJCJ-2 Plaster Rock.La titulaire a indiqué que Perth/Andover est desserviepar CIKX-FM, une station de Telemedia à Grand-Sault.

Page 16: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

1346 Canada Gazette Part I April 29, 2000

an application to use the facilities at Plaster Rock to re-broadcast the signal of CIKX-FM in the Plaster Rock area.

Telemedia a également déposé une demande afin d’utiliserles installations à Plaster Rock afin de retransmettre le signalde CIKX-FM dans la région de Plaster Rock.

Ontario Region Région de l’Ontario

4. Hamilton, OntarioCFMU Radio Incorporated

4. Hamilton (Ontario)CFMU Radio Incorporated

To amend the broadcasting licence of radio station CFMU-FM Hamilton, by decreasing the effective radiatedpowerfrom 250 to 166 watts.

En vue de modifier la licence de radiodiffusion de la stationCFMU-FM Hamilton, de manière à diminuer lapuissanceapparente rayonnée de 250 à 166 watts.

5. North Bay, Ontario1158556 Ontario Ltd.

5. North Bay (Ontario)1158556 Ontario Ltd.

To add a lowpower FM radio transmitter at North Bay to of-fer the programming of CHIM-FM Timmins, a Christianmusic service.

En vue d’ajouter un émetteur de radio FM de faiblepuis-sance à North Bay afin d’offrir les émissions de CHIM-FMTimmins, un service de musique chrétienne.

Western Canada and Territories Region Région de l’Ouest du Canada et Territoires

6. Edmonton (part of) and area, AlbertaShaw Cablesystems Company

6. Edmonton (secteur de) et la région (Alberta)Shaw Cablesystems Company

To temporarily amend the broadcasting licence of the cabledistribution undertaking serving part of Edmonton and area,during the Children’s Miracle Network Telethon.

En vue de modifier temporairement la licence de radiodiffu-sion de l’entreprise de distributionpar câble desservant unsecteur d’Edmonton et la région, pendant le Children’s Mi-racle Network Telethon.

7. Edmonton (part of) and area, AlbertaVideon Cablesystems Alberta Inc.

7. Edmonton (secteur de) et la région (Alberta)Videon Cablesystems Alberta Inc.

To temporarily amend the broadcasting licence of the cabledistribution undertaking serving part of Edmonton and area,during the Children’s Miracle Network Telethon.

En vue de modifier temporairement la licence de radiodiffu-sion de l’entreprise de distributionpar câble desservant unsecteur d’Edmonton et la région, pendant le Children’s Mi-racle Network Telethon.

8. Red Deer, Alberta1158556 Ontario Ltd.

8. Red Deer (Alberta)1158556 Ontario Ltd.

To add a lowpower FM radio transmitter at Red Deer to of-fer the programming of CHIM-FM Timmins, Ontario, aChristian music service.

En vue d’ajouter un émetteur de radio FM de faiblepuis-sance à Red Deer afin d’offrir les émissions de CHIM-FMTimmins (Ontario), un service de musique chrétienne.

9. Red Deer, AlbertaShaw Cablesystems Company

9. Red Deer (Alberta)Shaw Cablesystems Company

To temporarily amend the broadcasting licence of the cabledistribution undertaking serving Red Deer, during the Chil-dren’s Miracle Network Telethon.

En vue de modifier temporairement la licence de radiodiffu-sion de l’entreprise de distributionpar câble desservant RedDeer,pendant le Children’s Miracle Network Telethon.

10. Whistler, British ColumbiaWIC Radio Ltd.

10. Whistler (Colombie-Britannique)WIC Radio Ltd.

To add a lowpower FM transmitter at Whistler, to offer theprogramming of CFMI-FM Vancouver.

En vue d’ajouter un émetteur de radio FM de faiblepuis-sance à Whistler, afin d’offrir les émissions de CFMI-FMVancouver.

Deadline for intervention: May 23, 2000 Date limite d’intervention : le 23 mai 2000

April 18, 2000 Le 18 avril 2000[18-1-o] [18-1-o]

NAFTA SECRETARIAT SECRÉTARIAT DE L’ALÉNA

DECISION DÉCISION

Solder Joint Pressure Pipe Fittings and Solder Joint Drainage,Waste and Vent Pipe Fittings

Raccords de tuyauterie à souder de types à pression et àdrainage, renvoi et évent

Notice is hereby given, pursuant to rule 70 of theNAFTA Arti-cle 1904 Panel Rules, that thepanel established to review thefinal determination made by the Canadian International TradeTribunal, respecting certain solderjoint pressurepipe fittings andsolderjoint drainage, waste and ventpipe fittings, made of cast

Avis est donnépar les présentes, conformément auparagra-phe 70 desRègles des groupes spéciaux (article 1904 — ALÉ-NA), que legroupe spécial chargé de réviser la décision définitivedu Tribunal canadien du commerce extérieur, au sujet de certainsraccords de tuyauterie à souder, de types àpression et à drainage,

Page 17: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Le 29 avril 2000 Gazette du Canada Partie I 1347

copper alloy, wrought copper alloy or wrought copper, originat-ing in or exported from the United States of America andpro-duced by or on behalf of Elkhart Products Corporation, Elkhart,Indiana, Nibco Inc., Elkhart, Indiana, and Mueller Industries, Inc.,Wichita, Kansas, their successors and assigns, issued its decisionon April 3, 2000 (Secretariat File No. CDA-USA-98-1904-03).

renvoi et évent, faits en alliages de cuivre coulé, en alliages decuivre ouvré ou en cuivre ouvré, originaires ou exportés desÉtats-Unis d’Amérique etproduitspar les sociétés Elkhart Prod-ucts Corporation, d’Elkhart (Indiana), Nibco Inc., d’Elkhart(Indiana), et Mueller Industries, Inc., de Wichita (Kansas), leurssuccesseurs et ayants droit, ou en leur nom, a rendu sa décision le3 avril 2000 (dossier du Secrétariat no CDA-USA-98-1904-03).

In the April 3, 2000 decision, the binationalpanel affirmed theinvestigating authority’s determination respecting certain solderjoint pressurepipe fittings and solderjoint drainage, waste andvent pipe fittings, made of cast copper alloy, wrought copperalloy or wrought copper, originating in or exported from theUnited States of America andproduced by or on behalf of ElkhartProducts Corporation, Elkhart, Indiana, Nibco Inc., Elkhart, Indi-ana, and Mueller Industries, Inc., Wichita, Kansas, their succes-sors and assigns.

Dans la décision du 3 avril 2000, legroupe spécial binational aconfirmé la décision de l’autorité chargée de l’enquête dans cer-tains raccords de tuyauterie à souder, de types àpression et àdrainage, renvoi et évent, faits en alliages de cuivre coulé, enalliages de cuivre ouvré ou en cuivre ouvré, originaires ou expor-tés desÉtats-Unis d’Amérique etproduitspar les sociétés ElkhartProducts Corporation, d’Elkhart (Indiana), Nibco Inc., d’Elkhart(Indiana), et Mueller Industries, Inc., de Wichita (Kansas), leurssuccesseurs et ayants droit, ou en leur nom.

Copies of the complete decision may be obtained from Cana-dian Government Publishing, Public Works and GovernmentServices Canada, Ottawa, Canada K1A 0S9, (819) 956-4802(Telephone), (819) 994-1498 (Facsimile).

On peut seprocurer des copies de la version intégrale de ladécision en s’adressant auxÉditions dugouvernement du Cana-da, Travauxpublics et Servicesgouvernementaux Canada, Otta-wa, Canada K1A 0S9, (819) 956-4802 (téléphone), (819) 994-1498 (télécopieur).

Explanatory Note Note explicative

Chapter 19 of the North American Free Trade Agreement es-tablishes aprocedure for replacing domesticjudicial review ofdeterminations in anti-dumping and countervailing duty casesinvolving imports from a NAFTA country with review by bina-tional panels.

Le chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américainsubstitue à l’examenjudiciaire national des décisions rendues enmatière de droits antidumping et compensateurs touchant lespro-duits importés du territoire d’unpays de l’ALÉNA, uneprocédurede révisionpar desgroupes spéciaux binationaux.

Thesepanels are established, when a Request for Panel Reviewis received by the NAFTA Secretariat, to act inplace of nationalcourts to expeditiously review final determinations to determinewhether they are in accordance with the anti-dumping or counter-vailing duty law of the country that made the determination.

De telsgroupes spéciaux sont formés lorsqu’une demande derévision par un groupe spécial est reçue au Secrétariat del’AL ÉNA. Ils tiennent lieu d’un tribunal national et examinent,dans les meilleurs délais, la décision définitive afin de déterminersi elle est conforme à la législation sur les droits antidumping oucompensateurs dupays où elle a été rendue.

Under Article 1904 of the North American Free Trade Agree-ment which came into force on January 1, 1994, the Governmentof Canada, the Government of the United States and the Govern-ment of Mexico established theRules of Procedure for Article1904 Binational Panel Reviews. These Rules werepublished intheCanada Gazette, Part I, on January 1, 1994.

Conformément à l’article 1904 de l’Accord de libre-échangenord-américain entré en vigueur le 1er janvier 1994, legouverne-ment du Canada, legouvernement desÉtats-Unis et legouverne-ment du Mexique ont établi lesRègles de procédure des groupesspéciaux binationaux formés en vertu de l’article 1904. Ces rè-gles ont étépubliées dans la Partie I de laGazette du Canada, le1er janvier 1994.

Requests for information concerning the present notice, orconcerning the NAFTA Article 1904 Panel Rules, should be ad-dressed to the Canadian Secretary, NAFTA Secretariat, CanadianSection, North American Free Trade Agreement, 90 SparksStreet, Suite 705, Ottawa, Ontario K1P 5B4, (613) 992-9388.

Toutes demandes de renseignements, concernant leprésent avisou les Règles des groupes spéciaux (article 1904 — ALÉNA),doivent être adressées au Secrétaire canadien, Secrétariat del’AL ÉNA, Section canadienne, Accord de libre-échange nord-américain, 90, rue Sparks, Pièce 705, Ottawa (Ontario) K1P 5B4,(613) 992-9388.

FRANÇOY RAYNAULDCanadian Secretary

Le secrétaire canadien

FRANÇOY RAYNAULD[18-1-o] [18-1-o]

Page 18: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

1348 Canada Gazette Part I April 29, 2000

MISCELLANEOUS NOTICES AVIS DIVERS

ASSOCIATES FINANCIAL LIFE INSURANCE COMPANY ASSOCIATES FINANCIAL LIFE INSURANCE COMPANY

APPLICATION FOR AN ORDER DEMANDE D’ORDONNANCE

Notice is hereby given, pursuant to theprovisions of sec-tion 580 of theInsurance Companies Act, S.C., 1991, c. 47, thatAssociates Financial Life Insurance Company (“Associates”), acompany with its head office in Irving, Texas, intends to make anapplication to the Superintendent of Financial Institutions for anorder approving the insuring in Canada of life risks.

Avis est par lesprésentes donné, en vertu des dispositions del’article 580 de laLoi sur les sociétés d’assurances, L.C. (1991),ch. 47, que la Associates Financial Life Insurance Company(la « Associates »), une compagnie dont le siège social est situé àIrving, au Texas, a l’intention deprésenter une demande d’ordon-nance au surintendant des institutions financières l’autorisant àoffrir de l’assurance-vie au Canada.

April 15, 2000 Le 15 avril 2000

ANTHONY MILESChief Agent

L’agent principalANTHONY MILES

[16-4-o] [16-4]

BRIAN KILLINS AND ELAINE KILLINS BRIAN KILLINS ET ELAINE KILLINS

PLANS DEPOSITED DÉPÔT DE PLANS

Brian Killins and Elaine Killins hereby give notice that an ap-plication has been made to the Minister of Fisheries and Oceansunder theNavigable Waters Protection Actfor approval of theplans and site of the work described herein. Under section 9 ofthe said Act, Brian Killins and Elaine Killins have deposited withthe Minister of Fisheries and Oceans, at Vancouver, British Co-lumbia, and in the office of the District Registrar of the LandRegistry District of Victoria, at 850 Burdett Avenue, Victoria,British Columbia, under deposit number EP020077, a descriptionof the site andplans of theproposed expansion of the existingoyster lease in the Lemmens Inlet fronting an unsurveyed fore-shore, 2 300 m east of District Lot 925, Clayoquot District, atapproximately 8 km north of Tofino.

Brian Killins et Elaine Killins donnent avis,par lesprésentes,qu’une demande a été déposée auprès du ministre des Pêches etdes Océans en vertu de laLoi sur la protection des eaux naviga-bles, pour l’approbation desplans et de l’emplacement de l’ou-vrage décrit ci-après. Brian Killins et Elaine Killins ont, en vertude l’article 9 de ladite loi, déposé auprès du ministre des Pêcheset des Océans, à Vancouver (Colombie-Britannique), et au bureaude lapublicité des droits du district d’enregistrement de Victoria,situé au 850, avenue Burdett, Victoria (Colombie-Britannique),sous le numéro de dépôt EP020077, une description del’emplacement et lesplans de l’agrandissement d’un bail huîtrieractuellement dans le bras de mer Lemmens, en face d’un estrannon levé, à 2 300 m à l’est du lot de district 925, district deClayoquot, à environ 8 km au nord de Tofino.

And take notice that theproject is presently being screenedpursuant to theCanadian Environmental Assessment Act.

Le projet faitprésentement l’objet d’un examenpréalable en con-formité avec laLoi canadienne sur l’évaluation environnementale.

Written objections based on the effect of the work on marinenavigation should be directed, not later than one month fromthe date ofpublication of this notice, to the Regional Director,Navigable Waters Protection Division, Operational Programs,Canadian Coast Guard, Department of Fisheries and Oceans,350–555 West Hastings Street, Vancouver, British ColumbiaV6B 5G3.

Toute objection aux répercussionsque les travauxpourraientavoir sur la navigation doit être adresséepar écrit, dans un délaid’un mois suivant la date depublication duprésent avis, au Direc-teur régional, Division de laprotection des eaux navigables, Pro-grammes opérationnels, Garde côtière canadienne, Ministère desPêches et des Océans, 555, rue Hastings Ouest, Bureau 350, Van-couver (Colombie-Britannique) V6B 5G3.

Tofino, April 16, 2000 Tofino, le 16 avril 2000

BRIAN KILLINS AND ELAINE KILLINS BRIAN KILLINS AND ELAINE KILLINS[18-1-o] [18-1-o]

CITY OF LONDON CITY OF LONDON

PLANS DEPOSITED DÉPÔT DE PLANS

The City of London hereby gives notice that an application hasbeen made to the Minister of Fisheries and Oceans under theNavigable Waters Protection Actfor approval of the plans andsite of the work described herein. Under section 9 of the said Act,the City of London has deposited with the Minister of Fisheriesand Oceans, and in the office of the District Registrar of the LandRegistry District of Middlesex No. 33, at 80 Dundas Street,Ground Floor, Unit J, London, Ontario N6A 6A7, under depositnumber 950713, a description of the site andplans of the

La City of London donne avis,par les présentes,qu’une de-mande a été déposée auprès du ministre des Pêches et des Océansen vertu de laLoi sur la protection des eaux navigables, pourl’approbation desplans et de l’emplacement de l’ouvrage décritci-après. La City of London a, en vertu de l’article 9 de ladite loi,déposé auprès du ministre des Pêches et des Océans, et au bureaude lapublicité des droits du district d’enregistrement de Middle-sex no 33, situé au 80, rue Dundas, Rez-de-chaussée, Pièce J,London (Ontario) N6A 6A7, sous le numéro de dépôt 950713,

Page 19: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Le 29 avril 2000 Gazette du Canada Partie I 1349

Springbank Park footbridge over the Thames River, in the City ofLondon, Ontario.

une description de l’emplacement et lesplans de lapasserelleSpringbank Park au-dessus de la rivière Thames, dans la ville deLondon (Ontario).

And take notice that theproject will be screenedpursuant totheCanadian Environmental Assessment Act.

Le projet fera l’objet d’un examenpréalable en conformitéavec laLoi canadienne sur l’évaluation environnementale.

Written objections based on the effect of the work on marinenavigation and on the environment should be directed, not laterthan one month from the date ofpublication of this notice, to theRegional Director, Canadian Coast Guard, Department of Fisher-ies and Oceans, 201 Front Street N, Suite 703, Sarnia, OntarioN7T 8B1.

Toute objection aux répercussionsque les travauxpourraientavoir sur la navigation maritime et sur l’environnement doit êtreadresséepar écrit, dans un délai d’un mois suivant la date depublication duprésent avis, au Directeur régional, Garde côtièrecanadienne, Ministère des Pêches et des Océans, 201, rue FrontNord, Bureau 703, Sarnia (Ontario) N7T 8B1.

London, April 17, 2000 London, le 17 avril 2000

J. W. JARDINECommissioner of Environmental Services

and City Engineer

Le commissaire aux services de l’environnementet l’ingénieur municipal

J. W. JARDINE[18-1-o] [18-1]

CLARENCE MICHAEL WOODS AND PATRICKDONALD KORESKI

CLARENCE MICHAEL WOODS ET PATRICK DONALDKORESKI

PLANS DEPOSITED DÉPÔT DE PLANS

Clarence Michael Woods and Patrick Donald Koreski herebygive notice that an application has been made to the Minister ofFisheries and Oceans under theNavigable Waters Protection Actfor approval of theplans and site of the work described herein.Under section 9 of the said Act, Clarence Michael Woods andPatrick Donald Koreski have deposited with the Minister of Fish-eries and Oceans, at Vancouver, British Columbia, and in theoffice of the District Registrar of the Land Registry District ofClayoquot, at Victoria, British Columbia, under deposit num-ber EP024624, a description of the site andplans of expansion ofan oyster farm on the north side of a small cove located on thewest side of Lemmens Inlet, on unsurveyed Crown land, 7 kmnorth of Tofino.

Clarence Michael Woods et Patrick Donald Koreski donnentavis, par lesprésentes,qu’une demande a été déposée auprès duministre des Pêches et des Océans en vertu de laLoi sur la pro-tection des eaux navigables, pour l’approbation desplans et del’emplacement de l’ouvrage décrit ci-après. Clarence MichaelWoods et Patrick Donald Koreski ont, en vertu de l’article 9 deladite loi, déposé auprès du ministre des Pêches et des Océans, àVancouver (Colombie-Britannique), et au bureau de lapublicitédes droits du district d’enregistrement de Clayoquot, à Victoria(Colombie-Britannique), sous le numéro de dépôt EP024624, unedescription de l’emplacement et lesplans d’agrandissement d’unparc à huîtres installé du côté nord d’unepetite anse, côté ouestdu bras de mer Lemmens, sur des terrespubliques non cadastrées,à 7 km au nord de Tofino.

And take notice that theproject is presently being screenedpursuant to theCanadian Environmental Assessment Act.

Le projet faitprésentement l’objet d’un examenpréalable en con-formité avec laLoi canadienne sur l’évaluation environnementale.

Written objections based on the effect of the work on marinenavigation should be directed, not later than one month from thedate of publication of this notice, to the Regional Director,Canadian Coast Guard, Department of Fisheries and Oceans,350–555 West Hastings Street, Vancouver, British ColumbiaV6B 5G3.

Toute objection aux répercussionsque les travauxpourraientavoir sur la navigation maritime doit être adresséepar écrit, dansun délai d’un mois suivant la date depublication duprésent avis,au Directeur régional, Garde côtière canadienne, Ministère desPêches et des Océans, 555, rue Hastings Ouest, Bureau 350, Van-couver (Colombie-Britannique) V6B 5G3.

Tofino, April 17, 2000 Tofino, le 17 avril 2000

CLARENCE MICHAEL WOODS ANDPATRICK DONALD KORESKI

CLARENCE MICHAEL WOODS ETPATRICK DONALD KORESKI

[18-1-o] [18-1]

COMMERCIAL TRAVELERS MUTUAL INSURANCECOMPANY

COMPAGNIE MUTUELLE D’ASSURANCESCOMMERCIAL TRAVELERS

RELEASE OF ASSETS LIBÉRATION D’ACTIF

Notice is hereby given, pursuant to sections 651 and 652 of theInsurance Companies Act, that Commercial Travelers MutualInsurance Company, having ceased to carry on business in Can-ada, and having transferred all of its insurancepolicies issued inCanada to Toronto Mutual Life Insurance Company, will apply tothe Superintendent of Financial Institutions on or after June 12,2000, for the release of its assets in Canada.

Avis est par les présentes donné, conformément aux arti-cles 651 et 652 de laLoi sur les sociétés d’assurances, que laCompagnie Mutuelle D’Assurances Commercial Travelers, ayantcessé d’exercer ses activités commerciales au Canada, et ayanttransféré toutes sespolices d’assurance émises au Canada à laToronto Mutual Life Insurance Company, demandera au surin-tendant des institutions financières, le 12juin 2000 ou après cettedate, la libération de son actif au Canada.

Page 20: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

1350 Canada Gazette Part I April 29, 2000

Any policyholders in Canada opposing such release should filetheir opposition with the Superintendent of Financial Institutions,255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2, on or beforeJune 12, 2000.

Tout titulaire depolice au Canada s’opposant à ce transfert doitdéposer son opposition auprès du Surintendant des institutionsfinancières, 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2, auplustard le 12juin 2000.

April 29, 2000 Le 29 avril 2000

WILLIAM JORGENSChief Agent in Canada

L’agent principal au Canada

WILLIAM JORGENS[18-4-o] [18-4-o]

CORNER BROOK PULP AND PAPER LIMITED CORNER BROOK PULP AND PAPER LIMITED

PLANS DEPOSITED DÉPÔT DE PLANS

Corner Brook Pulp and Paper Limited hereby gives notice thatan application has been made to the Minister of Fisheries andOceans under theNavigable Waters Protection Actfor approvalof the plans and site of the work described herein. Under sec-tion 9 of the said Act, Corner Brook Pulp and Paper Limited hasdeposited with the Minister of Fisheries and Oceans and in theGovernment Service Centre of the Electoral District of Humber—St. Barbe at Corner Brook, Newfoundland, and also in the De-velopment Office of the Electoral District of Humber—St. Barbeat Pollards Point, Newfoundland, a description of the site andplans of the existing bridge over the Main River, northwest of thecommunity of Sop’s Arm, Newfoundland, located at latitude49°47′50″ and longitude 57°04′45″.

La société Corner Brook Pulp and Paper Limited donne avis,par lesprésentes,qu’une demande a été déposée auprès du minis-tre des Pêches et des Océans en vertu de laLoi sur la protectiondes eaux navigables, pour l’approbation desplans et de l’em-placement de l’ouvrage décrit ci-après. La Corner Brook Pulp andPaper Limited a, en vertu de l’article 9 de ladite loi, déposé au-près du ministre des Pêches et des Océans, au Centre des servicesgouvernementaux de la circonscription électorale de Humber—St. Barbe à Corner Brook (Terre-Neuve), et au Bureau du déve-loppement de la circonscription électorale de Humber—St. Barbeà Pollards Point (Terre-Neuve), une description de l’emplacementet lesplans dupont actuellement au-dessus de la rivière Main, aunord-ouest de la communauté de Sop’s Arm (Terre-Neuve), situéà 49°47′50″ de latitude et 57°04′45″ de longitude.

And take notice that theproject is presently being screenedpursuant to theCanadian Environmental Assessment Act.

Le projet faitprésentement l’objet d’un examenpréalable en con-formité avec laLoi canadienne sur l’évaluation environnementale.

Written objections based on the effect of the work on marinenavigation and on the environment as it relates to areas of federalresponsibility should be directed, not later than one month fromthe date ofpublication of this notice, to the Regional Director,Canadian Coast Guard, Department of Fisheries and Oceans, P.O.Box 5667, St. John’s, Newfoundland A1C 5X1.

Toute objection aux répercussionsque les travauxpourraientavoir sur la navigation maritime et sur l’environnement en cequia trait aux compétences fédérales doit être adresséepar écrit, dansun délai d’un mois suivant la date depublication duprésent avis,au Directeur régional, Garde côtière canadienne, Ministère desPêches et des Océans, Casepostale 5667, St. John’s (Terre-Neuve) A1C 5X1.

Corner Brook, April 18, 2000 Corner Brook, le 18 avril 2000

BARRY ELKINSRoads Technician

Le technicien des routes

BARRY ELKINS[18-1-o] [18-1-o]

CORTES ISLAND SHELLFISH GROWERSCO-OPERATIVE

CORTES ISLAND SHELLFISH GROWERSCO-OPERATIVE

PLANS DEPOSITED DÉPÔT DE PLANS

Cortes Island Shellfish Growers Co-operative hereby gives no-tice that an application has been made to the Minister of Fisheriesand Oceans under theNavigable Waters Protection Actfor ap-proval of theplans and site of the work described herein. Undersection 9 of the said Act, Cortes Island Shellfish Growers Co-operative has deposited with the Minister of Fisheries andOceans, at Vancouver, British Columbia, and in the office of theDistrict Registrar of the Land Registry District of Victoria, atVictoria, British Columbia, under deposit number EP026249, adescription of the site andplans of an off-bottom oyster culture inTalbot Cove, at Teakerne Arm, West Redonda Island, FileNo. 2406810.

La société Cortes Island Shellfish Growers Co-operative donneavis, par lesprésentes,qu’une demande a été déposée auprès duministre des Pêches et des Océans en vertu de laLoi sur la pro-tection des eaux navigables, pour l’approbation desplans et del’emplacement de l’ouvrage décrit ci-après. La Cortes IslandShellfish Growers Co-operative a, en vertu de l’article 9 de laditeloi, déposé auprès du ministre des Pêches et des Océans, àVancouver (Colombie-Britannique), et au bureau de lapublicitédes droits du district d’enregistrement de Victoria, à Victoria(Colombie-Britannique), sous le numéro de dépôt EP026249, unedescription de l’emplacement et lesplans d’une ostréiculture ensuspension dans l’anse Talbot, dans la baie Teakerne, à l’île WestRedonda, numéro de dossier 2406810.

And take notice that theproject is presently being screenedpursuant to theCanadian Environmental Assessment Act.

Le projet faitprésentement l’objet d’un examenpréalable en con-formité avec laLoi canadienne sur l’évaluation environnementale.

Page 21: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Le 29 avril 2000 Gazette du Canada Partie I 1351

Written objections based on the effect of the work on marinenavigation should be directed, not later than one month fromthe date ofpublication of this notice, to the Regional Director,Navigable Waters Protection Division, Operational Programs,Canadian Coast Guard, Department of Fisheries and Oceans,350–555 West Hastings Street, Vancouver, British ColumbiaV6B 5G3.

Toute objection aux répercussionsque les travauxpourraientavoir sur la navigation maritime doit être adresséepar écrit, dansun délai d’un mois suivant la date depublication duprésent avis,au Directeur régional, Division de laprotection des eaux navi-gables, Programmes opérationnels, Garde côtière canadienne,Ministère des Pêches et des Océans, 555, rue Hastings Ouest,Bureau 350, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3.

West Redonda Island, April 17, 2000 Île West Redonda, le 17 avril 2000

DELIA BECKERDirector

La directriceDELIA BECKER

[18-1-o] [18-1-o]

DJJ LEASING LTD. DJJ LEASING LTD.JOSEPH LEASING LTD. JOSEPH LEASING LTD.ECDC ENVIRONMENTAL, L.C. ECDC ENVIRONMENTAL, L.C.I&M RAIL LINK, L.L.C. I&M RAIL LINK, L.L.C.

DOCUMENTS DEPOSITED DÉPÔT DE DOCUMENTS

Notice is hereby given, pursuant to section 105 of theCanadaTransportation Act, that on April 5, 2000, copies of the followingdocuments were deposited in the Office of the Registrar Generalof Canada:

1. Railroad Equipment Lease by and between Joseph LeasingLtd. and ECDC Environmental, L.C. dated as of March 21,2000, relating to 50 2000 Trinity-built, 89 feet flatcars bearingreporting marks ECXX 20001–20050, inclusive;2. Railroad Equipment Lease among Joseph Leasing Ltd.(formerly DJJ Leasing Ltd.) and I&M Rail Link, L.L.C. datedas of March 16, 2000, relating to 100 2000 National Steel Car-built coil cars bearing reporting marks IMRL 70000–70099,inclusive and 50 2000 National Steel Car-built covered coilcars bearing reporting marks IMRL 70100–70149, inclusive;and3. Security Documents Supplement No. 2 dated April 3, 2000,to the Security Agreement dated as of December 29, 1999,between DJJ Leasing Ltd., as Borrower, and Firstar Bank,N.A., as Lender, and to the Assignment of Leases dated as ofDecem-ber 29, 1999, between such Borrower and such Lender, relatingto, among others, flatcars and coil cars bearing reportingmarks ECXX 20001–20025, inclusive, ECXX 20028–20030,inclusive, ECXX 20032–20033, inclusive, IMRL 70069 andIMRL 70100–70149, inclusive.

Avis estpar lesprésentes donné, conformément à l’article 105de la Loi sur les transports au Canada, que le 5 avril 2000 descopies des documents suivants ont été déposées au Bureau duregistrairegénéral du Canada :

1. Bail d’équipement ferroviairepar et entre la Joseph LeasingLtd. et la ECDC Environmental, L.C. en date du 21 mars 2000,ayant trait à 50 wagonsplats fabriquéspar la Trinity en 2000,mesurant 89pieds de long et portant les marques de wagonECXX 20001 à 20050, inclusivement;2. Bail d’équipement ferroviaire entre la Joseph Leasing Ltd.(anciennement la DJJ Leasing Ltd.) et la I&M Rail Link,L.L.C. en date du 16 mars 2000, ayant trait à 100 wagonspourtôle en rouleaux fabriquéspar la National Steel Car en 2000, etportant les marques de wagon IMRL 70000 à 70099, inclusi-vement et 50 wagons couvertspour tôle en rouleaux fabriquéspar la National Steel Car en 2000, etportant les marques dewagon IMRL 70100 à 70149, inclusivement;3. Deuxième supplément aux documents de sûreté en date du3 avril 2000, accompagnant l’accord de sûreté en date du29 décembre 1999 entre la DJJ Leasing Ltd., à titre d’em-prunteur, et la Firstar Bank, N.A., à titre deprêteur, et accom-pagnant aussi la cession des baux en date du 29 décembre 1999entre l’emprunteur et leprêteur ayant trait, entre autres, à deswagons plats et des wagons pour tôle en rouleauxportant lesmarques de wagons ECXX 20001 à 20025, inclusivement,ECXX 20028 à 20030, inclusivement, ECXX 20032 à 20033,inclusivement, IMRL 70069 et IMRL 70100 à 70149,inclusivement.

April 5, 2000 Le 5 avril 2000

FRASER MILNERSolicitors

Les conseillers juridiquesFRASER MILNER

[18-1-o] [18-1-o]

DONOHUE FOREST PRODUCTS INC. DONOHUE FOREST PRODUCTS INC.

PLANS DEPOSITED DÉPÔT DE PLANS

Donohue Forest Products Inc. hereby gives notice that an ap-plication has been made to the Minister of Fisheries and Oceansunder theNavigable Waters Protection Actfor approval of theplans and site of the work described herein. Under section 9 ofthe said Act, Donohue Forest Products Inc. has deposited with theMinister of Fisheries and Oceans, at Vancouver, British

La société Donohue Forest Products Inc. donne avis,par lesprésentes,qu’une demande a été déposée auprès du ministre desPêches et des Océans en vertu de laLoi sur la protection des eauxnavigables, pour l’approbation desplans et de l’emplacement del’ouvrage décrit ci-après. La Donohue Forest Products Inc. a, envertu de l’article 9 de ladite loi, déposé auprès du ministre des

Page 22: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

1352 Canada Gazette Part I April 29, 2000

Columbia, and in the office of the District Registrar of the LandRegistry District of Prince George, at Prince George, British Co-lumbia, under deposit number PP 012499, a description of thesite andplans of the McGraw Creek Bridge over the McGrawCreek, at kilometer 32+000 on the Russel Mainline.

Pêches et des Océans, à Vancouver (Colombie-Britannique), et aubureau de lapublicité des droits du district d’enregistrement dePrince George, à Prince George (Colombie-Britannique), sous lenuméro de dépôt PP 012499, une description de l’emplacement etlesplans dupont McGraw Creek au-dessus du ruisseau McGraw,au kilomètre 32+000 sur leprolongement Russel.

Written objections based on the effect of the work on marinenavigation and on the environment should be directed, not laterthan one month from the date ofpublication of this notice, tothe Regional Director, Navigable Waters Protection Division,Canadian Coast Guard, Department of Fisheries and Oceans,350–555 West Hastings Street, Vancouver, British ColumbiaV6B 5G3.

Toute objection aux répercussionsque les travauxpourraientavoir sur la navigation maritime et sur l’environnement doit êtreadresséepar écrit, dans un délai d’un mois suivant la date depublication duprésent avis, au Directeur régional, Division dela protection des eaux navigables, Garde côtière canadienne,Ministère des Pêches et des Océans, 555, rue Hastings Ouest,Bureau 350, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3.

Prince George, April 18, 2000 Prince George, le 18 avril 2000

ALLNORTH CONSULTANTS LIMITED

DARBY D. KREITZProfessional Engineer

ALLNORTH CONSULTANTS LIMITEDL’ingénieur

DARBY D. KREITZ[18-1-o] [18-1-o]

DONOHUE FOREST PRODUCTS INC. DONOHUE FOREST PRODUCTS INC.

PLANS DEPOSITED DÉPÔT DE PLANS

Donohue Forest Products Inc. hereby gives notice that an ap-plication has been made to the Minister of Fisheries and Oceansunder theNavigable Waters Protection Actfor approval of theplans and site of the work described herein. Under section 9 ofthe said Act, Donohue Forest Products Inc. has deposited with theMinister of Fisheries and Oceans, at Vancouver, British Colum-bia, and in the office of the District Registrar of the Land RegistryDistrict of Prince George, at Prince George, British Columbia,under deposit number PP 012498, a description of the site andplans of the Russel Creek Bridge over the Russel Creek, at kilo-meter 42+000 on the Russel Mainline.

La société Donohue Forest Products Inc. donne avis,par lesprésentes,qu’une demande a été déposée auprès du ministre desPêches et des Océans en vertu de laLoi sur la protection des eauxnavigables, pour l’approbation desplans et de l’emplacement del’ouvrage décrit ci-après. La Donohue Forest Products Inc. a, envertu de l’article 9 de ladite loi, déposé auprès du ministre desPêches et des Océans, à Vancouver (Colombie-Britannique), et aubureau de lapublicité des droits du district d’enregistrement dePrince George, à Prince George (Colombie-Britannique), sous lenuméro de dépôt PP 012498, une description de l’emplacement etles plans dupont Russel Creek au-dessus du ruisseau Russel, aukilomètre 42+000 sur leprolongement Russel.

Written objections based on the effect of the work on marinenavigation and on the environment should be directed, not laterthan one month from the date ofpublication of this notice, tothe Regional Director, Navigable Waters Protection Division,Canadian Coast Guard, Department of Fisheries and Oceans,350–555 West Hastings Street, Vancouver, British ColumbiaV6B 5G3.

Toute objection aux répercussionsque les travauxpourraientavoir sur la navigation maritime et sur l’environnement doit êtreadresséepar écrit, dans un délai d’un mois suivant la date depublication duprésent avis, au Directeur régional, Division dela protection des eaux navigables, Garde côtière canadienne,Ministère des Pêches et des Océans, 555, rue Hastings Ouest,Bureau 350, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3.

Prince George, April 18, 2000 Prince George, le 18 avril 2000

ALLNORTH CONSULTANTS LIMITED

DARBY D. KREITZProfessional Engineer

ALLNORTH CONSULTANTS LIMITEDL’ingénieur

DARBY D. KREITZ[18-1-o] [18-1-o]

DONOHUE FOREST PRODUCTS INC. DONOHUE FOREST PRODUCTS INC.

PLANS DEPOSITED DÉPÔT DE PLANS

Donohue Forest Products Inc. hereby gives notice that an ap-plication has been made to the Minister of Fisheries and Oceansunder theNavigable Waters Protection Actfor approval of theplans and site of the work described herein. Under section 9 ofthe said Act, Donohue Forest Products Inc. has deposited with theMinister of Fisheries and Oceans, at Vancouver, British Colum-bia, and in the office of the District Registrar of the Land RegistryDistrict of Prince George, at Prince George, British Columbia,under deposit number PP 012496, a description of the site and

La société Donohue Forest Products Inc. donne avis,par lesprésentes,qu’une demande a été déposée auprès du ministre desPêches et des Océans en vertu de laLoi sur la protection des eauxnavigables, pour l’approbation desplans et de l’emplacement del’ouvrage décrit ci-après. La Donohue Forest Products Inc. a, envertu de l’article 9 de ladite loi, déposé auprès du ministre desPêches et des Océans, à Vancouver (Colombie-Britannique), et aubureau de lapublicité des droits du district d’enregistrement dePrince George, à Prince George (Colombie-Britannique), sous le

Page 23: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Le 29 avril 2000 Gazette du Canada Partie I 1353

plans of the Stelkuz Creek Bridge over the Stelkuz Creek, atkilometer 5+600 on the Stelkuz Mainline.

numéro de dépôt PP 012496, une description de l’emplacement etlesplans dupont Stelkuz Creek au-dessus du ruisseau Stelkuz, aukilomètre 5+600 sur leprolongement Stelkuz.

Written objections based on the effect of the work on marinenavigation and on the environment should be directed, not laterthan one month from the date ofpublication of this notice, tothe Regional Director, Navigable Waters Protection Division,Canadian Coast Guard, Department of Fisheries and Oceans,350–555 West Hastings Street, Vancouver, British ColumbiaV6B 5G3.

Toute objection aux répercussionsque les travauxpourraientavoir sur la navigation maritime et sur l’environnement doit êtreadresséepar écrit, dans un délai d’un mois suivant la date depublication duprésent avis, au Directeur régional, Division dela protection des eaux navigables, Garde côtière canadienne,Ministère des Pêches et des Océans, 555, rue Hastings Ouest,Bureau 350, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3.

Prince George, April 18, 2000 Prince George, le 18 avril 2000

ALLNORTH CONSULTANTS LIMITED

DARBY D. KREITZProfessional Engineer

ALLNORTH CONSULTANTS LIMITEDL’ingénieur

DARBY K. KREITZ[18-1-o] [18-1-o]

DONOHUE FOREST PRODUCTS INC. DONOHUE FOREST PRODUCTS INC.

PLANS DEPOSITED DÉPÔT DE PLANS

Donohue Forest Products Inc. hereby gives notice that an ap-plication has been made to the Minister of Fisheries and Oceansunder theNavigable Waters Protection Actfor approval of theplans and site of the work described herein. Under section 9 ofthe said Act, Donohue Forest Products Inc. has deposited with theMinister of Fisheries and Oceans, at Vancouver, British Colum-bia, and in the office of the District Registrar of the Land RegistryDistrict of Prince George, at Prince George, British Columbia,under deposit number PP 012497, a description of the site andplans of the Tsaydiz Creek Bridge over the Tsaydiz Creek, atkilometer 15+000 on the Russel Forest Service Road.

La société Donohue Forest Products Inc. donne avis,par lesprésentes,qu’une demande a été déposée auprès du ministre desPêches et des Océans en vertu de laLoi sur la protection des eauxnavigables, pour l’approbation desplans et de l’emplacement del’ouvrage décrit ci-après. La Donohue Forest Products Inc. a, envertu de l’article 9 de ladite loi, déposé auprès du ministre desPêches et des Océans, à Vancouver (Colombie-Britannique), et aubureau de lapublicité des droits du district d’enregistrement dePrince George, à Prince George (Colombie-Britannique), sous lenuméro de dépôt PP 012497, une description de l’emplacement etles plans dupont Tsaydiz Creek au-dessus du ruisseau Tsaydiz,au kilomètre 15+000 sur le chemin de service forestier Russel.

Written objections based on the effect of the work on marinenavigation and on the environment should be directed, not laterthan one month from the date ofpublication of this notice, tothe Regional Director, Navigable Waters Protection Division,Canadian Coast Guard, Department of Fisheries and Oceans,350–555 West Hastings Street, Vancouver, British ColumbiaV6B 5G3.

Toute objection aux répercussionsque les travauxpourraientavoir sur la navigation maritime et sur l’environnement doit êtreadresséepar écrit, dans un délai d’un mois suivant la date depublication duprésent avis, au Directeur régional, Division dela protection des eaux navigables, Garde côtière canadienne,Ministère des Pêches et des Océans, 555, rue Hastings Ouest,Bureau 350, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3.

Prince George, April 18, 2000 Prince George, le 18 avril 2000

ALLNORTH CONSULTANTS LIMITED

DARBY D. KREITZProfessional Engineer

ALLNORTH CONSULTANTS LIMITEDL’ingénieur

DARBY D. KREITZ[18-1-o] [18-1-o]

THE FIRST CATHOLIC SLOVAK LADIESASSOCIATION OF THE UNITED STATES OF AMERICA

THE FIRST CATHOLIC SLOVAK LADIESASSOCIATION OF THE UNITED STATES OF AMERICA

RELEASE OF ASSETS LIBÉRATION D’ACTIF

Notice is hereby given, in accordance with sections 650, 651and 652 of theInsurance Companies Act, that The First CatholicSlovak Ladies Association of the United States of America, hav-ing ceased to carry on business in Canada, intends to apply to theSuperintendent of Financial Institutions for release of the Com-pany’s assets in Canada on or after June 5, 2000. The FirstCatholic Slovak Ladies Association of the United States ofAmerica has discharged orprovided for the discharge of all of itsobligations in Canada, including its liabilities under itspolicies inCanada.

Avis est par les présentes donné, conformément aux arti-cles 650, 651 et 652 de laLoi sur les sociétés d’assurances, queThe First Catholic Slovak Ladies Association of the United Statesof America, laquelle a cessé d’exercer des affaires au Canada, al’intention de demander au surintendant des institutions finan-cières, le 5juin 2000 ou après cette date, la libération de son actifau Canada. The First Catholic Slovak Ladies Association of theUnited States of America s’est acquittée ouprend des disposi-tions pour s’acquitter de toutes ses obligations au Canada,incluant ses obligations liées auxpolices au Canada.

Page 24: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

1354 Canada Gazette Part I April 29, 2000

Any policyholder who opposes such release of assets must filenotice of such opposition with the Superintendent of FinancialInstitutions, Ottawa, Ontario K1A 0H2, on or before June 5,2000.

Tout assuréqui s’oppose à cette libération doit enregistrer sonopposition auprès du Surintendant des institutions financières,Ottawa (Ontario) K1A 0H2, auplus tard le 5juin 2000.

April 15, 2000 Le 15 avril 2000

JOHN R. MILNESChief Agent for Canada

L’agent principal au CanadaJOHN R. MILNES

[17-4-o] [17-4-o]

FLEX LEASING II, LLC FLEX LEASING II, LLC

FLEX LEASING CORPORATION FLEX LEASING CORPORATION

DOCUMENTS DEPOSITED DÉPÔT DE DOCUMENTS

Notice is hereby given, pursuant to section 105 of theCanadaTransportation Act, that on April 10, 2000, the following docu-ments were deposited in the Office of the Registrar General ofCanada:

1. Memorandum of Partial Termination of Lease dated as ofApril 10, 2000, of the Lease dated as of August 7, 1998, andSchedule No. 1 dated as of August 7, 1998, between FlexLeasing II, LLC (“Flex”) as Successor Lessor by assignmentfrom Flex Leasing Corporation (“FLC”), and Phillips Petro-leum Company, as Lessee, only as to the railcars listed on An-nex A to the Memorandum of Partial Termination of Lease;2. Memorandum of Lease dated as of April 10, 2000, of theLease dated as of March 10, 2000, between Flex, as SuccessorLessor by assignment from FLC, and Variform Incorporated(“Variform”), as Lessee, covering the railcars listed on An-nex A to the Memorandum of Lease;3. Memorandum of Use Agreement dated as of April 10, 2000,of the Use Agreement dated as of March 3, 2000, betweenFlex, as Successor Lessor by assignment from FLC, and Vari-form, covering the railcars listed on Annex A to the Memoran-dum of Use;4. Memorandum of Use Agreement dated as of April 10, 2000,of the Use Agreement dated as of February 18, 2000, betweenFlex, as Successor Lessor by assignment from FLC, and Vari-form, covering the railcars listed on Annex A to the Memoran-dum of Use;5. Memorandum of Use Agreement dated as of April 10, 2000,of the Use Agreement dated as of February 7, 2000, betweenFlex, as Successor Lessor by assignment from FLC, and Vari-form, covering the railcars listed on Annex A to the Memoran-dum of Use; and6. Amendment and Supplement to the Memorandum of Se-curity Agreement — Chattel Mortgage dated as of April 10,2000, of the Memorandum of Security Agreement — ChattelMortgage dated as of August 31, 1999, between First SecurityBank, National Association, as Secured Party, and Flex, asBorrower.

Avis estpar lesprésentes donné, conformément à l’article 105de laLoi sur les transports au Canada, que le 10 avril 2000 lesdocuments suivants ont été déposés au Bureau du registraire gé-néral du Canada :

1. Résumé de résiliationpartielle du contrat de location datédu 10 avril 2000, du contrat de location daté du 7 août 1998 etde lapremière annexe datée du 7 août 1998, entre la Flex Leas-ing II, LLC (« Flex »), en qualité de bailleur remplaçant parcession la Flex Leasing Corporation (« FLC »), et la PhillipsPetroleum Company, en qualité depreneur à bail, des seulsautorails énumérés à l’annexe A du résumé de résiliationpar-tielle de contrat de location;2. Résumé du contrat location daté du 10 avril 2000, du con-trat de location daté du 10 mars 2000, entre la Flex, enqualitéde bailleur remplaçant par cession la FLC, et la Variform In-corporated (« Variform »), enqualité depreneur à bail, cou-vrant les autorails énumérés à l’annexe A du résumé du contratde location;3. Résumé de convention d’utilisation daté du 10 avril 2000,de la convention d’utilisation datée du 3 mars 2000, entre laFlex, enqualité de bailleur remplaçantpar cession la FLC, et laVariform, couvrant les autorails énumérés à l’annexe A du ré-sumé de convention d’utilisation;4. Résumé de convention d’utilisation daté du 10 avril 2000,de la convention d’utilisation datée du 18 février 2000, entre laFlex, enqualité de bailleur remplaçantpar cession la FLC, et laVariform, couvrant les autorails énumérés à l’annexe A du ré-sumé de convention d’utilisation;5. Résumé de convention d’utilisation daté du 10 avril 2000,de la convention d’utilisation datée du 7 février 2000, entre laFlex, enqualité de bailleur remplaçantpar cession la FLC, et laVariform, couvrant les autorails énumérés à l’annexe A du ré-sumé de convention d’utilisation;6. Modification et supplément au résumé de convention dega-rantie — hypothèque mobilière datés du 10 avril 2000, du ré-sumé de convention degarantie — hypothèque mobilière datédu 31 août 1999, entre la First Security Bank, National Asso-ciation, en qualité de partie garantie, et la Flex, enqualitéd’emprunteur.

April 10, 2000 Le 10 avril 2000

HEENAN BLAIKIESolicitors

Les conseillers juridiques

HEENAN BLAIKIE[18-1-o] [18-1-o]

Page 25: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Le 29 avril 2000 Gazette du Canada Partie I 1355

GE GLOBAL INSURANCE HOLDING CORPORATION GE GLOBAL INSURANCE HOLDING CORPORATION

LETTERS PATENT LETTRES PATENTES

Notice is hereby given, pursuant to theprovisions of section 25of the Insurance Companies Act, S.C., 1991, c. 47, that GEGlobal Insurance Holding Corporation (or a subsidiary of GEGlobal Insurance Holding Corporation) intends to file an applica-tion with the Minister of Finance (Canada) for letterspatent in-corporating GE Reassurance Company of Canada in English, andin French, GE Compagnie de Réassurance du Canada for thepur-pose of transacting the business of life insurance and accident andsickness insurance, limited to the business of reinsurance.

Avis est par lesprésentes donnéque la GE Global InsuranceHolding Corporation ou une filiale de la GE Global InsuranceHolding Corporation a l’intention deprésenter, aux termes del’article 25 de laLoi sur les sociétés d’assurances, L.C. (1991),ch. 47, au ministre des Finances (Canada), une demande de lettrespatentes constituant enpersonne morale GE Compagnie de Réas-surance du Canada, en français, et GE Reassurance Company ofCanada, en anglais, afin d’exercer des activités relatives àl’assurance-vie et à l’assurance accidents et maladie, limitées auxaffaires de réassurance.

Any person objecting to the proposed incorporation maysubmit an objection in writing to the Office of the Superintendentof Financial Institutions, 255 Albert Street, 15th Floor, Ottawa,Ontario K1A 0H2, on or before June 5, 2000.

Quiconque s’oppose auprojet de constitution enpersonne mo-rale peut soumettre une opposition par écrit au Bureau du surin-tendant des institutions financières, 255, rue Albert, 15e étage,Ottawa (Ontario) K1A 0H2, auplus tard le 5juin 2000.

Toronto, April 4, 2000 Toronto, le 4 avril 2000

GE GLOBAL INSURANCE HOLDING CORPORATION GE GLOBAL INSURANCE HOLDING CORPORATION[16-4-o] [16-4-o]

THE LAKE ERIE & DETROIT RIVER RAILWAYCOMPANY

THE LAKE ERIE & DETROIT RIVER RAILWAYCOMPANY

ANNUAL AND SPECIAL MEETING OF SHAREHOLDERS ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE ET ANNUELLE DESACTIONNAIRES

Notice is hereby given that the Annual and Special Meeting(“the “Meeting”) of the Shareholders of The Lake Erie & DetroitRailway Company (the “Corporation”) will be held at the headoffice of the Corporation at 100 Ouellette Avenue, Suite 1300,Windsor, Ontario, on June 25, 2000, at 11 a.m. (Eastern time), forthe following purpose :

1. To elect directors and othergeneralpurposes; and2. To consider and retroactively validate the sale on Febru-ary 15, 1991, by the Corporation to Canadian National Rail-ways or its nominee, certain tracks and real estate located inWindsor, Ontario, between mileposts 2.0 and 8.0 and atLeamington, Ontario, between mileposts 37.4 and 38.2, includ-ing various lead and spur tracks.

Avis estpar lesprésentes donné de l’assemblée extraordinaireet annuelle (l’assemblée) des actionnaires de The Lake Erie &Detroit River Railway Company (la compagnie) qui aura lieu ausiège social de la compagnie située au 100, avenue Ouellette, Bu-reau 1300, Windsor (Ontario), le 25juin 2000, à 11 h (heurenormale de l’Est),pour les raisons suivantes :

1. Élire les administrateurs et examiner d’autresquestionsd’ordregénéral;2. Étudier et valider rétroactivement la vente aux Chemins defer nationaux du Canada ou à ses mandataires, le 15 février1991,par la compagnie, de certaines voies ferrées etpropriétéssituées à Windsor, Ontario, entre les bornes 2.0 et 8.0 et àLeamington, Ontario, entre les bornes 37,4 et 38,2y comprisles diverses voies d’accès et embranchements.

PATRICIA AFTOORASecretary

La secrétairePATRICIA AFTOORA

[17-4-o] [17-4-o]

LOBLAW PROPERTIES LIMITED LOBLAW PROPERTIES LIMITED

PLANS DEPOSITED DÉPÔT DE PLANS

Loblaw Properties Limited hereby gives notice that an applica-tion has been made to the Minister of Fisheries and Oceans underthe Navigable Waters Protection Actfor approval of the plansand site of the work described herein. Under section 9 of the saidAct, Loblaw Properties Limited has deposited with the Ministerof Fisheries and Oceans, and in the office of the District Registrarof the Land Registry District of Halifax County, at 5151 TerminalRoad, 2nd Floor, Halifax, Nova Scotia, under deposit num-ber 3061, a description of the site andplans of aproposed vehicu-lar andpedestrian bridge over the Sackville River, at civic 1650Bedford Highway, at the intersection of the Bedford Highway andRocky Lake Drive, in Bedford, Nova Scotia.

La société Loblaw Properties Limited donne avis,par lespré-sentes,qu’une demande a été déposée auprès du ministre desPêches et des Océans en vertu de laLoi sur la protection des eauxnavigables, pour l’approbation desplans et de l’emplacement del’ouvrage décrit ci-après. La Loblaw Properties Limited a, envertu de l’article 9 de ladite loi, déposé auprès du ministre desPêches et des Océans, et au bureau de lapublicité des droits dudistrict d’enregistrement du comté de Halifax, situé au 5151, che-min Terminal, 2e étage, Halifax (Nouvelle-Écosse), sous le numé-ro de dépôt 3061, une description de l’emplacement et lesplansd’un pont-route et d’unepasserelleque l’on propose de construireau-dessus de la rivière Sackville, au niveau de la route municipale

Page 26: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

1356 Canada Gazette Part I April 29, 2000

1650 Bedford, à l’intersection de la route Bedford et de lapro-menade Rocky Lake, à Bedford (Nouvelle-Écosse).

Written objections based on the effect of the work on marinenavigation should be directed, not later than one month from thedate ofpublication of this notice, to the Regional Director, Ca-nadian Coast Guard, Department of Fisheries and Oceans, Foot ofParker Street, P.O. Box 1000, Dartmouth, Nova Scotia B2Y 3Z8.

Toute objection aux répercussionsque les travauxpourraientavoir sur la navigation maritime doit être adresséepar écrit, dansun délai d’un mois suivant la date depublication duprésent avis,au Directeur régional, Garde côtière canadienne, Ministère desPêches et des Océans, Rue Parker, Casepostale 1000, Dartmouth(Nouvelle-Écosse) B2Y 3Z8.

Bedford, April 18, 2000 Bedford, le 18 avril 2000

LOBLAW PROPERTIES LIMITED LOBLAW PROPERTIES LIMITED[18-1-o] [18-1]

NATIONAL CITY BANK NATIONAL CITY BANK

APPLICATION TO ESTABLISH A FOREIGN BANKBRANCH

DEMANDE D’ÉTABLISSEMENT D’UNE SUCCURSALE DEBANQUE ÉTRANGÈRE

Notice is hereby given, pursuant to subsection 525(2) of theBank Act, that National City Bank, a foreign bank located inCleveland, Ohio, U.S.A., intends to apply to the Minister ofFi-nance for an orderpermitting it to establish a foreign bank branchin Canada to carry on the business of banking. The principaloffice of the foreign bank branch will be located in Toronto,Ontario.

Avis estpar lesprésentes donné, en vertu duparagraphe 525(2)de laLoi sur les banques, que la National City Bank, une banqueétrangère ayant son siège social à Cleveland, Ohio,États-Unis, al’intention de demander au ministre des Finances une ordonnancel’autorisant à établir une succursale de banque étrangère au Cana-dapour y mener des activités bancaires. Le bureauprincipal de lasuccursale de la banque étrangère sera situé à Toronto (Ontario).

Any person who objects to theproposed order may submit anobjection in writing to the Office of the Superintendent of Finan-cial Institutions, 255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2, onor before June 20, 2000.

Toutepersonnequi s’oppose à une telle ordonnancepeut sou-mettre son opposition, par écrit, au Bureau du surintendant desinstitutions financières, 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A0H2, auplus tard le 20juin 2000.

Ohio, April 29, 2000 Ohio, le 29 avril 2000

NATIONAL CITY BAN K NATIONAL CITY BAN K[18-4-o] [18-4-o]

ORGANIZATION FOR THE SUPPORTOF VIETNAMESE REFUGEES

ŒUVRE DU SOUTIEN AUX RÉFUGIÉSVIETNAMIENS

SURRENDER OF CHARTER ABANDON DE CHARTE

Notice is hereby given that the ŒUVRE DU SOUTIEN AUXRÉFUGIÉS VIETNAMIENS/ORGANIZATION FOR THESUPPORT OF VIETNAMESE REFUGEES intends to apply tothe Minister of Industry for leave to surrender its charter,pursu-ant to theCanada Corporations Act.

Avis estpar lesprésentes donnéque l’ŒUVRE DU SOUTIENAUX RÉFUGIÉS VIETNAMIENS/ORGANIZATION FOR THESUPPORT OF VIETNAMESE REFUGEES demandera au minis-tre de l’Industrie lapermission d’abandonner sa charte en vertude laLoi sur les corporations canadiennes.

April 6, 2000 Le 6 avril 2000

DESJARDINS DUCHARME STEIN MONASTAttorneys to the Corporation

Les procureurs de la corporationDESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST

[18-1-o] [18-1-o]

PROCOR LIMITED PROCOR LIMITED

DOCUMENTS DEPOSITED DÉPÔT DE DOCUMENTS

Notice is hereby given, pursuant to section 105 of theCanadaTransportation Actthat on March 20, 2000, the following docu-ments were deposited in the Office of the Registrar General ofCanada:

1. Termination of Trust Agreement (Series CAN-5) dated as ofNovember 15, 1999, between Procor Limited and The RoyalTrust Company, as Trustee, terminating an Equipment TrustAgreement dated as of December 1, 1989; and

Avis estpar lesprésentes donné, conformément à l’article 105de laLoi sur les transports au Canada, que le 20 mars 2000 lesdocuments suivants ont été déposés au Bureau du registraire gé-néral du Canada :

1. Résiliation de la convention de fiducie (série CAN-5) endate du 15 novembre 1999 entre la Procor Limited et TheRoyal Trust Company, enqualité de fiduciaire, résiliant un ac-cord de nantissement de matériel en date du 1er décembre 1989;

Page 27: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Le 29 avril 2000 Gazette du Canada Partie I 1357

2. Bill of Sale (Series CAN-5) effective as of November 15,1999, from The Royal Trust Company, as Trustee, underEquipment Trust Agreement dated as of December 1, 1989,between Procor Limited and the Trustee, relating to 340 vari-ous railcars.

2. Contrat de vente (série CAN-5) entrant en vigueur le15 novembre 1999 de The Royal Trust Company, enqualité defiduciaire aux termes de l’accord de nantissement de matérielen date du 1er décembre 1989 entre la Procor Limited et lefiduciaire, concernant 340 wagons divers.

March 20, 2000 Le 20 mars 2000

OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLPBarristers and Solicitors

Les conseillers juridiques

OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP[18-1-o] [18-1-o]

RBC LIFE INSURANCE COMPANY COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE RBC

WESTBURY CANADIAN LIFE INSURANCE COMPANY WESTBURY CANADIENNE, COMPAGNIED’ASSURANCE VIE

LETTERS PATENT OF AMALGAMATION LETTRES PATENTES DE FUSION

Notice is hereby given, pursuant to theprovisions of subsec-tion 250(2) of theInsurance Companies Act(Canada), that RBCLife Insurance Company, having its head office at 55 City CentreDrive, Suite 1100, Mississauga, Ontario L5B 1M3, and WestburyCanadian Life Insurance Company, having its head office at21 King Street W, Suite 1100, Hamilton, Ontario L8N 3R5, in-tend to make ajoint application to the Minister of Finance on orafter May 9, 2000, for letterspatent of amalgamation continuingthem as one company under the name RBC Life Insurance Com-pany, and in French, Compagnie d’assurance vie RBC.

Avis est par les présentes donné, conformément auparagra-phe 250(2) de laLoi sur les sociétés d’assurances(Canada)quela Compagnie d’assurance vie RBC, dont le siège social est sis au55, promenade City Centre, Bureau 1100, Mississauga (Ontario)L5B 1M3, et la Westbury Canadienne, Compagnie d’AssuranceVie, dont le siège social est sis au 21, rue King Ouest, Bu-reau 1100, Hamilton (Ontario) L8N 3R5, entendent faire unedemande conjointe au ministre des Finances, le 9 mai 2000 ouaprès cette date,pour obtenir des lettrespatentes de fusion leurpermettant depoursuivre leurs activités en tantque compagnieunique sous le nom de Compagnie d’assurance vie RBC, et enanglais, RBC Life Insurance Company.

Mississauga, March 27, 2000 Mississauga, le 27 mars 2000

RBC LIFE INSURANCE COMPANY

WESTBURY CANADIAN LIFE INSURANCE COMPANY

COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE RBC

WESTBURY CANADIENNE, COMPAGNIED’ASSURANCE VIE

[15-4-o] [15-4-o]

SONYA’S MARIONNETTE THEATRE INC. THÉÂTRE DE MARIONNETTES SONYA INC.

SURRENDER OF CHARTER ABANDON DE CHARTE

Notice is hereby given that SONYA’S MARIONNETTETHEATRE INC. intends to apply to the Minister of Industry forleave to surrender its charter,pursuant to theCanada Corpora-tions Act.

Avis est par les présentes donnéque le THÉÂTRE DE MA-RIONNETTES SONYA INC. demandera au ministre de l’Indus-trie la permission d’abandonner sa charte en vertu de laLoi surles corporations canadiennes.

April 4, 2000 Le 4 avril 2000

NATHALIE GURALPresident

Le présidentNATHALIE GURAL

[18-1-o] [18-1-o]

ST. LAWRENCE ARTIFICIAL REEF ASSOCIATION ST. LAWRENCE ARTIFICIAL REEF ASSOCIATION

PLANS DEPOSITED DÉPÔT DE PLANS

The St. Lawrence Artificial Reef Association hereby gives no-tice that an application has been made to the Minister of Fisheriesand Oceans under theNavigable Waters Protection Actfor ap-proval of theplans and site of the work described herein. Undersection 9 of the said Act, the St. Lawrence Artificial Reef Asso-ciation has deposited with the Minister of Fisheries and Oceans,and in the NWP office for the county of Leeds and Grenville, atPrescott, Ontario, a description of the site andplans of an artifi-cial reef in the St. Lawrence River, at Brockville, south of the

La St. Lawrence Artificial Reef Association donne avis,par lesprésentes,qu’une demande a été déposée auprès du ministre desPêches et des Océans en vertu de laLoi sur la protection des eauxnavigables, pour l’approbation desplans et de l’emplacement del’ouvrage décrit ci-après. La St. Lawrence Artificial Reef Asso-ciation a, en vertu de l’article 9 de ladite loi, déposé auprès duministre des Pêches et des Océans, au bureau NWP du comté deLeeds et Grenville, à Prescott (Ontario), une description del’emplacement et lesplans d’un récif artificiel dans le fleuve

Page 28: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

1358 Canada Gazette Part I April 29, 2000

shipping channel, in front of Blockhouse Island or lot numberRegister Plan 67 - Block 29.

Saint-Laurent, à Brockville, au sud du canal de navigation setrouvant devant l’île Blockhouse ou du lotportant l’inscriptionRegister Plan 67 - Block 29.

Written objections based on the effect of the work on marinenavigation should be directed, not later than one month from thedate of publication of this notice, to the Regional Director,Canadian Coast Guard, Department of Fisheries and Oceans,201 Front Street N, Suite 703, Sarnia, Ontario N7T 8B1.

Toute objection aux répercussionsque les travauxpourraientavoir sur la navigation maritime doit être adresséepar écrit, dansun délai d’un mois suivant la date depublication duprésent avis,au Directeur régional, Garde côtière canadienne, Ministère desPêches et des Océans, 201, rue Front Nord, Bureau 703, Sarnia(Ontario) N7T 8B1.

Brockville, April 29, 2000 Brockville, le 29 avril 2000

DOUG CAMPBELLChairman

Le présidentDOUG CAMPBELL

[18-1-o] [18-1-o]

SUN LIFE TRUST COMPANY COMPAGNIE DE FIDUCIE SUN LIFE

CHANGE OF NAME CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE

Notice is hereby given that, in accordance with theprovisionsof the Trust and Loan Companies Act(Canada), Sun Life TrustCompany, a wholly-owned subsidiary of Laurentian Bank ofCanada, intends to make an application to the Minister of Financeto approve the change of its name to B2B Trust.

Avis est par lesprésentes donnéque, conformément aux dis-positions de laLoi sur les sociétés de fiducie et de prêt(Canada),la Compagnie de fiducie Sun Life, une filiale enpropriété exclu-sive de la Banque Laurentienne du Canada, a l’intention de de-mander au ministre des Finances l’autorisation de changer sadénomination sociale à B2B Trust.

Montréal, March 2, 2000 Montréal, le 2 mars 2000

SUZANNE MASSONSecretary

La secrétaireSUZANNE MASSON

[15-4-o] [15-4-o]

UNIGARD SECURITY INSURANCE COMPANY UNIGARD SECURITY INSURANCE COMPANY

CHANGE OF NAME CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE

Notice is hereby given that UNIGARD SECURITY INSUR-ANCE COMPANY intends to make an application to the Su-perintendent of Financial Institutions Canadapursuant tosection 576 of theInsurance Companies Actto change the nameunder which it is authorized to insure risks to SEATONINSURANCE COMPANY.

Avis estpar lesprésentes donnéque la UNIGARD SECURITYINSURANCE COMPANY a l’intention deprésenter une de-mande au surintendant des institutions financières du Canada, envertu de l’article 576 de laLoi sur les sociétés d’assurances, vi-sant à changer la raison sociale sous laquelle celle-ci est autoriséeà garantir des risques à SEATON INSURANCE COMPANY.

Vancouver, March 27, 2000 Vancouver, le 27 mars 2000

JOHN D. SAPINSKYChief Agent

L’agent principal

JOHN D. SAPINSKY[15-4-o] [15-4-o]

Page 29: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Le 29 avril 2000 Gazette du Canada Partie I 1359

PROPOSED REGULATIONS RÈGLEMENTS PROJET ÉS

Table of Contents Table des matières

Page Page

Health, Dept. of Santé, min. de laRegulations Amending the Food and Drug Regulations

(1097 — Aminopeptidase) [Erratum] .................... 1360Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et

drogues (1097 — aminopeptidase) [Erratum] ........ 1360

Page 30: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

1360 Canada Gazette Part I April 29, 2000

(Erratum) (Erratum)

Regulations Amending the Food and DrugRegulations (1097 — Aminopeptidase)

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments etdrogues (1097 — aminopeptidase)

Statutory Authority Fondement législatif

Food and Drugs Act Loi sur les aliments et drogues

Sponsoring Department Ministère responsable

Department of Health Ministère de la Santé

Notice is hereby given that in the above-mentioned Regulationspublished onpage 1200 of the Canada Gazette, Part I, Vol. 134,No. 16, dated Saturday, April 15, 2000, the table onpage 1203should have read as follows:

Avis est par les présentes donnéque dans le règlement sus-mentionnépublié à lapage 1200 de la Partie I de laGazette duCanada, vol. 134, no 16, en date du samedi 15 avril 2000, la ver-sion anglaise du tableau à lapage 1203 aurait dû se lire commesuit :

ItemNo.

Column III

Permitted in or Upon

Column IV

Maximum Level of UseItemNo.

Column III

Permitted in or Upon

Column IV

Maximum Level of Use

M.1 (2) Dairy based flavouringpreparations

(2) Good Manufacturing Practice M.1 (2) Dairy based flavouringpreparations

(2) Good Manufacturing Practice

(3) Hydrolyzed animal, milk andvegetable protein

(3) Good Manufacturing Practice (3) Hydrolyzed animal, milk andvegetable protein

(3) Good Manufacturing Practice

[18-1-o] [18-1-o]

Page 31: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Le 29 avril 2000 Gazette du Canada Partie I 1361

INDEX

No. 18 — April 29, 2000

(An asterisk indicates a notice previously published.)

COMMISSIONSCanadian Radio-television and Telecommunications

Commission*Addresses of CRTC offices — Interventions.................. 1340

Decisions2000-102 to 2000-104 ...................................................... 1340

Public Hearings2000-3............................................................................... 13412000-4............................................................................... 1344

Public Notices2000-55............................................................................. 13452000-56............................................................................. 1345

NAFTA SecretariatSolder joint pressure pipe fittings and solder joint

drainage, waste and vent pipe fittings — Decision ....... 1346

GOVERNMENT HOUSEAwards to Canadians ........................................................ 1334

GOVERNMENT NOTICESHealth, Dept. ofFood and Drugs Act

Food and Drug Regulations — Amendment (alpha-amylase enzyme) ........................................................... 1335

Food and Drug Regulations — Amendment (glucoseisomerase enzyme) ........................................................ 1335

Food and Drug Regulations — Amendment (pullulanaseenzyme)......................................................................... 1336

Superintendent of Financial Institutions, Office of theBank Act

Habib Canadian Bank, letters patent of incorporation ...... 1338

MISCELLANEOUS NOTICES*Associates Financial Life Insurance Company, application

for an order ...................................................................... 1348Commercial Travelers Mutual Insurance Company, release

of assets............................................................................. 1349Corner Brook Pulp and Paper Limited, bridge over the

Main River, Nfld............................................................... 1350Cortes Island Shellfish Growers Co-operative, off-bottom

oyster culture in Talbot Cove, B.C. .................................. 1350DJJ Leasing Ltd., Joseph Leasing Ltd., ECDC

Environmental, L.C. and I&M Rail Link, L.L.C.,documents deposited......................................................... 1351

Donohue Forest Products Inc., bridge over McGraw Creek,B.C.................................................................................... 1351

Donohue Forest Products Inc., bridge over Russel Creek,B.C.................................................................................... 1352

MISCELLANEOUS NOTICES — ContinuedDonohue Forest Products Inc., bridge over Stelkuz Creek,

B.C.................................................................................... 1352Donohue Forest Products Inc., bridge over Tsaydiz Creek,

B.C.................................................................................... 1353*First Catholic Slovak Ladies Association of the United

States of America (The), release of assets......................... 1353Flex Leasing II, LLC and Flex Leasing Corporation,

documents deposited......................................................... 1354*GE Global Insurance Holding Corporation, letters patent .. 1355Killins, Brian, and Elaine Killins, expansion of the existing

oyster lease site in the Lemmens Inlet, B.C. ..................... 1348*Lake Erie & Detroit River Railway Company (The),

annual and special meeting of shareholders...................... 1355Loblaw Properties Limited, vehicular and pedestrian bridge

over the Sackville River, N.S............................................ 1355London, City of, footbridge over the Thames River, Ont. .... 1348National City Bank, application to establish a foreign bank

branch ............................................................................... 1356ORGANIZATION FOR THE SUPPORT OF

VIETNAMESE REFUGEES, surrender of charter ........... 1356Procor Limited, documents deposited .................................. 1356*RBC Life Insurance Company and Westbury Canadian

Life Insurance Company, letters patent of amalgamation. 1357SONYA’S MARIONNETTE THEATRE INC., surrender

of charter........................................................................... 1357*Sun Life Trust Company, change of name.......................... 1358St. Lawrence Artificial Reef Association, artificial reef in

the St. Lawrence River, Ont.............................................. 1357*UNIGARD SECURITY INSURANCE COMPANY,

change of name ................................................................. 1358Woods, Clarence Michael, and Patrick Donald Koreski,

expansion of an oyster farm in Lemmens Inlet, B.C......... 1349

PARLIAMENTHouse of Commons

*Filing applications for private bills (2nd Session,36th Parliament)............................................................ 1339

SenateRoyal Assent

Bills assented to ................................................................ 1339

PROPOSED REGULATIONSHealth, Dept. ofFood and Drugs Act

Regulations Amending the Food and Drug Regulations(1097 — Aminopeptidase) [Erratum]........................... 1360

SUPPLEMENTSSuperintendent of Financial Institutions, Office of the

Insurance Companies and Fraternal Benefit Societies

Page 32: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

1362 Canada Gazette Part I April 29, 2000

INDEX

No 18 — Le 29 avril 2000

(L’astérisque indique un avis déjà publié.)

AVIS DIVERS*Associates Financial Life Insurance Company, demande

d’ordonnance ................................................................... 1348*Compagnie d’assurance vie RBC et Wesbury Canadienne,

Compagnie d’Assurance Vie, lettres patentes de fusion ... 1357Compagnie Mutuelle D’Assurances Commercial

Travellers, libération d’actif.............................................. 1349*Compagnie de fiducie Sun Life, changement de

dénomination sociale ........................................................ 1358Corner Brook Pulp and Paper Limited, pont au-dessus de la

rivière Main (T.-N.) .......................................................... 1350Cortes Island Shellfish Growers Co-operative, ostréiculture

en suspension dans l’anse Talbot (C.-B.).......................... 1350DJJ Leasing Ltd., Joseph Leasing Ltd., ECDC

Environmental, L.C. et I&M Rail Link, L.L.C., dépôt dedocuments ......................................................................... 1351

Donohue Forest Products Inc., pont au-dessus du ruisseauMcGraw (C.-B.) ................................................................ 1351

Donohue Forest Products Inc., pont au-dessus du ruisseauRussel (C.-B.) ................................................................... 1352

Donohue Forest Products Inc., pont au-dessus du ruisseauStelkuz (C.-B.) .................................................................. 1352

Donohue Forest Products Inc., pont au-dessus du ruisseauTsaydiz (C.-B.).................................................................. 1353

*First Catholic Slovak Ladies Association of the UnitedStates of America (The), libération d’actif........................ 1353

Flex Leasing II, LLC et Flex Leasing Corporation, dépôt dedocuments ......................................................................... 1354

*GE Global Insurance Holding Corporation, lettrespatentes ............................................................................. 1355

Killins, Brian, et Elaine Killins, agrandissement d’un bailhuîtrier actuellement dans le bras de mer Lemmens(C.-B.) ............................................................................... 1348

*Lake Erie & Detroit River Railway Company (The),assemblée extraordinaire et annuelle des actionnaires ...... 1355

Loblaw Properties Limited, pont-route et passerelleau-dessus de la rivière Sackville (N.-É.) ........................... 1355

London, City of, passerelle au-dessus de la rivière Thames(Ont.)................................................................................. 1348

National City Bank, demande d’établissement d’unesuccursale de banque étrangère......................................... 1356

ŒUVRE DU SOUTIEN AUX RÉFUGIÉSVIETNAMIENS, abandon de charte................................. 1356

Procor Limited, dépôt de documents .................................... 1356St. Lawrence Artificial Reef Association, récif artificiel

dans le fleuve Saint-Laurent (Ont.)................................... 1357THÉÂTRE DE MARIONNETTES SONYA INC., abandon

de charte............................................................................ 1357*UNIGARD SECURITY INSURANCE COMPANY,

changement de dénomination sociale ............................... 1358

AVIS DIVERS (suite)Woods, Clarence Michael, et Patrick Donald Koreski,

agrandissement d’un parc à huîtres dans le bras de merLemmens (C.-B.) .............................................................. 1349

AVIS DU GOUVERNEMENTSanté, min. de laLoi sur les aliments et drogues

Règlement sur les aliments et drogues — Modification(enzyme alpha-amylase) ................................................ 1335

Règlement sur les aliments et drogues — Modification(enzyme glucose-isomérase) ......................................... 1335

Règlement sur les aliments et drogues — Modification(enzyme pullulanase)..................................................... 1336

Surintendant des institutions financières, bureau duLoi sur les banques

Banque Habib Canadienne, lettres patentes deconstitution.................................................................... 1338

COMMISSIONSConseil de la radiodiffusion et des télécommunications

canadiennes*Adresses des bureaux du CRTC — Interventions........... 1340

Audiences publiques2000-3............................................................................... 13412000-4............................................................................... 1344

Avis publics2000-55............................................................................. 13452000-56............................................................................. 1345

Décisions2000-102 à 2000-104........................................................ 1340

Secrétariat de l’ALÉNARaccords de tuyauterie à souder de types à pression et à

drainage, renvoi et évent — Décision ........................... 1346

PARLEMENTChambre des communes

*Demandes introductives de projets de loi privés(2e session, 36e législature)............................................ 1339

SénatSanction royale

Projets de loi sanctionnés.................................................. 1339

RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRALDécorations à des Canadiens ............................................ 1334

RÈGLEMENTS PROJETÉSSanté, min. de laLoi sur les aliments et drogues

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments etdrogues (1097 — aminopeptidase) [Erratum] .............. 1360

SUPPLÉMENTSSurintendant des institutions financières, bureau du

Sociétés d’assurances et sociétés de secours mutuel

Page 33: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

SupplementCanada Gazette, Part I

April 29, 2000

SupplémentGazette du Canada, Partie I

Le 29 avril 2000

INSURANCE COMPANIESAND

FRATERNAL BENEFITSOCIETIES

SOCIÉTÉS D’ASSURANCESET

SOCIÉTÉS DE SECOURSMUTUEL

Registered to do business in Canada under theInsurance Companies Actas at March 31, 2000.

Enregistréespour faire des affaires au Canada en vertu de laLoi sur les sociétés d’assurancesau 31 mars 2000.

Page 34: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

2 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

TABLE OF CONTENTS TABLE DES MATIÈRES

Page Page

Insurance Companies....................................................... 3 Sociétés d’assurances ...................................................... 3

Fraternal Benefit Societies............................................... 41 Sociétés de secours mutuel .............................................. 41

Notes................................................................................ 44 Remarques ....................................................................... 44

______Prepared by the Office of the Superintendent of Financial Institutions, Canada in

accordance with section 585 of theInsurance Companies Act.

______Préparé par le Bureau du surintendant des institutions financières, Canada con-

formément à l’article 585 de laLoi sur les sociétés d’assurances.

Page 35: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 3

ACE INA Insurance250 Yonge Street, Suite 1400Toronto, Ontario M5B 2L7Samuel B. Cupp, President and

Chief Executive Officer.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Hail,Liabilit y and Surety.

Voir-Assurance ACE INA

Aegon Insurance Company (U.K.) Limited57 Lakeshore Road East, No. 1Mississauga, Ontario L5G 1C9Eric G. Winn, Chief Agent.

Property, Aircraft and Liability,limited to the servicing ofexisting policies.

Aegon Insurance Company (U.K.) Limited57, chemin Lakeshore Est, No 1Mississauga (Ontario) L5G 1C9Eric G. Winn, Agentprincipal.

Biens, aériennes et responsabilité,limitée à l’écoulement despolices existantes.

Ætna Life Insurance CompanyT-D Bank Tower, 42nd FloorBox 20, Suite 4200, T-D CentreToronto, Ontario M5K 1N6Robert W. McDowell, Chief Agent.

Life, Personal accident andSickness.

Ætna Life Insurance CompanyT-D Bank Tower, 42e étageC.P. 20, Bureau 4200, T-D CentreToronto (Ontario) M5K 1N6Robert W. McDowell, Agentprincipal.

Vie, accidents corporels etmaladie.

Affiliated F M Insurance Company155 Gordon Baker Rd., Suite 202Willowdale, Ontario M2H 3N7Perry Brazeau, Chief Agent.

Property, Boiler and machinery,Fidelity, Liability and Surety.

Affiliated F M Insurance Company155, chemin Gordon Baker, Bureau 202Willowdale (Ontario) M2H 3N7Perry Brazeau, Agentprincipal.

Biens, chaudières et machines,abus de confiance, responsabilitéet caution.

AIG Life Insurance Company of Canada145 Wellington Street West, 8th FloorToronto, Ontario M5J 2T4Ralph J. Gaudio, President and Chief

Executive Officer.

Life, Accident and sickness. Voir-La Compagnie d’Assurance-VieAIG du Canada

Alexander Hamilton Life InsuranceCompany of America

3400 One First Canadian PlaceP.O. Box 130Toronto, Ontario M5X 1A4Stephen Paddon, Chief Agent.

Life, Accident and sickness,limited to the servicing ofpolicies issuedprior toJanuary 1, 1997.

Alexander Hamilton Life InsuranceCompany of America

3400, One First Canadian PlaceC.P. 130Toronto (Ontario) M5X 1A4Stephen Paddon, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie, limitée àla gestion despolices émisesavant le 1er janvier 1997.

Allianz Insurance Company of Canada10 York Mills Road, Suite 700Toronto, Ontario M2P 2G5Robert E. Maynard, President and Chief

Executive Officer.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Credit, Fidelity,Legal expense, Liability andSurety.

Voir-Compagnie d’Assurance Allianz duCanada

Allianz Life Insurance Company ofNorth America

2005 Sheppard Avenue East,Suite 700Willowdale, Ontario M2J 5B4Doreen G. Johnston, Chief Agent.

Life, Accident and sickness. Allianz Life Insurance Company ofNorth America

2005, av. Sheppard Est, Bureau 700Willowdale (Ontario) M2J 5B4Doreen G. Johnston, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie.

Allstate Insurance Company10 Allstate ParkwayMarkham, Ontario L3R 5P8Paul R. Morin, Chief Agent.

Property, Aircraft, Automobile,Boiler and machinery, Fidelity,Hail, Liability and Surety.

Allstate Insurance Company10 Allstate ParkwayMarkham (Ontario) L3R 5P8Paul R. Morin, Agentprincipal.

Biens, aériennes, automobile,chaudières et machines,détournements,grêle,responsabilité et caution.

Allstate Insurance Company of Canada10 Allstate ParkwayMarkham, Ontario L3R 5P8Michael L. Haskell, President

and Chief Executive Officer.

Property, Accident and sickness,Automobile, Boiler andmachinery, Legal expense,Fidelity, Liability and Surety.

Allstate du Canada, Compagnie d’Assurance10 Allstate ParkwayMarkham (Ontario) L3R 5P8Michael L. Haskell, Président et

chef de la direction.

Biens, accidents et maladie,automobile, chaudières etmachines, fraisjuridiques,détournements, responsabilité etcaution.

Allstate Life Insurance Company10 Allstate ParkwayMarkham, Ontario L3R 5P8Paul R. Morin, Chief Agent.

Life, Accident and sickness,limited to the servicing ofpolicies issuedprior toNovember 15, 1996.

Allstate Life Insurance Company10 Allstate ParkwayMarkham (Ontario) L3R 5P8Paul R. Morin, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie, limitée àla gestion despolices émisesavant le 15 novembre 1996.

Allstate Life Insurance Company of Canada10 Allstate ParkwayMarkham, Ontario L3R 5P8Michael L. Haskell, President

and Chief Executive Officer.

Life, Accident and sickness,limited to the servicing ofpolicies issuedprior toNovember 15, 1996.

Allstate du Canada, Compagnied’Assurance-Vie

10 Allstate ParkwayMarkham (Ontario) L3R 5P8Michael L. Haskell, Président et chef

de la direction.

Vie, accidents et maladie, limitée àla gestion despolices émisesavant le 15 novembre 1996.

Alpina Insurance Company Limited400 University Ave.Toronto, Ontario M5G 1S7Barry John Gilway, Chief Agent.

Property, Automobile andLiabilit y, limited to the servicingof existing policies.

Alpina Insurance Company Limited400, av. UniversityToronto (Ontario) M5G 1S7Barry John Gilway, Agentprincipal.

Biens, automobile etresponsabilité, limitée àl’écoulement despolicesexistantes.

Alta Surety Company800 René-Lévesque Blvd. WestSuite 2795Montréal, Quebec H3B 1X9Aram Semerjian, President.

Fidelity and Surety, limited to theservicing of existing policies.

Voir-La Compagnie de Cautionnement Alta

Page 36: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

4 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

American Bankers Insurance Companyof Florida

5001 Yonge Street, Suite 1700North York, Ontario M2N 6T7Mark S.J. Scime, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Automobile, Credit, Fidelity,Surety and Liability, on thecondition that if in thetransaction of its business inCanada the company uses aFrench form of name, that nameshall be “American BankersCompagnie d’AssurancesGénérales de la Floride”.

American Bankers Compagnied’Assurances Généralesde la Floride

5001, rue Yonge, Bureau 1700North York (Ontario) M2N 6T7Mark S.J. Scime, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,automobile, détournements,crédit, responsabilité et caution,pourvuque, si la société utiliseune dénomination socialefrançaise dans le cadre del’exercice de son activité auCanada, ce soit « AmericanBankers Compagnied’Assurances Générales de laFloride ».

American Bankers Life Assurance Companyof Florida

5001 Yonge Street, Suite 1700North York, Ontario M2N 6T7Mark S.J. Scime, Chief Agent.

Life, Accident and sickness, on thecondition that if in thetransaction of its business inCanada the Company uses aFrench form of name that nameshall be “American BankersCompagnie d’Assurances-Vie dela Floride”.

American Bankers Compagnied’Assurances-Vie de laFloride

5001, rue Yonge, Bureau 1700North York (Ontario) M2N 6T7Mark S.J. Scime, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie à laconditionque, si la Compagnieutilise un nom français dans sesaffaires au Canada, ce nom serait« American Bankers Compagnied’Assurances-Vie de la Floride ».

American Home Assurance Company145 Wellington St. WestToronto, Ontario M5J 1H8Gary A. McMillan, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Credit, Fidelity, Hail,Liabilit y and Surety.

American Home Assurance Company145, rue Wellington OuestToronto (Ontario) M5J 1H8Gary A. McMillan, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,aériennes, automobile,chaudières et machines, crédit,détournements,grêle,responsabilité et caution.

American Income Life Insurance Companyc/o McLean & Kerr130 Adelaide Street WestSuite 2800Toronto, Ontario M5H 3P5Robin B. Cumine, Q.C., Chief Agent.

Life, Accident and sickness. American Income Life Insurance Companya/s McLean & Kerr130, rue Adelaide Ouest, Bureau 2800Toronto (Ontario) M5H 3P5Robin B. Cumine, C.R., Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie.

American National Fire Insurance Company40 King Street WestScotia Plaza, Suite 2100Toronto, Ontario M5H 3C2J. Brian Reeve, Chief Agent.

Fire, Accident, Automobile, Boilerexcluding machinery,Earthquake, Explosion, Forgery,Hail, Inland transportation,Personalproperty, Plateglass,Realproperty, Theft andadditional classes 3, 5, 7, 8, 9and 10. (SeeNote (B))

American National Fire Insurance Company40, rue King OuestScotia Plaza, Bureau 2100Toronto (Ontario) M5H 3C2J. Brian Reeve, Agentprincipal.

Incendie, accidents, automobile,biens immeubles, biens meubles,brise desglaces, chaudières (lesmachines non comprises),explosions, faux,grêle,transports terrestres,tremblements de terre, vol etcatégories additionnelles 3, 5, 7,8, 9 et 10. (Voir Remarque (B))

American Re-Insurance Company250 Yonge Street, P.O. Box 20Suite 2010Toronto, Ontario M5B 2L7Randolph B. Scott, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Credit, Fidelity, Hail,Liabilit y and Surety.

American Re-Insurance Company250, rue YongeC.P. 20, Bureau 2010Toronto (Ontario) M5B 2L7Randolph B. Scott, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,accidents d’aviation, automobile,chaudières et machines, crédit,abus de confiance,grêle,responsabilité et caution.

The American Road Insurance Company1145 Nicholson Road, Unit 2Newmarket, Ontario L3Y 7V1Colleen Sexsmith, Chief Agent.

Property, Automobile, Boiler andmachinery (limited to theProvince of Alberta and vehiclewarranty insurance as defined bythe Classes of InsuranceRegulations of the Province ofAlberta), Credit, Liability andSurety.

The American Road Insurance Company1145, chemin Nicholson, Unité 2Newmarket (Ontario) L3Y 7V1Colleen Sexsmith, Agentprincipal.

Biens, automobile, chaudières etmachines (limitée à laprovincede l’Alberta, et l’assurance degarantie des véhicules tellequedéfiniepar le règlementpertinentde laprovince de l’Alberta),crédit, responsabilité et caution.

AMEX Assurance Company60 Bloor St. West, Suite 403Toronto, Ontario M4W 3L8Judy K. S. Ha, Chief Agent.

Life, Accident and sickness, to theextent authorized by its articlesof incorporation and limited togroup airflight insurance andgroup travel accident insurance,on the condition that if in thetransaction of its business inCanada the company uses aFrench form of name, that nameshall be “AMEX Compagnied’Assurance”.

AMEX Compagnie d’Assurance60, rue Bloor Ouest, Bureau 403Toronto (Ontario) M4W 3L8Judy K. S. Ha, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie, dans lamesureprévuepar ses articlesconstitutifs et se limitant àl’assurance collective desoccupants d’avions et àl’assurance collective contre lesaccidents de voyage,pourvuque,si la société utilise unedénomination sociale françaisedans le cadre de l’exercice deson activité au Canada, ce soit« AMEX Compagnied’Assurance ».

See-Old Republic Insurance Companyof Canada

L’Ancienne République, Compagnied’Assurance du Canada

100, rue King Ouest, C.P. 557Hamilton (Ontario) L8N 3K9Frank Szirt, Président et chef

de la direction.

Biens, aériennes, automobile etresponsabilité.

Page 37: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 5

Anglo Canada General Insurance Company5700 Yonge Street, Suite 1400North York, Ontario M2M 4K2Joseph K. Fung, Chief Financial Officer.

Property, Accident and sickness,Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Hail,Liabilit y and Surety, limited tothe business of reinsurance.

Anglo Canada General Insurance Company5700, rue Yonge, Bureau 1400North York (Ontario) M2M 4K2Joseph K. Fung, Chef des finances.

Biens, accidents et maladie,automobile, chaudières etmachines, détournements,grêle,responsabilité et caution, limitéeaux affaires de réassurance.

Antigonish Farmers’ Mutual FireInsurance Company

P.O. Box 1535Antigonish,Nova Scotia B2G 2L8W. J. Chisholm, Secretary-

Treasurer and Manager.

Fire, Public liability, Theft, andadditional classes 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9 and 10 (SeeNote (B)),restricted to the Province ofNova Scotia.

Antigonish Farmers’ Mutual FireInsurance Company

C.P. 1535Antigonish (Nouvelle-Écosse) B2G 2L8W. J. Chisholm, Secrétaire-trésorier

et directeur.

Incendie, responsabilité civile, vol,et catégories additionnelles 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 (voirRemarque (B)), restreint à laprovince de la Nouvelle-Écosse.

Assicurazioni Generali S.p.A.1000 rue de la Gauchetière WestSuite 500Montréal, Quebec H3B 4W5W. J. Green, Chief Agent.

Property, Automobile, Fidelity,Hail, Legal expense, Liability,and Surety, limited to thebusiness of reinsurance.

Assicurazioni Generali S.p.A.1000, rue de la Gauchetière OuestBureau 500Montréal (Québec) H3B 4W5W. J. Green, Agentprincipal.

Biens, automobile, détournements,grêle, fraisjuridiques,responsabilité et caution, limitéeaux affaires de réassurance.

Assitalia-Le Assicurazioni d’Italia S.P.A.1190 Hornby Street, Suite 1000Vancouver British Columbia V6Z 2W2D. Jay Smith, Chief Agent.

Property and liability, limited tothe servicing of existing policies.

Assitalia-Le Assicurazioni d’Italia S.P.A.1190, rue Hornby, Bureau 1000Vancouver(Colombie-Britannique) V6Z 2W2D. Jay Smith, Agentprincipal.

Biens et responsabilité, limitée àl’administration despolicesexistantes.

Associates Insurance Companyc/o Blake, Cassels & GraydonP.O. Box 25Commerce Court WestToronto, Ontario M5L 1A9Barry G. McGee, Chief Agent.

Automobile, limited to theservicing of existing policies.

Associates Insurance Companya/s Blake, Cassels & GraydonC.P. 25, Commerce Court WestToronto (Ontario) M5L 1A9Barry G. McGee, Agentprincipal.

Automobile, limitée àl’administration despolicesexistantes.

See-ACE INA Insurance Assurance ACE INA250, rue Yonge, Bureau 1400Toronto (Ontario) M5B 2L7Samuel B. Cupp, Président et chef

de la direction.

Biens, accidents et maladie,aériennes, automobile,chaudières et machines,détournements,grêle,responsabilité et caution.

See-Trade Indemnity P.L.C. Assurances Trade Indemnity320, chemin March, Bureau 103Kanata (Ontario) K2K 2D3Ian Douglas Miller, Agentprincipal.

Crédit, limitée à l’écoulement despolices existantes.

Avemco Insurance Company133 Richmond St. WestSuite 600Toronto, Ontario M5H 2L3Donald G. Smith, Chief Agent.

Accident and sickness, Aircraft. Avemco Insurance Company133, rue Richmond Ouest, Bureau 600Toronto (Ontario) M5H 2L3Donald G. Smith, Agentprincipal.

Accidents et maladie, accidentsd’aviation.

Aviation & General InsuranceCompany Limited

c/o British Aviation Insurance Group(Canada) Ltd.

100 Renfrew Drive, Suite 200Markham, Ontario L3R 9R6Murray Frank Bartel, Chief Agent.

Aircraft and Liability. Aviation & General InsuranceCompany Limited

a/s British Aviation Insurance Group(Canada) Ltd.

100,promenade Renfrew, Bureau 200Markham (Ontario) L3R 9R6Murray Frank Bartel, Agentprincipal.

Accidents d’aviation etresponsabilité.

AXA Insurance (Canada)5700 Yonge Street, Suite 1400North York, Ontario M2M 4K2Joseph K. Fung, Chief Financial Officer.

Property, Accident and sickness,Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Hail,Liabilit y and Surety.

AXA Assurances (Canada)5700, rue Yonge, Bureau 1400North York (Ontario) M2M 4K2Joseph K. Fung, Chef des finances.

Biens, accidents et maladie,automobile, chaudières etmachines, détournements,grêle,responsabilité et caution.

AXA Pacific Insurance Company999 West Hastings StreetVancouver, British Columbia V6C 2W2Robert P. Vickerstaff, President

and Chief Operating Officer.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Credit, Fidelity, Hail,Liabilit y and Surety.

AXA Pacifique Compagnie d’Assurance999, rue West HastingsVancouver(Colombie-Britannique) V6C 2W2Robert P. Vickerstaff, Président et

chef des opérations.

Biens, accidents et maladie,aériennes, automobile,chaudières et machines, crédit,détournements,grêle,responsabilité et caution.

Axa Réassurance1800 McGill College, Suite 2000Montréal, Quebec H3A 3J6Claire Gariépy, Chief Agent.

Life, Property, Accident andsickness, Aircraft, Automobile,Boiler and Machinery, Fidelity,Hail, Liability and Surety,limited to the business ofreinsurance.

Axa Réassurance1800, McGill College, Bureau 2000Montréal (Québec) H3A 3J6Claire Gariépy, Agentprincipal.

Vie, biens, accidents et maladie,aériennes, automobile,chaudières et machines,détournements,grêle,responsabilité et caution, limitéeaux affaires de réassurance.

Balboa Insurance Company201 Queens AvenueP.O. Box 5071, Terminal ALondon, Ontario N6A 4M5Anthony W. Miles, Chief Agent.

Property and Accident andsickness, limited to the servicingof existing policies.

Balboa Insurance Company201, av. QueensC.P. 5071, Terminus ALondon (Ontario) N6A 4M5Anthony W. Miles, Agentprincipal.

Biens et accidents et maladie,limitée à l’écoulement despolices existantes.

Page 38: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

6 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

Balboa Life Insurance Company201 Queens AvenueP.O. Box 5071, Terminal ALondon, Ontario N6A 4M5Anthony W. Miles, Chief Agent.

Life, and Accident and sickness(accident and sickness insuranceis limited to the servicing ofexisting policies).

La Balboa, compagnie d’assurance-vie201, av. QueensC.P. 5071, Terminus ALondon (Ontario) N6A 4M5Anthony W. Miles, Agentprincipal.

Vie, et accidents et maladie (lesopérations d’assurance accidentset maladie sont limitées àl’écoulement despolicesexistantes).

Bankers Life and Casualty Companyc/o Fasken Campbell GodfreyToronto-Dominion Centre,P.O. Box 20, Suite 4200Toronto, Ontario M5K 1N6Robert W. McDowell, Chief Agent.

Life, Accident and sickness,limited to the servicing ofpolicies issuedprior toDecember 10, 1999, with theexception that the foreigncompany may provide insuranceon the lives of Canadianresidents employed by a UnitedStates client of the foreigncompany or an affiliate of one ofits United States clients.

Bankers Life and Casualty Companya/s Fasken Campbell GodfreyToronto-Dominion Centre,C.P. 20, Bureau 4200Toronto (Ontario) M5K 1N6Robert W. McDowell, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie, limitée àla gestion despolices émisesavant le 10 décembre 1999, saufqu’elle peut assurer la vie derésidents fu Canadaqu’emploiel’un de ses clients desÉtats-Unisou un membre dugroupe de l’unde ces mêmes clients.

Blue Cross Life Insurance Companyof Canada

P.O. Box 220, 644 Main StreetMoncton, New BrunswickE1C 8L3Pierre-Yves Julien, President and

Chief Executive Officer.

Life, Accident and sickness. Voir-Compagnie d’Assurance-Vie CroixBleue du Canada.

The Boiler Inspection and InsuranceCompany of Canada

18 King St. EastToronto, Ontario M5C 1C4Hans A. Schols, President and

General Manager.

Property, Boiler and machineryand Liability.

Voir-La Compagnie d’Inspection etd’Assurance Chaudières et Machinerie.

See-Canadian Northern Shield InsuranceCompany.

Le Bouclier du Nord Canadien,Compagnie d’Assurance

C.P. 12133, Bureau 1900555, rue West HastingsVancouver(Colombie-Britannique) V6B 4N6T. Michael Porter, Président et chef

de la direction.

Biens, accidents et maladie,automobile, chaudières etmachines, abus de confiance,responsabilité et caution.

The British Aviation InsuranceCompany Limited

100 Renfrew Drive, Suite 200Markham, Ontario L3R 9R6Murray Frank Bartel, Chief Agent.

Accident, Aircraft and Inlandtransportation.

The British Aviation Insurance CompanyLimited

100,promenade Renfrew, Bureau 200Markham (Ontario) L3R 9R6Murray Frank Bartel, Agentprincipal.

Accidents, aéronefs et transportsterrestres.

Caisse Centrale de Réassurancec/o Jacques Davis Lefaivre & cie Ltée1080 Beaver Hall Hill, 19th FloorMontreal, Quebec H2Z 1S8Jacques Mailloux, Chief Agent

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andMachinery, Fidelity, Legalexpense, Liability and Surety,limited to the business ofreinsurance.

Caisse Centrale de Réassurancea/s Jacques Davis Lefaivre & cie Ltée1080, côte du Beaver Hall, 19e étageMontréal (Québec) H2Z 1S8Jacques Mailloux, Agentprincipal

Biens, accidents et maladie,aériennes, automobile,chaudières et machines,détournements, fraisjuridiques,responsabilité et caution, limitéeaux affaires de réassurance.

Calvert Insurance Companyc/o Focus Group Inc.36 King Street East, Suite 500Toronto, Ontario M5C 1E5Philip H. Cook, Chief Agent.

Property, Automobile andLiabilit y.

Calvert Insurance Companya/s Focus Group Inc.36, rue King Est, Bureau 500Toronto (Ontario) M5C 1E5Philip H. Cook, Agentprincipal.

Biens, automobile etresponsabilité.

The Canada Life Assurance Company330 University Ave.Toronto, Ontario M5G 1R8David Alexander Nield, President and

Chief Executive Officer.

Life, Accident and sickness. Voir-La Compagnie d’Assurance du Canadasur la Vie.

Canada Life Casualty Insurance Companyc/o Canada Life Assurance Company330 University Ave.Toronto, Ontario M5G 1R8David Victor Newton, President and

Chief Operating Officer.

Property, Accident and sickness,Automobile, Boiler andmachinery, Legal expense andLiabilit y.

Canada-Vie Compagnie D’AssuranceGénérales

a/s La Compagnie d’Assurance du Canadasur la Vie

330, av. UniversityToronto (Ontario) M5G 1R8David Victor Newton, Président et chef

Des opérations.

Biens, accidents et maladie,automobile, chaudières etmachines, fraisjuridiques etresponsabilité.

Page 39: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 7

Canada Life Financial Corporation330 University AveToronto, Ontario M5G 1R8David Nield, President and Chief

Executive officer

Life Voir-Corporation Financière Canada-Vie Vie

Canadian Northern Shield InsuranceCompany

P.O. Box 121331900–555 West Hastings St.Vancouver, British Columbia V6B 4N6T. Michael Porter, President and

Chief Executive Officer.

Property, Accident and sickness,Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Liability andSurety.

Voir-Le Bouclier du Nord Canadien,Compagnie d’Assurance.

Canadian Premier Life Insurance Company80 Tiverton Court, Suite 500Markham, Ontario L3R 0G4Aaron Hill, Vice-President and

Chief Executive Officer.

Life, Accident and sickness. Voir-Compagnie d’assurance-vie Premièredu Canada.

Centennial Insurance Companyc/o Focus Group Inc.36 King Street East, Suite 500Toronto, Ontario M5C 1E5Philip H. Cook, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Hail, Fidelity andLiabilit y.

Centennial Insurance Companya/s Focus Group Inc.36, rue King Est, Bureau 500Toronto (Ontario) M5C 1E5Philip H. Cook, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,aériennes, automobile,chaudières et machines,grêle,détournements et responsabilité.

See-Gold Circle Insurance Company. Cercle d’Or, Compagnie d’Assurancea/s The Great-West Life Assurance

Company100, rue Osborne NordWinnipeg (Manitoba) R3C 3A5Sheila Wagar, Secrétaire.

Biens, accidents et maladie,automobile et responsabilité,limitée à l’administration despolices existantes.

CGU Insurance Company of Canada2206 Eglinton Avenue EastScarborough, Ontario M1L 4S8Mark Webb, Executive Vice President and

Chief Operating Officer.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Hail, Legalexpense, Liability and Surety.

CGU, Compagnie D’Assurance du Canada2206, av. Eglinton EstScarborough (Ontario) M1L 4S8Mark Webb, Vice-président exécutif

et chef des opérations.

Biens, accidents et maladie,aériennes, automobile,chaudières et machines,détournements,grêle, fraisjuridiques, responsabilité etcaution.

CGU International Insuranceplc350 Albert Street, Suite 700Ottawa, Ontario K1R 1A4Denis Shillington, Chief Agent.

Property, Liability and Aircraft. CGU International Insuranceplc350, rue Albert, Bureau 700Ottawa (Ontario) K1R 1A4Denis Shillington, Agentprincipal.

Biens, responsabilité et aériennes.

Chancellor Reinsurance Company of CanadaSuite 2000, Oceanic Plaza1066 West Hastings StreetVancouver, British Columbia V6E 3X2Robert Rusko, AgentKPMG Chartered AccountantsAgent for the Superintendent ofFinancial Institutions, ProvisionalLiquidator.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Credit, Fidelity, Hail,Legal expense, Liability andSurety, limited to the business ofreinsurance. As of July 5, 1995,Chancellor ReinsuranceCompany of Canada is involuntary, court supervisedliquidation and dissolution undertheprovisions of theInsuranceCompanies Act.KPMGChartered Accountants has beenappointed as liquidator of thecompany by court order.

Voir-La Compagnie de RéassuranceChancellor du Canada.

Chicago Title Insurance Company141 Adelaide Street WestSuite 1006Toronto, Ontario M5H 3L5J. Donald Bergeron, Chief Agent.

Title. Chicago Title Insurance Company141, rue Adelaide OuestBureau 1006Toronto (Ontario) M5H 3L5J. Donald Bergeron, Agentprincipal.

Titres.

Chieftain Insurance Company165 University AvenueToronto, Ontario M5H 3B9George L. Cooke, President and

Chief Executive Officer.

Property, Automobile andLiabilit y.

Chieftain Insurance Company165, av. UniversityToronto (Ontario) M5H 3B9George L. Cooke, Président et

Chef de la direction.

Biens, automobile etresponsabilité.

Chrysler Insurance Company2700 Matheson Blvd. EastSuite 400, EastTowerMississauga, Ontario L4W 4V9Richard Wong, Chief Agent.

Property, Automobile, Liabilityand Surety.

Chrysler Insurance Company2700, boul. Matheson EstBureau 400, Tour EstMississauga (Ontario) L4W 4V9Richard Wong, Agentprincipal.

Biens, automobile, responsabilitéet caution.

Page 40: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

8 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

Chrysler Life Insurance Company of Canada2700 Matheson Blvd. EastSuite 400, EastTowerMississauga, Ontario L4W 4V9Richard Wong, Chief Executive Officer.

Life, Accident and sickness to theextent authorized by itsinstrument of incorporation andlimited to the servicing ofpolicies issuedprior toApril 1, 1991.

Chrysler Compagnie D’Assurance-Viedu Canada

2700, boul. Matheson EstBureau 400, Tour EstMississauga (Ontario) L4W 4V9Richard Wong, Chef de la direction.

Vie, accidents et maladie dans lamesure autoriséepar son acte deconstitution en corporation etsous réserve de la restrictionqueles affaires de la compagniesoient limitées à l’écoulementdespolices émises avant le1er avril 1991.

Chubb Insurance Company of CanadaOne Financial Place1 Adelaide Street EastToronto, Ontario M5C 2V9Janice M. Tomlinson, President.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Liability andSurety.

Chubb du Canada Compagnie d’AssuranceOne Financial Place1, rue Adelaide EstToronto (Ontario) M5C 2V9Janice M. Tomlinson, Président.

Biens, accidents et maladie,accidents d’aviation, automobile,chaudières et machines, abus deconfiance, responsabilité etcaution.

CIBC General Insurance Company Limited3 Robert Speck ParkwaySuite 500, P.O. Box 7065Mississauga, Ontario L5A 4K7Dwight Lacey, Chief Executive Officer.

Property, Automobile, Liabilityand Surety.

Voir-Compagnie d’assurancegénéraleCIBC Limitée.

CIBC Life Insurance Company Limited3 Robert Speck ParkwaySuite 500, P.O. Box 7065Mississauga, Ontario L5A 4K7Gabor Kalmar, President and

Chief Operating Officer.

Life, Accident and sickness. Voir-Compagnie d’assurance-vieCIBC Limitée.

CIGNA Life Insurance Company of Canada55 Town Centre Court, Suite 606P. O. Box 14Scarborough, Ontario M1P 4X4Samuel B. Cupp, President and

Chief Executive Officer.

Life, Accident and sickness, andLoss of Employment.

CIGNA du Canada compagnie d’assurancesur la vie

55, cour Town Centre,Bureau 606, C.P. 14Scarborough (Ontario) M1P 4X4Samuel B. Cupp, Président et chef

de la direction.

Vie, accidents et maladie etperted’emploi.

The Citadel General Assurance Company1075 Bay St.Toronto, Ontario M5S 2W5Ernst Notz, President and Chief

Executive Officer.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Hail, Legalexpense, Liability, Loss ofEmployment and Surety.

La Citadelle, Compagnie d’AssurancesGénérales

1075, rue BayToronto (Ontario) M5S 2W5Ernst Notz, Président et chef

de la direction.

Biens, accidents et maladie,aériennes, automobile,chaudières et machines,détournements,grêle, fraisjuridiques, responsabilité,perted’emploi et caution.

Clare Mutual Insurance CompanyBelliveau’s Cove, Nova Scotia B0W 1J0Henri J. Thibodeau, President.

Fire and Theft and additionalclasses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and10 (SeeNote (B)), restricted tothe Province of Nova Scotia.

Clare Mutual Insurance CompanyBelliveau’s Cove(Nouvelle-Écosse) B0W 1J0Henri J. Thibodeau, Président.

Incendie etvol; et catégoriesadditionnelles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9 et 10 (Voir Remarque (B)),restreint à laprovince de laNouvelle-Écosse.

Clarica Life Insurance Company227 King St. SouthWaterloo, Ontario N2J 4C5Robert M. Astley, President and Chief

Executive Officer.

Life, Accident and Sickness. Clarica, compagnie d’assurance sur la vie227, rue King SudWaterloo (Ontario) N2J 4C5Robert M. Astley, Président et chef

de la direction.

Vie, accidents et maladie.

CNA Life Insurance Company of Canada40 Weber Street East, 7th FloorKitchener, Ontario N2H 6R3Robert D. Scott, President and

Chief Executive Officer.

Life, Accident and sickness andLoss of employment.

Voir-Compagnie d’Assurance-Vie CNAdu Canada.

Cologne Reinsurance Company(Kolnische Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft)

c/o D. M. Williams & Associates Ltd.3650 Victoria Park Ave., Suite 201North York, Ontario M2H 3P7V. Lorraine Williams, Chief Agent.

Property, Aircraft, Automobile,Boiler and machinery, Credit,Fidelity, Hail, Liability andSurety, limited to the business ofreinsurance.

Cologne Reinsurance Company(Kolnische Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft)

a/s D. M. Williams & Associates Ltd.3650, av. Victoria Park, Bureau 201North York (Ontario) M2H 3P7V. Lorraine Williams, Agentprincipal.

Biens, accidents d’aviation,automobile, crédit, chaudières etmachines, abus de confiance,grêle, responsabilité et caution,limitée aux affaires deréassurances.

Combined Insurance Company of America7300 Warden AvenueMarkham, Ontario L3R 0X3Dan C. Evans, Chief Agent.

Life, Accident and sickness, on thecondition that if in thetransaction of its business inCanada the Company uses aFrench name, that name shall be“Compagnie d’assuranceCombined d’Amérique”.

Voir-Compagnie d’assurance Combinedd’Amérique.

The Commerce Group Insurance Company2450 Girouard St. West, P.O. Box 1000Saint-Hyacinthe, Quebec J2S 7C4Claude Gravel, President and

Chief Operating Officer.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Legal Expense,Fidelity, Hail, Liability andSurety.

Voir-Le Groupe Commerce Compagnied’Assurances.

Page 41: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 9

Commercial Travelers Mutual InsuranceCompany (incorporated under the lawsof the State of New York, U.S.A.)

8 Ranchwood PlaceBrampton, Ontario L6R 1W5William C. Jorgens, Chief Agent.

Accident and sickness, on thecondition that the words“incorporated under the laws ofthe State of New York, U.S.A.”will be used in conspicuousrelation to the name“Commercial Travelers MutualInsurance Company” wherever itappears in the Company’scontracts, application forms,advertisements or otherpublished material, and on thecondition that if in thetransaction of its business inCanada the Company uses aFrench name, that name shall be“Compagnie MutuelleD’Assurances CommercialTravelers”. The company’sbusiness in Canada is limited tothe servicing of policies issuedprior to April 1, 1991.

Voir-Compagnie Mutuelle D’AssurancesCommercial Travelers.

Commercial Union Life Assurance Companyof Canada

300 Consilium PlaceP.O. Box 370, Station AScarborough, Ontario M1K 5C3Frank J. Crowley, President and

Chief Operating Officer.

Life, Accident and sickness. Voir-La Compagnie d’Assurance-Vie UnionCommerciale du Canada.

Commonwealth Insurance CompanySuite 1500, Bentall Three595 Burrard St.P.O. Box 49115Vancouver, British Columbia V7X 1G4John Watson, President.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Liability andSurety.

Voir-Compagnie d’assurancesCommonwealth.

See-Allianz Insurance Company of Canada. Compagnie d’Assurance Allianz du Canada10, chemin York Mills, Bureau 700Toronto (Ontario) M2P 2G5Robert E. Maynard, Président et chef

de la direction.

Biens, accidents et maladie,aériennes, automobile,chaudières et machines, crédit,détournements, fraisjuridiques,responsabilité et caution.

See-The Canada Life Assurance Company. La Compagnie d’Assurance du Canadasur la Vie

330, av. UniversityToronto (Ontario) M5G 1R8David Alexander Nield, Président et chef

de la direction.

Vie, accidents et maladie.

See-Combined Insurance Company ofAmerica.

Compagnie d’assurance Combinedd’Amérique

7300, av. WardenMarkham (Ontario) L3R 0X3Dan C. Evans, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie, à laconditionque, si la Compagnieutilise un nom français dans lesaffaires au Canada, ce nom serait« Compagnie d’assuranceCombined d’Amérique ».

See-Commonwealth Insurance Company. Compagnie d’assurances CommonwealthBureau 1500, Bentall Trois595, rue Burrard, C.P. 49115Vancouver (Colombie-Britannique)V7X 1G4John Watson, Président.

Biens, accidents et maladie,accidents d’aviation, automobile,chaudières et machines, abus deconfiance, responsabilité etcaution.

See-Coseco Insurance Company. Compagnie d’Assurance CosecoPriory Square Guelph (Ontario) N1H 6P8Terry Squire, Président et chef

de la direction.

Biens, accident et maladie,automobile et responsabilité.

See-Elite Insurance Company. La Compagnie d’Assurances Elite649, chemin North Service OuestBurlington (Ontario) L7R 4L5Mark Webb, Vice-président exécutif

et chef des opérations.

Biens, accidents et maladie,aériennes, automobile,chaudières et machines,détournements, responsabilité etcaution.

Page 42: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

10 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

See-Everest Insurance Company of Canada. La Compagnie d’Assurance Everestdu Canada

130, rue King OuestThe Exchange Tower, Bureau 2520Toronto (Ontario) M5X 1E3William G. Jonas, Président et

chef de la direction.

Biens, automobile, aériennes,chaudières et machines, crédit,détournements,grêle,responsabilité et caution.

See-Federal Insurance Company. Compagnie d’assurances FédéraleOne Financial Place1, rue Adelaide EstToronto (Ontario) M5C 2V9Janice M. Tomlinson, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,automobile, chaudières etmachines, abus de confiance,responsabilité et caution, à laconditionque, si la Compagnieutilise un nom français dans sesaffaires au Canada, ce nom serait« Compagnie d’assurancesFédérale ».

See-Grain Insurance and GuaranteeCompany.

La Compagnie d’assurance et deGarantie Grain

1240, One Lombard PlaceWinnipeg (Manitoba) R3B 0V9Ralph N. Jackson, Président.

Biens, automobile, détournements,chaudières et machines,responsabilité et caution.

See-GE Capital Casualty Company, Canada. Compagnie d’assurance GE CapitalCasualty, Canada

2023, 7495, 132e rueSurrey (Colombie-Britannique)V3W 1J8Danielle Bolduc, Président et

chef de la direction.

Biens, chaudières et machines ausein de laprovince de l’Alberta,et l’assurance degarantie desvéhicules tellequ’elle est définiepar le règlementpertinent de laprovince de l’Alberta, et caution.

See-CIBC General Insurance CompanyLimited.

Compagnie d’assurancegénéraleCIBC Limitée

3, promenade Robert SpeckBureau 500, C.P. 7065Mississauga (Ontario) L5A 4K7Dwight Lacey, Chef de la direction.

Biens, automobile, responsabilitéet caution.

See-Co-operators General InsuranceCompany.

La Compagnie d’Assurance GénéraleCo-operators

Priory Square, Guelph (Ontario) N1H 6P8Terry Squire, Président et chef

de la direction.

Biens, accidents et maladie,accidents d’aviation, automobile,chaudières et machines, crédit,frais juridiques, abus deconfiance,grêle, responsabilité etcaution.

See-CUMIS General Insurance Company. La Compagnie d’Assurance GénéraleCUMIS

C.P. 5065, Burlington (Ontario) L7R 4C2T. Michael Porter, Président et chef

de la direction.

Biens, accidents et maladie,automobile, chaudières etmachines, abus de confiance,responsabilité et caution.

See-The Dominion of Canada GeneralInsurance Company.

Compagnie d’assurancegénérale Dominiondu Canada

165, av. UniversityToronto (Ontario) M5H 3B9George L. Cooke, Président et chef

de la direction.

Biens, aériennes, automobile,chaudières et machines,détournements,grêle,responsabilité et caution.

See-Legacy General Insurance Company. Compagnie d’assurancesgénérales Legacy80, cour Tiverton, Bureau 500Markham (Ontario) L3R 0G4Aaron Hill, Vice-président et chef de

la direction.

Biens, accidents et maladie etperted’emploi.

See-Liberty Mutual Fire Insurance Company. La Compagnie d’Assurance GénéraleLiberté Mutuelle

BCE Place, Bay Wellington Tower181, rue Bay, Bureau 3320Toronto (Ontario) M5J 2T3Gery Barry, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,détournements, aériennes,automobile, chaudières etmachines, responsabilité etcaution, limitée à l’écoulementdespolices existantes, saufpourla branche automobile; etpourvuque, si la société utilise unedénomination sociale françaisedans le cadre de l’exercice deson activité au Canada, ce soit« La Compagnie d’AssuranceGénérale Liberté Mutuelle ».

Page 43: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 11

See-RBC General Insurance Company. Compagnie d’assurancegénérale RBC55,promenade City Centre, Bureau 1100Mississauga (Ontario) L5B 1M3Andrew Rogacki, Président et chef de

la direction

Biens, accident et maladie,automobile et responsabilité.

See-The Halifax Insurance Company. La Compagnie d’Assurance Halifax75, av. Eglinton EstToronto (Ontario) M4P 3A4Donald K. Lough, Président.

Biens, accidents et maladie,accidents d’aviation, automobile,chaudières et machines, abus deconfiance,grêle, responsabilité etcaution.

See-Hartford Insurance Company of Canada. Compagnie d’Assurance Hartford du Canada20, chemin York MillsWillowdale (Ontario) M2P 2C2Gray G. Davis, Président et chef

de la direction.

Biens, accidents et maladie,accidents d’aviation, automobile,chaudières et machines, abus deconfiance,grêle, responsabilité etcaution.

See-HSBC Canadian Direct InsuranceIncorporated.

La Compagnie d’Assurances HSBCCanadienne Direct Incorporée

610, rue 6e, Bureau 217New Westminster(Colombie-Britannique) V3L 3C2Guy Cloutier, Président et chef

de la direction.

Biens, automobile, accidents etmaladie et responsabilité.

See-The Mortgage Insurance Companyof Canada.

La Compagnie d’Assurance d’Hypothèquesdu Canada

100, rue Yonge, Bureau 400Toronto (Ontario) M5H 1H1Oscar Zimmerman, Président.

Détournements et caution, limitéeà l’écoulement despolicesexistantes, et hypothèque, limitéeaux affaires de réassurance.

See-GE Capital Mortgage InsuranceCompany (Canada).

Compagnie d’assurance d’hypothèquesGE Capital (Canada)

2300, boul. MeadowvaleMississauga (Ontario) L5N 5P9Peter Vukanovich, Président, chef de la

direction et chef des finances.

Hypothèque.

See-Jevco Insurance Company. La Compagnie d’Assurances Jevco2021, Union, Bureau 1150Montréal (Québec) H3A 2S9William G. Star, Président du

conseil,président et chef dela direction.

Biens, automobile, responsabilitéet caution.

See-Liberty Insurance Company of Canada. Compagnie d’Assurance Liberté du Canada200,place Consilium, 8e étageScarborough (Ontario) M1H 3E6Ronald H. Switzer, Président et chef

de la direction.

Biens, automobile etresponsabilité.

See-Liberty Mutual Insurance Company. La Compagnie d’Assurance Liberté MutuelleBCE Place, Bay Wellington Tower181, rue Bay, Bureau 3320Toronto (Ontario) M5J 2T3Gery Barry, Agentprincipal.

Biens, détournements, aériennes,accidents et maladie, automobile,chaudières et machines,responsabilité et caution.

See-Life Investors Insurance Companyof America.

Compagnie D’Assurances Life InvestorsD’Amérique

a/s John Milnes & Associates68, rue Scollard, 2e étageToronto (Ontario) M5R 1G2John R. Milnes, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie.

See-Lombard Insurance Company. Compagnie d’assurance Lombard105, rue Adelaide OuestToronto (Ontario) M5H 1P9Byron G. Messier, Chef de la direction.

Biens, aériennes, automobile,chaudières et machines, crédit,détournements,grêle,responsabilité et caution.

See-London Guarantee Insurance Company. Compagnie d’Assurance London Garantie77, rue King Ouest, Bureau 3426Royal Trust Tower, C.P. 284Toronto (Ontario) M5K 1K2Robert E. Taylor, Président.

Biens, accidents et maladie,aériennes, automobile,chaudières et machines, crédit(sous réserveque lapersonne àqui le crédit est accordé soitprésente au Canada),détournements, fraisjuridiques,titres,grêle, responsabilité etcaution.

Page 44: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

12 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

See-The Missisquoi Insurance Company. La Compagnie d’Assurance Missisquoi625, boul. René-Lévesque OuestBureau 600Montréal (Québec) H3B 1R2Jean P. Courtemanche, Président.

Biens, automobile, chaudières etmachines, abus de confiance,responsabilité et caution.

See-New York Life Insurance Company. Compagnie d’assurances New York LifeScotia Plaza, Bureau 210040, rue King OuestToronto (Ontario) M5H 3C2J. Brian Reeve, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie, à laconditionque, si la compagnieutilise un nom français dans lesaffaires au Canada, ce nom serait« Compagnie d’assurances NewYork Life ».

See-Quebec Assurance Company. Compagnie d’Assurance du Québec3500, boul. de Maisonneuve Ouest2, place Alexis-Nihon, Bureau 800Montréal (Québec) H3Z 3C1Robert John Gunn, Président.

Biens, accidents et maladie,aériennes, automobile,chaudières et machines,responsabilité, détournements etcaution.

See-St. Paul Fire and Marine InsuranceCompany.

La Compagnie d’Assurance Saint Paul121, rue King OuestBureau 1200, C.P. 93Toronto (Ontario) M5H 3T9Wayne McKellar Edmondson, Agent

principal.

Biens, aériennes, automobile,chaudières et machines,détournements, responsabilité etcaution, à la conditionquelorsque la société utilise un nomfrançais dans l’exercice de sesactivités au Canada, ce nom soit« La Compagnie d’AssuranceSaint Paul ».

See-The Standard Life Assurance Company. Compagnie d’assurance Standard Life1245, rue Sherbrooke OuestMontréal (Québec) H3G 1G3Claude A. Garcia, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie, et lacompagnie peut utiliser dans lesaffaires au Canada son nom enanglais « The Standard LifeAssurance Company » ou sonnom en français « Compagnied’assurance Standard Life », outous deux à la fois.

See-The Standard Life Assurance Companyof Canada.

Compagnie d’assurance Standard Lifedu Canada

1245, rue Sherbrooke OuestMontréal (Québec) H3G 1G3Claude A. Garcia, Président et

chef des opérations.

Vie.

See-Temple Insurance Company. La compagnie d’assurance Temple390, rue Bay, Bureau 2300Toronto (Ontario) M5H 2Y2John P. Phelan, Président et chef

de la direction.

Biens, accidents et maladie,aériennes, automobile,chaudières et machines, crédit,détournements,grêle, fraisjuridiques, responsabilité etcaution.

See-Traders General Insurance Company. Compagnie d’Assurance Traders Générale2206, av. Eglinton Est, Bureau 500Scarborough (Ontario) M1L 4S8Mark Webb, Vice-président exécutif

et chef des opérations.

Biens, accidents et maladie,aériennes, automobile,chaudières et machines,détournements,grêle, fraisjuridiques, responsabilité etcaution.

See-Trafalgar Insurance Companyof Canada.

Compagnie d’Assurance Trafalgardu Canada

10, chemin York Mills, Bureau 700Toronto (Ontario) M2P 2G3Robert E. Maynard, Président et

chef de la direction.

Biens, accidents et maladie,automobile, chaudières etmachines et responsabilité.

See-Transit Insurance Company. La Compagnie d’Assurance Transit5310,promenade Explorer, Bureau 201Mississauga (Ontario) L4W 5H9William Star, Président.

Biens, automobile etresponsabilité, limitée àl’administration despolicesexistantes.

See-AIG Life Insurance Company of Canada. La Compagnie d’Assurance-Vie AIGdu Canada

145, rue Wellington Ouest, 8e étageToronto (Ontario) M5J 2T4Ralph J. Gaudio, Président et chef

de la direction.

Vie, accidents et maladie.

Page 45: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 13

See-CIBC Life Insurance Company Limited. Compagnie d’assurance-vie CIBC Limitée3, promenade Robert SpeckBureau 500, C.P. 7065Mississauga (Ontario) L5A 4K7Gabor Kalmar, Président et chef

des opérations.

Vie, accidents et maladie.

See-CNA Life Insurance Company ofCanada.

Compagnie d’Assurance-Vie CNAdu Canada

40, rue Weber Est, 7e étageKitchener (Ontario) N2H 6R3Robert D. Scott, Président et

chef de la direction.

Vie, accidents et maladie etperted’emploi.

See-Blue Cross Life Insurance Companyof Canada.

Compagnie d’Assurance-Vie Croix Bleuedu Canada

C.P. 220, 644, rue MainMoncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8L3Pierre-Yves Julien, Président et chef

de la direction.

Vie, accidents et maladie.

See-CUMIS Life Insurance Company. La Compagnie d’Assurance-Vie CUMISC.P. 5065, 151, rue North ServiceBurlington (Ontario) L7R 4C2T. Michael Porter, Président et chef

de la direction.

Vie, accidents et maladie dans lamesure où son acte deconstitution en corporationl’autorise.

See-Federated Life Insurance Companyof Canada.

La Compagnie d’Assurance-Vie Federateddu Canada

717, av. Portage, C.P. 5800Winnipeg (Manitoba) R3C 3C9John M. Paisley, Président.

Vie, accidents et maladie.

See-Household Life Insurance Company. Compagnie d’Assurance-Vie HouseholdPlace Marois,3268, boul. Saint-Martin OuestLaval (Québec) H7T 1A1Jennifer Vinet, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie, à laconditionque lorsque la sociétéutilise un nom français dansl’exercice de ses activitiés auCanada, ce nom soit« Compagnie d’Assurance-VieHousehold ».

See-J.C. Penney Life Insurance Company. Compagnie d’assurance-vie J.C. Penney80, Tiverton Court, Bureau 500Markham (Ontario) L3R 0G4Isaac Sananes, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie.

See-John Alden Life Insurance Company. La Compagnie D’Assurance-Vie John Alden1145, chemin Nicholson, Unité 2Newmarket (Ontario) L3Y 7V1Colleen Sexsmith, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie, à laconditionque, si la Compagnieutilise un nom français dans sesaffaires au Canada, ce nom serait« La CompagnieD’Assurance-Vie John Alden ».Les affaires de la compagnie sontlimitées à l’écoulement despolices émises avant le1er avril 1991.

See-Liberty Life Assurance Companyof Boston.

La Compagnie d’Assurance-Vie Libertéde Boston

BCE Place, Bay Wellington Tower181, rue Bay, Bureau 3320Toronto (Ontario) M5J 2T3Gery Barry, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie.

See-The Manufacturers Life InsuranceCompany.

La Compagnie d’Assurance-VieManufacturers

200, rue Bloor EstToronto (Ontario) M4W 1E5Dominic D’Alessandro, Président

et chef de la direction.

Vie, accidents et maladie.

See-MIC Life Insurance Corporation. La Compagnie d’Assurance-Vie MICC.P. 6000, 8500, rue Leslie, Bureau 400Thornhill (Ontario) L3T 4S5Charles W. Hastings, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie, limitée àla gestion despolices émisesavant le 1er janvier 1997 et sur laconditionque lorsque la sociétéétrangère utilise un nom françaisdans l’exercice de ses activitésau Canada, ce nom soit « LaCompagnie d’Assurance-VieMIC ».

Page 46: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

14 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

See-Minnesota Life Insurance Company Compagnie d’Assurance-vie Minnesotaa/s McLean & Kerr130, rue Adelaide Ouest, Bureau 2800Toronto (Ontario) M5H 3P5Robin B. Cumine, C.R., Agentprincipal.

Vie, pourvuque, si la sociétéétrangère utilise unedénomination sociale françaisedans le cadre de l’exercise de sonactivité au Canada, ce soit« Compagnie d’Assurance-vieMinnesota ».

See-The North West Life AssuranceCompany of Canada.

La Compagnie d’Assurance-Vie North Westdu Canada

2165, Broadway Ouest, C.P. 5900Vancouver (Colombie-Britannique)V6B 5H6Douglas A. Carrothers, Vice-président,

conseilgénéral et secrétaire.

Vie, accidents corporels etmaladie.

See-Penncorp Life Insurance Company. La Compagnie D’Assurance Vie Penncorp90, rue Dundas Ouest, Bureau 400Mississauga (Ontario) L5B 2T5J. Paul Edmondson, Président et chef

de la direction.

Vie, accidents et maladie.

See-Canadian Premier Life InsuranceCompany.

Compagnie d’assurance-vie Premièredu Canada.

80, Tiverton Court, Bureau 500Markham (Ontario) L3R 0G4Aaron Hill, Vice-président et chef

de la direction.

Vie, accidents et maladie.

See-Primerica Life Insurance Companyof Canada.

La Compagnie d’Assurance-Vie Primericadu Canada

2000, chemin Argentia,Plaza V, Bureau 300Mississauga (Ontario) L5N 2R7Glenn J. Williams, Vice-président

exécutif et chef de la direction.

Vie, accidents et maladie.

See-Principal Life Insurance Company. Compagnie d’assurance-vie Principal68, rue Scollard, 2e étageToronto (Ontario) M5R 1G2John Milnes, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie,pourvuque, si la société étrangère utiliseune dénomination socialfrançaise dans le cadre del’exercise de son activité auCanada, ce soit « Compagnied’assurance-vie Principal ».

See-RBC Life Insurance Company. Compagnie d’assurance vie RBC55,promenade City Centre, Bureau 1100Mississauga (Ontario) L5B 1M3W. Grant Hardy, Président et chef de

la direction.

Vie, accidents et maladie.

See-ReliaStar Life Insurance Company. Compagnie D’Assurance-Vie ReliaStar3650, av. Victoria Park, Bureau 201North York (Ontario) M2H 3P7V. Lorraine Williams, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie, limitéeaux affaires de réassurance, lasociété étrangèrepeut égalementsouscrire despolices d’assurancesur la vie de résidents du Canadaassurés en vertu depolicescollectives émises auxÉtats-Unis, et à la conditionquesi la société étrangère utilise unnom français, ce nom serait« Compagnie D’Assurance-VieReliaStar ».

See-Seaboard Life Insurance Company. Compagnie d’Assurance-vie Seaboard2165, Broadway Ouest, C.P. 5900Vancouver(Colombie-Britannique) V6B 5H6Robert T. Smith, Président et chef

de la direction.

Vie, accidents et maladie, limitée àla gestion despolices émisesavant le 31 mai 1999.

See-Transamerica Life Insurance Companyof Canada.

Compagnie d’Assurance-Vie Transamericadu Canada

300,place ConsiliumScarborough (Ontario) M1H 3G2George A. Foegele, Président et chef

de la direction.

Vie, accidents et maladie.

Page 47: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 15

See-Commercial Union Life AssuranceCompany of Canada.

La Compagnie d’Assurance-Vie UnionCommerciale du Canada

300,place ConsiliumC.P. 370, Succursale AScarborough (Ontario) M1K 5C3Frank J. Crowley, Président et chef

des opérations.

Vie, accidents et maladie.

See-Union Fidelity Life Insurance Company. Compagnie d’Assurance-Vie Union Fidelity200, rue Wellington OuestC.P. 166, Bureau 400Toronto (Ontario) M5V 3C7Alan K. Ryder, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie,limitée àla gestion despolices émisesavant le 1er janvier 1999.

See-The Wawanesa Life InsuranceCompany.

La Compagnie d’Assurance-vie Wawanesa191, BroadwayWinnipeg (Manitoba) R3C 3P1G. J. Hanson, Président et chef

de la direction.

Vie, accidents et maladie.

See-Voyageur Insurance Company. Compagnie d’Assurance Voyageur44,promenade centre Peel, Bureau 300Brampton (Ontario) L6T 4M8Walter Schutte, Président et chef

de la direction.

Biens, accidents et maladie.

See-Wellington Insurance Company. Compagnie d’Assurance WellingtonOne Concord GateDon Mills (Ontario) M3C 3N6Yves Brouillette, Président et chef

de la direction.

Biens, accidents et maladie,aériennes, automobile,chaudières et machines,détournements,grêle,perted’emploi, responsabilité etcaution.

See-Zenith Insurance Company. Compagnie d’assurance Zenitha/s Lombard Canada Ltd.105, rue Adelaide OuestToronto (Ontario) M5H 1P9Byron G. Messier, Président et chef

de la direction.

Biens, automobile etresponsabilité.

See-Lombard General Insurance Companyof Canada.

Compagnie canadienne d’assurancesgénérales Lombard

105, rue Adelaide OuestToronto (Ontario) M5H 1P9Byron G. Messier, Chef de la direction.

Biens, aériennes, automobile,chaudières et machines, crédit,détournements,grêle,responsabilité et caution.

See-Alta Surety Company. La Compagnie de Cautionnement Alta800, boul. René-Lévesque OuestBureau 2795Montréal (Québec) H3B 1X9Aram Semerjian, Président.

Détournements et caution, limitéeà l’administration despolicesexistantes.

See-Northern Indemnity, Inc. La Compagnie d’Indemnité du Nord, Inc.2, rue Bloor ouest, Bureau1500Toronto (Ontario) M4W 3E2Robert Lamendola, Président.

Biens, responsabilité,détournements et caution.

See-The Boiler Inspection and InsuranceCompany of Canada.

La Compagnie d’Inspection et d’AssuranceChaudières et Machinerie

18, rue King EstToronto (Ontario) M5C 1C4Hans A. Schols, Président et

directeurgénéral.

Biens, chaudières et machines etresponsabilité.

See-Maryland Casualty Company. Compagnie Maryland Casualtya/s Lavery, DeBilly, Avocats1, place Ville Marie, 40e étageMontréal (Québec) H3B 4M4Pierre Caron, Agentprincipal.

Biens, abus de confiance, accidentset maladie, accidents d’aviation,automobile, caution, chaudièreset machines et responsabilité, àla conditionque, si laCompagnie utilise un nomfrançais dans ses affaires auCanada, ce nom serait« Compagnie MarylandCasualty », limitée àl’administration despolicesexistantes.

Page 48: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

16 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

See-Commercial Travelers MutualInsurance Company.

Compagnie Mutuelle D’AssurancesCommercial Travelers

(Incorporée sous les lois de l’étatde New York,É.-U.A.)

8, place RanchwoodBrampton (Ontario) L6R 1W5William C. Jorgens, Agentprincipal.

Accidents et maladie, à conditionque les mots « constituée envertu des lois de l’État de NewYork, É.-U. d’Amérique » soientplacés bien en évidenceparrapport au nom « CommercialTravelers Mutual InsuranceCompany » partout où ce nom setrouve dans les contrats,formules deproposition,annonces et autres documentspubliéspar la Compagnie, et à laconditionque, si la Compagnieutilise un nom français dans sesaffaires au Canada, ce nom serait« Compagnie MutuelleD’Assurances CommercialTravelers ». Les affaires de lacompagnie sont limitées àl’écoulement despolices émisesavant le 1er avril 1991.

See-Chancellor Reinsurance Company ofCanada.

La Compagnie de Réassurance Chancellordu Canada.

Bureau 2000, Oceanic Plaza1066, rue West HastingsVancouver(Colombie-Britannique) V6E 3X2Robert Rusko, AgentKPMG Comptables AgréésMandataire du surintendant desinstitutions financières, liquidateurprovisoire.

Biens, accidents et maladie,accidents d’aviation, automobile,chaudières et machines, crédit,abus de confiance,grêle, fraisjuridiques, responsabilité etcaution, limitée aux affaires deréassurance. Depuis le 5juillet1995, La Compagnie deRéassurance Chancellor duCanada fait l’objet d’uneprocédure volontaire deliquidation et de dissolution sousla supervision des tribunaux, envertu de laLoi sur les sociétésd’assurances. La firme KPMGComptables Agréés a éténommée liquidateur de la sociétéen vertu d’une ordonnance dutribunal.

See-Suecia Reinsurance Company Compagnie de réassurance Suecia18, rue King Est, Bureau 1402Toronto (Ontario) M5C 1C4J. Leo Daly, Président.

Biens, accidents et maladie,aériennes, automobile,chaudières et machines,détournements,grêle,responsabilité et caution, limitéeaux affaires de réassurance, et àl’écoulement despolicesexistantes.

See-The Toa Reinsurance Company ofAmerica.

La Compagnie de réassurance Toad’Amérique.

Une rue Queen Est, Bureau 2606Toronto (Ontario) M5C 2W5David E. Wilmot, Agentprincipal

Biens, accidents et maladie,automobile, chaudières etmachines, crédit, détournements,grêle, responsabilité et caution,limitée aux affaires deréassurance etpourvuque, si lasociété utilise une dénominationsociale française dans le cadre del’exercise de son activité auCanada, ce soit « La Compagniede réassurance Toad’Amérique ».

See-Swiss Reinsurance Company Canada. Compagnie Suisse de Réassurance Canada150, rue King OuestC.P. 50, Bureau 2200Toronto (Ontario) M5H 1J9Patrick Mailoux, Président and chef

de la direction.

Biens, accidents et maladie,aériennes, automobile,chaudières et machines, crédit,détournements,grêle, fraisjuridiques, responsabilité,hypothèque et caution, limitéeaux affaires de réassurance.

See-Western Surety Company. La Compagnie de Sûreté de l’OuestC.P. 527, 1874, rue Scarth, 20e étageRegina (Saskatchewan) S4P 2G8L. C. Ell, Président.

Détournements et caution.

Page 49: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 17

See-Virginia Surety Company, Inc. Compagnie de sûreté Virginia Inc.7300, av. Warden, Bureau 300Markham (Ontario) L3R 0X3Dan C. Evans, Agentprincipal.

Biens, automobile, chaudières etmachines et responsabilité, à laconditionque lorsque la sociétéutilise un nom français dansl’exercice de ses activités auCanada, ce nom soit« Compagnie de sûreté VirginiaInc. ».

CompCorp Life Insurance Company1 Queen Street East, Suite 1700Toronto, Ontario M5C 2X9Gordon M. Dunning, President and

Chief Executive Officer.

Life, Accident and sickness, to theextent authorized by itsincorporating instrument.

Voir-Société d’assurance vie SIAP

Concordia Life Insurance Company2 St. Clair Ave. East, 6th FloorToronto, Ontario M4T 2V6Christopher H. McElvaine, President and

Chief Executive Officer.

Life, Accident and sickness. Concordia compagnie d’assurance-vie2, av. St. Clair Est, 6e étageToronto (Ontario) M4T 2V6Christopher H. McElvaine, Président et

chef de la direction.

Vie, accidents et maladie.

Confederation Life Insurance Company800 Bay Street, 8th FloorToronto, Ontario M5S 3A9Robert O. Sanderson, President,

KPMG Inc.Agent for the Superintendent of

Financial Institutions, ProvisionalLiquidator.

Life, Personal accident andSickness.On August 11, 1994 theSuperintendent of FinancialInstitutions took control ofConfederation Life InsuranceCompany and the courtgranted awinding-up order appointing theSuperintendent asprovisionalliquidator of the company. Thecourt subsequently appointedKPMG Inc. aspermanentliquidator. The winding up of thecompany’s business and affairscontinues.

La Confédération, Compagnied’Assurance-Vie

800, rue Bay, 8e étageToronto (Ontario) M5S 3A9Robert O. Sanderson,

Président KPMG Inc.Mandataire du surintendant des

institutions financières, liquidateurprovisoire.

Vie, accidents corporels etmaladie.Le 11 août 1994, le surintendantdes institutions financières aprisle contrôle de La Confédération,Compagnie d’Assurance-Vie etla cour accordait une ordonnancede liquidation nommant lesurintendant au titre deliquidateurprovisoire de lasociété. La cour apar la suitedésigné la firme KPMG Inc. àtitre de liquidateurpermanent.La liquidation des opérations etdes affaires de la société sepoursuivent.

Connecticut General Life InsuranceCompany

55 Town Centre CourtP.O. Box 14, Suite 606Scarborough, Ontario M1P 4X4M. E. Hassan, Chief Agent.

Life, Personal accident andSickness.

Connecticut General Life InsuranceCompany

55, cour Town CentreBureau 606, C.P. 14Scarborough (Ontario) M1P 4X4M. E. Hassan, Agentprincipal.

Vie, accidents corporels etmaladie.

Constitution Insurance Company of Canada500 University Ave., 4th FloorToronto, Ontario M5G 1V9Frank DiTomasso, President.

Property, Accident and sickness,Automobile, Fidelity, Legalexpense, Liability and Surety,limited to the servicing ofexisting policies.

Constitution du Canada, Compagnied’Assurance

500, av. University, 4e étageToronto (Ontario) M5G 1V9Frank DiTomasso, Président.

Biens, accidents et maladie,automobile, détournements, fraisjuridiques, responsabilité etcaution, limitée à l’écoulementdespolices existantes.

Continental Assurance Company40 Weber Street East, 7th FloorKitchener, Ontario N2H 6R3Robert D. Scott, Chief Agent.

Life, Accident and sickness,limited to the servicing ofpolicies issuedprior toJanuary 1, 1999.

Continental Assurance Company40, rue Weber Est, 7e étageKitchener (Ontario) N2H 6R3Robert D. Scott, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie, limitée àla gestion despolices émisesavant le 1er janvier 1999.

Continental Casualty Company105 Adelaide Street WestToronto, Ontario M5H 1P9Charles R. Lawrence, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Credit, Fidelity, Hail,Liabilit y and Surety.

Continental Casualty Company105, rue Adelaide OuestToronto (Ontario) M5H 1P9Charles R. Lawrence, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,aériennes, automobile,chaudières et machines, crédit,détournements,grêle,responsabilité et caution.

The Continental Insurance Company105 Adelaide Street WestToronto, Ontario M5H 1P9Charles R. Lawrence, Chief Agent.

Property, Aircraft, Automobile,Boiler and machinery, Credit,Fidelity, Hail, Liability andSurety.

The Continental Insurance Company105, rue Adelaide OuestToronto (Ontario) M5H 1P9Charles R. Lawrence, Agentprincipal.

Biens, accidents d’aviation,automobile, chaudières etmachines, crédit, abus deconfiance, responsabilité etcaution.

Co-operators General Insurance CompanyPriory Square, Guelph, Ontario N1H 6P8Terry Squire, President and

Chief Executive Officer.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Credit, Legalexpense, Fidelity, Hail, Liabilityand Surety.

Voir-La Compagnie d’Assurance GénéraleCo-operators

Co-operators Life Insurance CompanyPriory Square, Guelph, Ontario N1H 6P8Terry Squire, President and Chief

Executive Officer.

Life, Accident and sickness. Co-operators, Compagnie d’Assurance-ViePriory Square, Guelph (Ontario) N1H 6P8Terry Squire, Président et chef

de la direction.

Vie, accidents et maladie.

Page 50: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

18 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

Coseco Insurance CompanyPriory Square Guelph, Ontario N1H 6P8Terry Squire, President and Chief

Executive Officer.

Property, Accident and sickness,Automobile and Liability.

Voir-Compagnie d’Assurance Coseco

See-Canada Life Financial Corporation Corporation Financière Canada-Vie330, av. UniversityToronto (Ontario) M5G 1R8David Nield, Président et chef

de la direction.

Vie

Crown Life Insurance Company1874 Scarth Street, Suite 1900Regina, Saskatchewan S4P 4B3Brian A. Johnson, President and

Chief Executive Officer.

Life, Accident and sickness. Crown, compagnie d’assurance-vie1874, rue Scarth, Bureau 1900Regina (Saskatchewan) S4P 4B3Brian A. Johnson, Président et chef

de la direction.

Vie, accidents et maladie.

CT Direct Insurance Inc.2161 Yonge Street, 4th FloorToronto, Ontario M4S 3A6Alain Thibault, Chief Operating Officer.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Liability andSurety.

CT assurance directe inc.2161, rue Yonge, 4e étageToronto (Ontario) M4S 3A6Alain Thibault, Chef de l’exploitation.

Biens, accidents et maladie,aériennes, automobile,chaudières et machines,détournements, responsabilité etcaution.

CUMIS General Insurance CompanyP.O. Box 5065Burlington, Ontario L7R 4C2T. Michael Porter, President and

Chief Executive Officer.

Property, Accident and sickness,Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Liability andSurety.

Voir-La Compagnie d’Assurance GénéralCUMIS

CUMIS Life Insurance CompanyP.O. Box 5065, 151 North Service RoadBurlington, Ontario L7R 4C2T. Michael Porter, President and

Chief Executive Officer.

Life, Accident and sickness to theextent authorized by itsinstrument of incorporation.

Voir-La Compagnie d’Assurance-VieCUMIS

CUNA Mutual Insurance SocietyP.O. Box 5065, 151 North Service RoadBurlington, Ontario L7R 4C2T. Michael Porter, Chief Agent.

Life, Accident and sickness,limited to the writing ofinsurance on the members ofcredit unions, and the Companymay use in the transaction of itsbusiness in Canada its name inEnglish “CUNA MutualInsurance Society” or its name inFrench “La Société d’AssuranceCUNA Mutuelle”, or both ofsuch names.

Voir-La Société d’Assurance CUNAMutuelle

The Dominion Life Assurance Company200 Bloor St. East, North Tower 10Toronto, Ontario M4W 1E5Ian Beverly, Provisional Liquidator.

Life insurance, limited to theservicing of policies issuedpriorto January 1, 1986.

La Dominion, Compagnie d’Assurancesur la Vie

200, rue Bloor Est, North Tower 10Toronto (Ontario) M4W 1E5Ian Beverly, Liquidateur

provisoire.

Vie, sous réserve de la restrictionque les affaires de la compagniesoient limitées à l’écoulementdespolices émises avant le1er janvier 1986.

The Dominion of Canada GeneralInsurance Company

165 University Ave.Toronto, Ontario M5H 3B9George L. Cooke, President and

Chief Executive Officer.

Property, Aircraft, Automobile,Boiler and machinery, Fidelity,Hail, Liability and Surety.

Voir-Compagnie d’assurancegénéraleDominion du Canada

Eagle Star Insurance Company Limitedc/o Focus Group Inc.36 King Street East, Suite 500Toronto, Ontario M5C 1E5P. H. Cook, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Liability andSurety.

Eagle Star Insurance Company Limiteda/s Focus Group Inc.36, rue King Est, Bureau 500Toronto (Ontario) M5C 1E5P. H. Cook, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,accidents d’aviation, automobile,chaudières et machines, abus deconfiance, responsabilité etcaution.

Ecclesiastical Insurance Office PublicLimited Company

Box 2401, Suite 502, 2300 Yonge St.Toronto, Ontario M4P 1E4Stephen Malcolm Oxley, Chief Agent.

Property, Automobile, Boiler andMachinery, Fidelity and Liabilityon the condition that if in thetransaction of its business inCanada the Company uses aFrench name, that name shall be“Société des AssurancesÉcclésiastiques”.

Voir-Société des AssurancesÉcclésiastiques

Echelon General Insurance CompanyPriory SquareGuelph, Ontario N1H 6P8Terry Squire, President and Chief

Executive Officer.

Property, Automobile andLiabilit y.

Échelon, Compagnie D’Assurances GénéralePriory SquareGuelph (Ontario) N1H 6P8Terry Squire, Président et chef

de la direction.

Biens, automobile etresponsabilité.

Page 51: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 19

Economical Mutual Insurance CompanyP.O. Box 2000111 Westmount Road SouthWaterloo, Ontario N2J 4S4Noel G. Walpole, President and Chief

Executive Officer.

Property, Accident and sickness,Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Liability andSurety.

Economical, Compagnie Mutuelled’Assurance

C.P. 2000111, chemin Westmount SudWaterloo (Ontario) N2J 4S4Noel G. Walpole, Président et chef

de la direction.

Biens, accidents et maladie,automobile, chaudières etmachines, détournements,responsabilité et caution.

Elite Insurance Company649 North Service Road WestBurlington, Ontario L7R 4L5Mark Webb, Executive Vice President and

Chief Operating Officer.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Liability andSurety.

Voir-La Compagnie d’Assurances Elite

The Empire Life Insurance Company259 King Street EastKingston, Ontario K7L 3A8Christopher H. McElvaine, President and

Chief Executive Officer.

Life, Accident and sickness. L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie259, rue King EstKingston (Ontario) K7L 3A8Christopher H. McElvaine, Président et

chef de la direction.

Vie, accidents et maladie.

Employers Insurance of Wausaua Mutual Company

c/o D. M. Williams & Associates Ltd.3650 Victoria Park Ave., Suite 201North York, Ontario M2H 3P7V. Lorraine Williams, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Liability andSurety on the condition that if inthe transaction of its business inCanada the Company uses aFrench name, that name shall be“Société d’assurance mutuelledes employeurs de Wausau”.

Voir-Société d’assurance mutuelle desemployeurs de Wausau

Employers Reassurance Corporation200 Wellington Street West, Suite 400P.O. Box 166Toronto, Ontario M5V 3C7Alan Ryder, Chief Agent.

Life, Accident and sickness,limited to the business ofreinsurance.

Employers Reassurance Corporation200, rue Wellington OuestBureau 400, C.P. 166Toronto (Ontario) M5V 3C7Alan Ryder, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie, limitéeaux affaires de réassurance.

Employers Reinsurance Corporation200 Wellington Street West, Suite 1400P.O. Box 166Toronto, Ontario M5V 3C7Peter Borst, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Credit, Fidelity,Liabilit y and Surety.

Employers Reinsurance Corporation200, rue Wellington OuestBureau 1400, C.P. 311Toronto (Ontario) M5V 3C7Peter Borst, Agentprincipal.

Biens, abus de confiance, accidentsd’aviation, accidents et maladie,automobile, caution, chaudièreset machines, crédit etresponsabilité.

The Equitable General Insurance Company2475 Laurier Blvd., P.O. Box 4700Sillery, Quebec G1V 4E4John Arbour, President and Chief

Executive Officer.

Property, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Liability andSurety, limited to the servicing ofexisting policies.

L’ Équitable, Compagnie d’AssurancesGénérales

2475, boul. Laurier, C.P. 4700Sillery (Québec) G1V 4E4John Arbour, Président et chef

de la direction.

Biens, automobile, chaudières etmachines, abus de confiance,responsabilité et caution, limitéeà l’écoulement despolicesexistantes.

The Equitable Life Assurance Society ofthe United States

55 Town Centre CourtP.O. Box 14, Suite 606Scarborough, Ontario M1P 4X4M. E. Hassan, Chief Agent.

Life, Personal accident andSickness.

The Equitable Life Assurance Society ofthe United States

55, cour Town CentreC.P. 14, Bureau 606Scarborough (Ontario) M1P 4X4M. E. Hassan, Agentprincipal.

Vie, accidents corporels etmaladie.

The Equitable Life Insurance Companyof Canada

1 Westmount Rd. NorthWaterloo, Ontario N2J 4C7Ron Beaubien, President and

Chief Executive Officer.

Life, Personal accident andSickness.

L’ Équitable Compagnie d’Assurance-Viedu Canada

1, chemin Westmount NordWaterloo (Ontario) N2J 4C7Ron Beaubien, Président et chef

de la direction.

Vie, accidents corporels etmaladie.

ERC Frankona Rückversicherungs-Aktien-Gesellschaft

Life Branch200 Wellington Street WestSuite 400, P.O. Box 166Toronto, Ontario M5V 3C7Alan K. Ryder, Chief Agent.

Property and Casualty Branch20 Richmond St. East, Suite 330Toronto, Ontario M5C 2R9Brian Frederick Maltman, Chief Agent.

Life, Property, Accident andsickness, Aircraft, Automobile,Boiler and machinery, Credit,Fidelity, Hail, Liability andSurety, limited to the business ofreinsurance.

ERC Frankona Rückversicherungs-Aktien-Gesellschaft

Vie200, rue Wellington OuestBureau 400, C.P. 166Toronto (Ontario) M5V 3C7Alan K. Ryder, Agentprincipal.

Biens et risques divers20, rue Richmond Est, Bureau 330Toronto (Ontario) M5C 2R9Brian Frederick Maltman, Agentprincipal.

Vie, biens, accidents et maladie,aériennes, automobile,chaudières et machines, crédit,détournements,grêle,responsabilité et caution, limitéeaux affaires de réassurance.

EULER American Credit IndemnityCompany

1155 René-Lévesque Blvd. West,Suite 1702, CIBCTowerMontreal, Quebec H3B 3Z7Robert Labelle, Chief Agent.

Credit. EULER American Credit IndemnityCompany

1155, boul. René-Lévesque OuestBureau 1702, Tour CIBCMontréal (Québec) H3B 3Z7Robert Labelle, Agentprincipal.

Crédit.

Page 52: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

20 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

Everest Insurance Company of Canada130 King Street WestThe Exchange Tower, Suite 2520Toronto, Ontario M5X 1E3William G. Jonas, President

and Chief Executive Officer.

Property, Automobile, Aircraft,Boiler and machinery, Credit,Fidelity, Hail, Liability andSurety.

Voir-La Compagnie d’Assurance Everest duCanada

Everest Reinsurance Company130 King Street WestThe Exchange Tower, Suite 2520Toronto, Ontario M5X 1E3William G. Jonas, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Credit, Fidelity, Hail,Liabilit y and Surety, limited tothe business of reinsurance.

Everest Reinsurance Company130, rue King OuestThe Exchange Tower, Bureau 2520Toronto (Ontario) M5X 1E3William G. Jonas, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,aériennes, automobile,chaudières et machines, crédit,détournements,grêle,responsabilité et caution, limitéeaux affaires de réassurance.

Factory Mutual Insurance Company165 Commerce Valley Drive West,Suite 500Thornhill, Ontario L3T 7V8Perry Brazeau, Chief Agent.

Property, Boiler and machinery,Fidelity, Liability and Surety.

Factory Mutual Insurance Company165,promenade Commerce Valley Ouest,Bureau 500Thornhill (Ontario) L3T 7V8Perry Brazeau, Agentprincipal.

Biens, chaudières et machines,détournements, responsabilité etcaution.

Federal Insurance CompanyOne Financial Place1 Adelaide Street EastToronto, Ontario M5C 2V9Janice M. Tomlinson, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Liability andSurety, on the condition that if inthe transaction of its business inCanada the company uses aFrench name, that name shall be“Compagnie d’assurancesFédérale”.

Voir-Compagnie d’assurances Fédérale

Federated Insurance Company of CanadaP.O. Box 5800, 717 Portage Ave.Winnipeg, Manitoba R3C 3C9John M. Paisley, President.

Property, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Liability andSurety.

La Federated, Compagnie d’Assurancedu Canada

C.P. 5800, 717, av. PortageWinnipeg (Manitoba) R3C 3C9John M. Paisley, Président.

Biens, automobile, chaudières etmachines, abus de confiance,responsabilité et caution.

Federated Life Insurance Companyof Canada

717 Portage Avenue, P.O. Box 5800Winnipeg, Manitoba R3C 3C9John M. Paisley, President.

Life, Accident and sickness. Voir-La Compagnie d’Assurance-VieFederated du Canada

Federation Insurance Company of Canada1000 de la Gauchetière Street WestSuite 500Montréal, Quebec H3B 4W5W. J. Green, President.

Property, Automobile, Boiler andmachinery, Legal expense,Fidelity, Hail, Liability andSurety.

La Fédération Compagnie d’Assurancesdu Canada

1000, rue de la Gauchetière OuestBureau 500Montréal (Québec) H3B 4W5W. J. Green, Président.

Biens, automobile, chaudières etmachines, fraisjuridiques,détournements,grêle,responsabilité et caution.

Financial Life Assurance Companyof Canada

10 Four Seasons Place, 10th FloorP.O. Box 335Etobicoke, Ontario M9C 4V3Hugh D. Haney, President.

Life, Accident and sickness. Financial du Canada, Compagnied’Assurance-Vie

10 Four Seasons Place, 10e étageC.P. 335Etobicoke (Ontario) M9C 4V3Hugh D. Haney, Président.

Vie, accidents et maladie.

See-Sun Life Financial Services ofCanada Inc.

Financière Sun Life du Canada inc.150, rue King OuestToronto (Ontario) M5H 1J9Donald A. Stewart, Président du conseil

et chef de la direction

Vie.

First Allmerica Financial Life InsuranceCompany

40 King St. WestScotia Plaza, Suite 2100Toronto, Ontario M5H 3C2J. Brian Reeve, Chief Agent.

Life, Accident and sickness,limited to the servicing ofpolicies issuedprior toJune 1, 1992.

First Allmerica Financial Life InsuranceCompany

40, rue King OuestScotia Plaza, Bureau 2100Toronto (Ontario) M5H 3C2J. Brian Reeve, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie, sousréserve de la restrictionque lesaffaires de la compagnie soientlimitées à l’écoulement despolices émises avant le1er juin 1992.

First American Title Insurance Company1290 Central Parkway West, Suite 801Mississauga, Ontario L5C 4R3Tom Grifferty, Chief Agent.

Title. First American Title Insurance Company1290,promenade Central OuestBureau 801Mississauga (Ontario) L5C 4R3Tom Grifferty, Agentprincipal.

Titres.

First National Insurance Companyof America

c/o Fasken, Campbell, GodfreyP.O. Box 20, Toronto-Dominion CentreToronto-Dominion BankTowerToronto, Ontario M5K 1N6Robert M. Sutherland, Chief Agent.

Property, Automobile, Fidelity,Liabilit y and Surety, limited tothe servicing of existing policies.

First National Insurance Companyof America

a/s Fasken, Campbell, GodfreyC.P. 20, Toronto-Dominion BankTowerToronto-Dominion CentreToronto (Ontario) M5K 1N6Robert M. Sutherland, Agentprincipal.

Biens, automobile, abus deconfiance, responsabilité etcaution, limitée àl’administration despolicesexistantes.

Page 53: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 21

First North American Insurance Company5650 Yonge St.North York, Ontario M2M 4G4Dominic D’Alessandro, President and

Chief Executive Officer.

Accident and sickness, Propertylimited to job loss insurance,baggage insurance, merchandiserepair and replacementinsurance, and credit cardinsurance arising from massmarketing initiatives, andAutomobile limited toindemnification of credit cardholders insured under agrouppolicy in respect of collisiondamage waivers.

Voir-La Nord-américaine,premièrecompagnie d’assurance

Folksamerica Reinsurance Company80 Bloor Street West, Suite 1202Toronto, Ontario M5S 2V1James M. Willis, Chief Agent.

Property, Automobile, Fidelity,Hail, Liability and Surety,limited to the business ofreinsurance.

Folksamerica Reinsurance Company80, rue Bloor Ouest, Bureau1202Toronto (Ontario) M5S 2V1James M. Willis, Agentprincipal.

Biens, automobile, détournements,responsabilité,grêle et caution,limitée aux affaires deréassurance.

Ford Life Insurance Company1145 Nicholson Road, Unit 2Newmarket, Ontario L3Y 7V1Colleen Sexsmith, Chief Agent.

Life, Accident and sickness,limited to the servicing ofpolicies issuedprior toJuly 1, 1992.

Ford Life Insurance Company1145, chemin Nicholson, Unité 2Newmarket (Ontario) L3Y 7V1Colleen Sexsmith, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie, limitéesà lagestion despolices émisesavant le 1er juillet 1992.

Foresters Indemnity Company789 Don Mills RoadDon Mills, Ontario M3C 1T9G. Peter Oakes, Group Vice-President

Finance & Administration.

Property, Accident and sicknessand Liability, limited to theservicing of existing policies.

Voir-Indemnité Compagnie des Forestiers

Forethought Life Insurance Company3380 South Service RoadBurlington, Ontario L7N 3J5L. Paul Renaud, Chief Agent.

Life. Forethought Life Insurance Company3380, chemin South ServiceBurlington (Ontario) L7N 3J5L. Paul Renaud, Agentprincipal.

Vie.

GAN VIE Compagnie Françaised’Assurances sur la Vie

425, Maisonneuve Blvd. West, Suite 1200Montréal, Quebec H3A 3G5Eric L. Clark, Chief Agent.

Life. GAN VIE Compagnie Françaised’Assurances sur la Vie

425, boul. de Maisonneuve OuestBureau 1200Montréal (Québec) H3A 3G5Eric L. Clark, Agentprincipal.

Vie.

See-The Guarantee Company ofNorth America

La Garantie, Compagnie d’Assurancede l’Amérique du Nord

Place du Canada, Bureau 1560Montréal (Québec) H3B 2R4Jules R. Quenneville, Président et chef

de la direction.

Biens, accidents et maladie,automobile, chaudières etmachines, abus de confiance,frais juridiques, responsabilité etcaution.

GE Capital Casualty Company, Canada2023-7495 132 StreetSurrey, British Columbia V3W 1J8Danielle Bolduc, President and

Chief Financial Officer.

Property, Boiler and machinerylimited to the Province ofAlberta and Vehicle Warrantyinsurance as defined by theClasses of Insurance Regulationsof the Province of Alberta, andSurety.

Voir-Compagnie d’assurance GE CapitalCasualty, Canada

GE Capital Mortgage Insurance Company(Canada)

2300 Meadowvale Blvd.Mississauga, Ontario L5N 5P9Peter Vukanovich, President, Chief

Executive Officer, and Chief FinancialOfficer

Mortgage. Voir-Compagnie d’assurance d’hypothèquesGE Capital (Canada)

GE Reinsurance Corporation3650 Victoria Park Ave., Suite 201North York, Ontario M2H 3P7V. Lorraine Williams, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Hail,Liabilit y and Surety, limited tothe business of reinsurance.

GE Reinsurance Corporation3650, av. Victoria Park, Bureau 201North York (Ontario) M2H 3P7V. Lorraine Williams, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,accidents d’aviation, automobile,chaudières et machines, abus deconfiance,grêle, responsabilité etcaution, limitée aux affaires deréassurances.

General & Cologne Life Re of America1 First Canadian PlaceSuite 5705, P.O. Box 471Toronto, Ontario M5X 1E4Gerald A. Wolfe, Chief Agent

Life, Accident and sickness,limited to the business ofreinsurance.

General & Cologne Life Re of America1 First Canadian PlaceBureau 5705, C.P. 471Toronto (Ontario) M5X 1E4Gerald A. Wolfe, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie, limitéeaux affaires de réassurance.

General American Life Insurance Company1501 McGill College AvenueSuite 2220Montréal, Quebec H3A 3M8André St-Amour, Chief Agent.

Life, Personal accident andSickness.

General American Life Insurance Company1501, av. McGill CollegeBureau 2220Montréal (Québec) H3A 3M8André St-Amour, Agentprincipal.

Vie, accidents corporels etmaladie.

Page 54: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

22 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

General Insurance Company of Americac/o Fasken, Campbell, GodfreyP.O. Box 20Toronto-Dominion BankTowerToronto-Dominion CentreToronto, Ontario M5K 1N6Robert M. Sutherland, Chief Agent.

Property, Automobile, Fidelity,Liabilit y and Surety, limited tothe servicing of existing policies.

General Insurance Company of Americaa/s Fasken, Campbell, GodfreyC.P. 20, Toronto-Dominion CentreToronto-Dominion BankTowerToronto (Ontario) M5K 1N6Robert M. Sutherland, Agentprincipal.

Biens, automobile, abus deconfiance, responsabilité etcaution, limitée àl’administration despolicesexistantes.

General Reinsurance Corporation1 First Canadian PlaceSuite 5705, P.O. Box 471Toronto, Ontario M5X 1E4Gerald A. Wolfe, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Credit, Fidelity, Hail,Liabilit y and Surety.

General Reinsurance Corporation1 First Canadian PlaceBureau 5705, C.P. 471Toronto (Ontario) M5X 1E4Gerald A. Wolfe, Agentprincipal.

Biens, abus de confiance, accidentset maladie, accidents d’aviation,automobile, caution, chaudièreset machines, crédit,grêle etresponsabilité.

Gold Circle Insurance Companyc/o The Great-West LifeAssurance Company

100 Osborne St. NorthWinnipeg, Manitoba R3C 3A5Sheila Wagar, Secretary.

Property, Accident and sickness,Automobile and Liability,limited to the servicing ofexisting policies.

Voir-Cercle d’Or, Compagnie d’Assurance

Gore Mutual Insurance Company252 Dundas St.Cambridge, Ontario N1R 5T3Claude Smith, President and Chief

Operating Officer.

Property, Accident and sickness,Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Liability andSurety.

Gore Mutual Insurance Company252, rue DundasCambridge (Ontario) N1R 5T3Claude Smith, Président et chef

des opérations.

Biens, accident et maladie,automobile, chaudières etmachines, détournements,responsabilité et caution.

Grain Insurance and Guarantee Company1240 One Lombard PlaceWinnipeg, Manitoba R3B 0V9Ralph N. Jackson, President.

Property, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Liability andSurety.

Voir-La Compagnie d’assurance et deGarantie Grain

Granite Insurance Company2 Eva Road, Suite 200Etobicoke, Ontario M9C 2A8Bruce K. Dwyer, President.

Property, Accident and sickness,Automobile, Fidelity, Liabilityand Surety, limited to theservicing of existing policies.

Granite Compagnie d’Assurances2, chemin Eva, Bureau 200Etobicoke (Ontario) M9C 2A8Bruce K. Dwyer, Président.

Biens, accidents et maladie,automobile, abus de confiance,responsabilité et caution, limitéeà l’administration despolicesexistantes.

Great American Insurance Company40 King Street WestScotia Plaza, Suite 2100Toronto, Ontario M5H 3C2J. Brian Reeve, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Hail,Liabilit y and Surety.

Great American Insurance Company40, rue King OuestScotia Plaza, Bureau 2100Toronto (Ontario) M5H 3C2J. Brian Reeve, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,accidents d’aviation, automobile,chaudières et machines, abus deconfiance,grêle, responsabilité etcaution.

The Great-West Life Assurance Company100 Osborne St. NorthP.O. Box 6000Winnipeg, Manitoba R3C 3A5Ray McFeetors, President and

Chief Executive Officer.

Life, Accident and sickness. La Great-West, compagnie d’assurance-vie100, rue Osborne NordC.P. 6000Winnipeg (Manitoba) R3C 3A5Ray McFeetors, Président et chef

de la direction.

Vie, accidents et maladie.

The Guarantee Company of North AmericaPlace du Canada, Suite 1560Montréal, Quebec H3B 2R4Jules R. Quenneville, President and

Chief Executive Officer.

Property, Accident and Sickness,Automobile, Boiler andMachinery, Fidelity, Legalexpense, Liability and Surety.

Voir-La Garantie, Compagnie d’Assurancede l’Amérique du Nord

See-The Commerce Group InsuranceCompany

Le Groupe Commerce Compagnied’Assurances

2450, rue Girouard Ouest, C.P. 1000Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7C4Claude Gravel, Président et chef

des opérations.

Biens, accidents et maladie,aériennes, automobile,chaudières et machines, fraisjuridiques, détournements,grêle,responsabilité et caution.

The Halifax Insurance Company75 Eglinton Ave. EastToronto, Ontario M4P 3A4Donald K. Lough, President.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Hail,Liabilit y and Surety.

Voir-La Compagnie d’Assurance Halifax

Hannover Ruckversicherungs-Aktiengesellschaft

3650 Victoria Park Ave., Suite 201North York, Ontario M2H 3P7V. Lorraine Williams, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Hail,Liabilit y and Surety, limited tothe business of reinsurance.

Hannover Ruckversicherungs-Aktiengesellschaft

3650, av. Victoria Park, Bureau 201North York (Ontario) M2H 3P7V. Lorraine Williams, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,accidents d’aviation, automobile,chaudières et machines, abus deconfiance,grêle, responsabilité etcaution, limitée aux affaires deréassurance.

The Hanover Insurance Companyc/o Focus Group, Inc.36 King Street East, Suite 500Toronto, Ontario M5C 1E5Philip H. Cook, Chief Agent.

Property, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Liability andSurety, limited to the servicing ofexisting policies.

The Hanover Insurance Companya/s Focus Group, Inc.36, rue King Est, Bureau 500Toronto (Ontario) M5C 1E5Philip H. Cook, Agentprincipal.

Biens, chaudières et machines,automobile, abus de confiance,responsabilité et caution, limitéeà l’administration despolicesexistantes.

Page 55: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 23

The Hartford Fire Insurance Company20 York Mills Rd.Willowdale, Ontario M2P 2C2Kenneth Yeaglin, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Hail,Liabilit y and Surety.

The Hartford Fire Insurance Company20, chemin York MillsWillowdale (Ontario) M2P 2C2Kenneth Yeaglin, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,accidents d’aviation, automobile,chaudières et machines, abus deconfiance,grêle, responsabilité etcaution.

Hartford Insurance Company of Canada20 York Mills Rd.Willowdale, Ontario M2P 2C2Gary G. Davis, President and Chief

Executive Officer.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Hail,Liabilit y and Surety.

Voir-Compagnie d’Assurance Hartforddu Canada.

Hartford Life Insurance Company20 Queen Street West, Suite 1400Toronto, Ontario M5H 2V3Susan L. Naylor, Chief Agent.

Life, Accident and sickness. Hartford Life Insurance Company20, rue Queen Ouest, Bureau 1400Toronto (Ontario) M5H 2V3Susan L. Naylor, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie.

Helvetia Swiss Insurance Company, Limited1000 de la Gauchetière Street WestSuite 500Montréal, Quebec H3B 4W5W. J. Green, Chief Agent.

Property, Automobile, Hail, Legalexpense, Fidelity, Liability andSurety.

Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances1000, rue de la Gauchetière OuestBureau 500Montréal (Québec) H3B 4W5W. J. Green, Agentprincipal.

Biens, automobile,grêle, fraisjuridiques, détournements,responsabilité et caution.

Highlands Insurance Companyc/o Fasken, Campbell, GodfreyToronto-Dominion CentreP.O. Box 20Toronto, Ontario M5K 1C1Robert W. McDowell, Chief Agent.

Property, Aircraft, Automobile,Fidelity, Hail, Liability andSurety, limited to the servicing ofexisting policies.

Highlands Insurance Companya/s Fasken, Campbell, GodfreyToronto-Dominion Centre, C.P. 20Toronto (Ontario) M5K 1C1Robert W. McDowell, Agentprincipal.

Biens, accidents d’aviation,automobile, abus de confiance,grêle, responsabilité et caution,limitée à l’administration despolices existantes.

The Home Insurance Companyc/o Focus Group Inc.36 King Street East, Suite 500Toronto, Ontario M5C 1E5Philip H. Cook, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Liability andSurety, limited to the servicing ofexisting policies.

The Home Insurance Companya/s Focus Group Inc.36, rue King Est, Bureau 500Toronto (Ontario) M5C 1E5Philip H. Cook, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,aériennes, automobile, caution,chaudières et machines,détournements et responsabilité,limitée à l’écoulement despolices existantes.

Household Life Insurance CompanyPlace Marois3268 Saint-Martin Boulevard. WestLaval, Quebec H7T 1A1Jennifer Vinet, Chief Agent.

Life, Accident and sickness, on thecondition that if, in thetransaction of its business inCanada, the Company uses aFrench form of name, that nameshall be “Compagnied’Assurance-Vie Household”.

Voir-Compagnie d’Assurance-VieHousehold

HSBC Canadian Direct InsuranceIncorporated

610-6th Street, Suite 217New WestminsterBritish Columbia V3L 3C2Guy Cloutier, President and

Chief Executive Officer.

Property, Accident and sickness,Automobile and Liability.

Voir-La Compagnie d’Assurances HSBCCanadienne Direct Incorporée.

ICAROM Public Limited Companyc/o Focus Group Inc.36 King Street East, Suite 500Toronto, Ontario M5C 1E5Philip H. Cook, Chief Agent.

Property, Aircraft, Automobile,Fidelity, Liability and Surety,limited to the servicing ofexisting policies.

ICAROM Public Limited Companya/s Focus Group Inc.36, rue King Est, Bureau 500Toronto (Ontario) M5C 1E5Philip H. Cook, Agentprincipal.

Biens, accidents d’aviation,automobile, abus de confiance,responsabilité et caution, limitéeà l’administration despolicesexistantes.

The Imperial Life Assurance Companyof Canada

95 St. Clair Ave. WestToronto, Ontario M4V 1N7Marcel Pépin, President and Chief

Executive Officer.

Life, Accident and sickness. L’Impériale, compagnie d’assurance-vie95, av. St. Clair OuestToronto (Ontario) M4V 1N7Marcel Pépin, Président et chef

de la direction.

Vie, accidents et maladie.

See-Foresters Indemnity Company Indemnité Compagnie des Forestiers789, chemin Don MillsDon Mills (Ontario) M3C 1T9G. Peter Oakes, Vice-président

Groupe des Financeset Administration.

Biens, accidents et maladie etresponsabilité, limitée àl’administration despolicesexistantes.

ING Novex Insurance Company of CanadaSuite 300, P.O. Box 130Markborough Place II6733 Mississauga RoadMississauga, Ontario L5N 6J5Jack (John) P. McCarthy, President

and Chief Executive Officer.

Property, Accident and sickness,Automobile, Boiler andmachinery* , Credit, Fidelity,Legal expense, Liability andSurety* . (*Denotes classeslimited to the business ofreinsurance.)

ING Novex Compagnie d’assurancedu Canada

Bureau 300, C.P. 130Markborough Place II6733, chemin MississaugaMississauga (Ontario) L5N 6J5Jack (John) P. McCarthy, Président

et chef de la direction.

Biens, accidents et maladie,automobile, chaudières etmachines* , crédit,détournements, fraisjuridiques,responsabilité et caution* .(* Indiqueque ces branchesd’affaires sont limitées auxaffaires de réassurances.)

Page 56: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

24 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

The Insurance Corporation of New York1145 Nicholson Road, Unit 2Newmarket, Ontario L3Y 7V1Colleen Sexsmith, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Hail,Liabilit y and Surety, limited tothe business of reinsurance.

The Insurance Corporation of New York1145, chemin Nicholson, Bureau 2Newmarket (Ontario) L3Y 7V1Colleen Sexsmith, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,aériennes, automobile,chaudières et machines,détournements,grêle,responsabilité et caution, limitéeaux affaires de réassurances.

J.C. Penney Life Insurance CompanySuite 500, 80 Tiverton CourtMarkham, Ontario L3R 0G4Isaac Sananes, Chief Agent.

Life, Accident and sickness. Voir-Compagnie d’assurance-vieJ.C. Penney

Jevco Insurance Company2021 Union, Suite 1150Montréal, Quebec H3A 2S9William G. Star, Chairman, President

and Chief Executive Officer.

Property, Automobile, Liabilityand Surety.

Voir-La Compagnie d’Assurances Jevco

John Alden Life Insurance Company1145 Nicholson Road, Unit 2Newmarket, Ontario L3Y 7V1Colleen Sexsmith, Chief Agent.

Life, Accident and sickness, on thecondition that if in thetransaction of its business inCanada the Company uses aFrench name, that name shall be“La Compagnie D’Assurance-Vie John Alden”. The company’sbusiness in Canada is limited tothe servicing of policies issuedprior to April 1, 1991.

Voir-La Compagnie D’Assurance-VieJohn Alden

John Hancock Life Insurance Companyc/o McLean & Kerr130 Adelaide Street West, Suite 2800Toronto, Ontario M5H 3P5Robin B. Cumine, Q.C., Chief Agent.

Life, Accident and sickness,limited to the servicing ofpolicies issuedprior toDecember 31, 1995 with theexception of business arisingfrom conversion ofgrouppolicies to individualpolicies.

John Hancock Life Insurance Companya/s McLean & Kerr130, rue Adelaide Ouest, Bureau 2800Toronto (Ontario) M5H 3P5Robin B. Cumine, C.R., Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie, limitée àla gestion despolices émisesavant le 31 décembre 1995exception faite des activitésdécoulant de la conversion depolices collectives à despolicesindividuelles.

The Kings Mutual Insurance CompanyP.O. Box 10Berwick, Nova Scotia B0P 1E0Josephus J. Ueffing, President.

Property and Liability. The Kings Mutual Insurance CompanyC.P. 10Berwick (Nouvelle-Écosse) B0P 1E0Josephus J. Ueffing, Président.

Biens et responsabilité.

Lawyers Title Insurance Corporation2170 Torquay MewsMississauga, Ontario L5N 2M6Gary Patrick Mooney, Chief Agent.

Title Lawyers Title Insurance Corporation2170, Torquay MewsMississauga (Ontario) L5N 2M6Gary Patrick Mooney, Agentprincipal.

Titres

Le Mans Ré20 Queen Street West, Suite 1000Toronto, Ontario M5H 3R3Rui Quintal, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Liability andSurety, limited to the business ofreinsurance.

Le mans Ré20, rue Queen Ouest, Bureau 1000,Toronto (Ontario) M5H 3R3Rui Quintal, Agentprincipal.

Biens, accident et maladie,automobile, chaudières etmachines, détournements,responsabilité et caution, limitéeaux affaires de réassurance

Legacy General Insurance Company80 Tiverton Court, Suite 500Markham, Ontario L3R 0G4Aaron Hill, Vice-President and

Chief Executive Officer.

Property, Accident and sickness,and Loss of Employment.

Voir-Compagnie d’assurancesgénéralesLegacy

Liberty Insurance Company of Canada200 Consilium Place, 8th FloorScarborough, Ontario M1H 3E6Ronald H. Switzer, President and

Chief Executive Officer.

Property, Automobile andLiabilit y.

Voir-Compagnie d’Assurance Liberté duCanada

Liberty Life Assurance Company of BostonBCE Place, Bay Wellington Tower181 Bay Street, Suite 3320Toronto, Ontario M5J 2T3Gery Barry, Chief Agent.

Life, Accident and sickness. Voir-La Compagnie d’Assurance-VieLiberté de Boston.

Page 57: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 25

Liberty Mutual Fire Insurance CompanyBCE Place, Bay Wellington Tower181 Bay Street, Suite 3320Toronto, Ontario M5J 2T3Gery Barry, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Liability andSurety, limited to the servicing ofexisting policies, except forautomobile insurance; and on thecondition that, if in thetransaction of its business inCanada, the company uses aFrench name, that name shall be“La Compagnie d’AssuranceGénérale Liberté Mutuelle”.

Voir-La Compagnie d’Assurance GénéraleLiberté Mutuelle.

Liberty Mutual Insurance CompanyBCE Place, Bay Wellington Tower181 Bay Street, Suite 3320Toronto, Ontario M5J 2T3Gery Barry, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Liability andSurety.

Voir-La Compagnie d’Assurance LibertéMutuelle

Life Insurance Company of North America55 Town Centre Court,Suite 606, P.O. Box 14Scarborough, Ontario M1P 4X4Eman Hassan, Chief Agent.

Life, Personal accident andSickness.

Life Insurance Company of North America55, cour Town CentreBureau 606, C.P. 14Scarborough (Ontario) M1P 4X4Eman Hassan, Agentprincipal.

Vie, accidents corporels etmaladie.

Life Investors Insurance Company ofAmerica

c/o John Milnes & Associates68 Scollard Street, 2nd FloorToronto, Ontario M5R 1G2John R. Milnes, Chief Agent.

Life, Accident and sickness. Voir-Compagnie D’Assurances LifeInvestors D’Amérique

Life Reassurance Corporation of Americac/o Deloitte and Touche181 Bay Street, Suite 1400Toronto, Ontario M5J 2V1P. Wayne Musselman, Chief Agent.

Life, Accident and sickness,limited to the business ofreinsurance.

Life Reassurance Corporation of Americaa/s Deloitte & Touche181, rue Bay, Bureau 1400Toronto (Ontario) M5J 2V1P. Wayne Musselman, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie, limitéeaux affaires de réassurance.

Lincoln Heritage Life Insurance Companysee-Superior Life Insurance Company,the name used by Lincoln HeritageLife Insurance Company to transactbusiness in Canada.

Lincoln Heritage Life Insurance Companyvoir-Superior Life Insurance Company,le nom utilisépar Lincoln Heritage LifeInsurance Company dans les affaires auCanada.

The Lincoln National Life InsuranceCompany

151 Yonge Street, Suite 1700Toronto, Ontario M5C 2W7Brenda L. Buckingham, Chief Agent.

Life, Personal accident andSickness.

The Lincoln National Life InsuranceCompany

151, rue Yonge, Bureau 1700,Toronto (Ontario) M5C 2W7Brenda L. Buckingham, Agentprincipal.

Vie, accidents corporels etmaladie.

Lloyd’s Underwriters1155 Metcalfe Street, Suite 1540Montréal, Quebec H3B 2V6Mark J. Oppenheim, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Credit, Fidelity, Hail,Legal expense, Liability andSurety.

Voir-Les Souscripteurs du Lloyd’s

Lombard General Insurance Companyof Canada

105 Adelaide Street WestToronto, Ontario M5H 1P9Byron G. Messier, Chief

Executive Officer.

Property, Aircraft, Automobile,Boiler and machinery, Credit,Fidelity, Hail, Liability andSurety.

Voir-Compagnie canadienne d’assurancesgénérales Lombard.

Lombard Insurance Company105 Adelaide Street WestToronto, Ontario M5H 1P9Byron G. Messier, Chief

Executive Officer.

Property, Aircraft, Automobile,Boiler and machinery, Credit,Fidelity, Hail, Liability andSurety.

Voir-Compagnie d’assurance Lombard.

London and Midland General InsuranceCompany

201 Queens Ave., P.O. Box 5071London, Ontario N6A 4M5A. W. Miles, Vice-President and

General Manager.

Property, Accident and sickness,Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Legalexpense, Liability and Surety.

La London et Midland Compagnied’Assurance Générale

201, av. Queens, C.P. 5071London (Ontario) N6A 4M5A. W. Miles, Vice-président et

administrateurgérant.

Biens, accidents et maladie,automobile, chaudières etmachines, abus de confiance,frais juridiques, responsabilité etcaution.

Page 58: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

26 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

London Guarantee Insurance Company77 King Street West, Suite 3426Royal Trust Tower, P.O. Box 284Toronto, Ontario M5K 1K2Robert E. Taylor, President.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Credit (oncondition that theperson towhom the credit isgranted islocated in Canada), Boiler andmachinery, Fidelity, Hail, LegalExpense, Title, Liability andSurety.

Voir-Compagnie d’Assurance LondonGarantie

London Life Insurance Company255 Dufferin Ave.London, Ontario N6A 4K1Raymond L. McFeetors, President and

Chief Executive Officer.

Life, Accident and sickness. London Life, Compagnie d’Assurance-Vie255, av. DufferinLondon (Ontario) N6A 4K1Raymond L. McFeetors, Président et chef

de la direction.

Vie, accidents et maladie.

Lumbermens Mutual Casualty Company320 Front Street West, 6th FloorToronto, Ontario M5V 3B6Judy Maddocks, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Liability andSurety.

Lumbermens Mutual Casualty Company320, rue Front Ouest, 6e étageToronto (Ontario) M5V 3B6Judy Maddocks, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,accidents d’aviation, automobile,chaudières et machines, abus deconfiance, responsabilité etcaution.

Lumbermen’s Underwriting Alliance185 Dorval Ave., Suite 500Dorval, Quebec H9S 5J9Maurice R. Piché, Chief Agent.

Property and Boiler andmachinery.

Lumbermen’s Underwriting Alliance185, av. Dorval, Bureau 500Dorval (Québec) H9S 5J9Maurice R. Piché, Agentprincipal.

Biens, chaudières et machines.

The Manufacturers Life Insurance Company200 Bloor St. EastToronto, Ontario M4W 1E5Dominic D’Alessandro, President

and Chief Executive Officer.

Life, Accident and sickness. Voir-La Compagnie d’Assurance-VieManufacturers

Manulife Financial Corporation200 Bloor St. EastToronto, Ontario M4W 1E5Dominic D’Alessandro, President

and Chief Executive Officer.

Life Voir-Société Financière Manuvie

Maritime Insurance Company Limited250 Yonge Street, 15th floorToronto, Ontario M5B 2L7Maurice Jaques, Chief Agent.

Property and Liability, limited tothat liability insurance which thecompany is authorized totransact in the United Kingdom.

Maritime Insurance Company Limited250, rue Yonge, 15e étageToronto (Ontario) M5B 2L7Maurice Jaques, Agentprincipal.

Biens et responsabilité, limitera sesactivités relatives à l’assurancede responsabilité aux catégoriesqui lui sont autorisées auRoyaume-Uni.

The Maritime Life Assurance Company2701 Dutch Village Rd., P.O. Box 1030Halifax, Nova Scotia B3J 2X5Heather Hannon, VP, Counsel and

Corporate Secretary

Life, Personal accident andSickness.

La Maritime Compagnie d’Assurance-vie2701, chemin Dutch Village, C.P. 1030Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2X5Heather Hannon, VP, Conseillaire et

Secrétaire corporatif.

Vie, accidents et maladie.

Markel Insurance Company of Canada105 Adelaide Street West, 7th FloorToronto, Ontario M5H 1P9Mark Ram, President.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Hail,Liabilit y and Surety.

Markel Compagnie d’Assurance du Canada105, rue Adelaide Ouest, 7e étageToronto (Ontario) M5H 1P9Mark Ram, Président.

Biens, accidents et maladie,accidents d’aviation, automobile,chaudières et machines, abus deconfiance,grêle, responsabilité etcaution.

Maryland Casualty Companyc/o Lavery, DeBilly,

Barristers & SolicitorsOne Place Ville Marie, 40th FloorMontréal, Quebec H3B 4M4Pierre Caron, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Liability andSurety, on the condition that if inthe transaction of its business inCanada the Company uses aFrench name, that name shall be“Compagnie MarylandCasualty”, limited to theservicing of existing policies.

Voir-Compagnie Maryland Casualty

Massachusetts Mutual Life InsuranceCompany

c/o McLean & Kerr130 Adelaide St. West, Suite 2800Toronto, Ontario M5H 3P5Robin B. Cumine, Q.C., Chief Agent.

Life, Personal accident andSickness

Massachusetts Mutual Life InsuranceCompany

a/s McLean & Kerr130, rue Adelaide Ouest, Bureau 2800Toronto (Ontario) M5H 3P5Robin B. Cumine, C.R., Agentprincipal.

Vie, accidents corporels etmaladie.

Metropolitan Life Insurance CompanyConstitution Square360 Albert Street, Suite 1750Ottawa, Ontario K1R 7X7William R. Prueter, Chief Agent.

Life, Accident and sickness, on thecondition that if in thetransaction of its business inCanada the Company uses aFrench name, that name shall be“La Métropolitaine, compagnied’Assurance vie.”

La Métropolitaine, compagnied’Assurance vie

Carré Constitution360, rue Albert, Bureau 1750Ottawa (Ontario) K1R 7X7William R. Prueter, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie, à laconditionque, si la compagnieutilise un nom français dans lesaffaires au Canada, ce nom serait« La Métropolitaine, compagnied’Assurance vie ».

Page 59: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 27

MIC Life Insurance CorporationP.O. Box 6000, 8500 Leslie St., Suite 400Thornhill, Ontario L3T 4S5Charles W. Hastings, Chief Agent.

Life, Accident and sickness,limited to the servicing ofpolicies issuedprior toJanuary 1, 1997 and on thecondition that if in thetransaction of its business inCanada the Company uses aFrench form of name, that nameshall be “La Compagnied’Assurance-Vie MIC”.

Voir-La Compagnie d’Assurance-Vie MIC

Minnesota Life Insurance Companyc/o McLean & Kerr130 Adelaide St. West, Suite 2800Toronto, Ontario M5H 3P5Robin B. Cumine, Q.C., Chief Agent.

Life, on the condition that if in thetransaction of its business inCanada the foreign companyuses a French name, that nameshall be “Compagnied’Assurance-vie Minnesota”.

Voir-La Compagnie d’Assurance-vieMinnesota.

The Missisquoi Insurance Company625 René-Lévesque Blvd. WestSuite 600Montréal, Quebec H3B 1R2Jean P. Courtemanche, President.

Property, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Liability andSurety.

Voir-La Compagnie d’Assurance Missisquoi.

Mitsui Marine and Fire InsuranceCompany, Limited

c/o D.M. Williams & Associates Ltd.3650 Victoria Park Ave., Suite 201North York, Ontario M2H 3P7V. Lorraine Williams, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Liability andSurety.

Mitsui Marine and Fire InsuranceCompany, Limited

a/s D.M. Williams & Associates Ltd.3650, av. Victoria Park, Bureau 201North York (Ontario) M2H 3P7V. Lorraine Williams, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,aériennes, automobile,chaudières et machines,détournements, responsabilité etcaution.

The Mortgage Insurance Companyof Canada

100 Yonge Street, Suite 400Toronto, Ontario M5H 1H1Oscar Zimmerman, President.

Fidelity, and Surety, limited to theservicing of existing policies,and Mortgage, limited to thebusiness of reinsurance.

Voir-La Compagnie d’Assuranced’Hypothèques du Canada

Motors Insurance Corporation8500 Leslie St.Thornhill, Ontario L3T 4S5Charles W. Hastings, Chief Agent.

Property, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Liability andSurety.

Motors Insurance Corporation8500, rue LeslieThornhill (Ontario) L3T 4S5Charles W. Hastings, Agentprincipal.

Biens, automobile, chaudières etmachines, abus de confiance,responsabilité et caution.

Munich Reinsurance Company(Munchener Rückversicherungs-

Gesellschaft)390 Bay Street, 26th FloorToronto, Ontario M5H 2Y2

Life BranchJames A. Brierley, Chief Agent.

Property and Casualty BranchJohn P. Phelan, Chief Agent.

Life, Property, Accident andsickness, Aircraft, Automobile,Boiler and machinery, Credit,Fidelity, Hail, Liability andSurety, limited to the business ofreinsurance. The Company mayuse in the transacting of itsbusiness in Canada its name inEnglish “Munich ReinsuranceCompany” or its name in French“La Munich, Compagnie deRéassurance”.

La Munich, Compagnie de Réassurance(Munchener Rückversicherungs-Gesellschaft)

390, rue Bay, 26e étageToronto (Ontario) M5H 2Y2

VieJames A. Brierley, Agentprincipal.

Biens et risques diversJohn P. Phelan, Agentprincipal.

Vie, biens, accidents et maladie,accidents d’aviation, automobile,chaudières et machines, crédit,abus de confiance,grêle,responsabilité et caution, limitéeaux affaires de réassurance. LaCompagnie peut utiliser dans lesaffaires au Canada son nom enanglais « Munich ReinsuranceCompany » ou son nom enfrançais « La Munich,Compagnie de Réassurance ».

Munich Reinsurance Company of Canada390 Bay St., 22nd FloorToronto, Ontario M5H 2Y2John P. Phelan, President.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Credit, Fidelity, Hail,Legal expense, Liability andSurety, limited to the business ofreinsurance.

La Munich, du Canada, Compagniede Réassurance

390, rue Bay, 22e étageToronto (Ontario) M5H 2Y2John P. Phelan, Président.

Biens, accidents et maladie,aériennes, automobile,chaudières et machines, crédit,détournements,grêle, fraisjuridiques, responsabilité etcaution, limitée aux affaires deréassurance.

The Mutual Life Insurance Companyof New York

c/o Tory, Tory, DesLauriers & Binnington79 Wellington Street WestSuite 3000, AetnaTowerP.O. Box 270, Toronto-Dominion CentreToronto, Ontario M5K 1N2Blair W. Keefe, Chief Agent.

Life, Personal accident andSickness, limited to the servicingof policies issuedprior toApril 1, 1991.

The Mutual Life Insurance Companyof New York

a/s Tory, Tory, DesLauriers & Binnington79, rue Wellington OuestBureau 3000, AetnaTowerC.P. 270, Toronto-Dominion CentreToronto (Ontario) M5K 1N2Blair W. Keefe, Agentprincipal.

Vie, accidents corporels etmaladie, sous réserve de larestrictionque les affaires de lacompagnie soient limitées àl’écoulement despolices émisesavant le 1er avril 1991.

Page 60: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

28 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

Mutual of Omaha Insurance Companyc/o Cassels, Brock & Blackwell40 King Street WestScotia Plaza, Suite 2100Toronto, Ontario M5H 3C2J. Brian Reeve, Chief Agent.

Life, Accident and sickness,limited to the servicing ofpolicies issuedprior toJanuary 1, 1998, on the conditionthat if in the transaction of itsbusiness in Canada the foreigncompany uses a French form ofname, that name shall be “LaMutuelle d’Omaha, Compagnied’assurance”.

La Mutuelle d’Omaha, Compagnied’Assurance

a/s Cassels, Brock & Blackwell40, rue King OuestScotia Plaza, Bureau 2100Toronto (Ontario) M5H 3C2J. Brian Reeve, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie, limitée àla gestion despolices émisesavant le 1er janvier 1998,pourvuque, si la société étrangère utiliseune dénomination socialefrançaise dans le cadre del’exercice de son activité auCanada, ce soit « La Mutuelled’Omaha, Compagnied’assurance ».

La Mutuelle du Mans Assurances I.A.R.D.20 Queen St. West, Suite 1000Toronto, Ontario M5H 3R3Rui Quintal, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Liability andSurety, limited to the business ofreinsurance.

La Mutuelle Du Mans Assurances I.A.R.D.20, rue Queen Ouest, Bureau 1000Toronto (Ontario) M5H 3R3Rui Quintal, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,automobile, chaudières etmachines, abus de confiance,responsabilité et caution, limitéeaux affaires de réassurance.

La Mutuelle du Mans Assurances Viec/o Industrial-Alliance Life Insurance Co.1080 St-Louis Road,P.O. Box 1907, Station TerminusSillery, Quebec G1K 7M3Yvon Charest, Chief Agent.

Life, Accident and sickness,limited to the business ofreinsurance.

La Mutuelle du Mans Assurances Viea/s L’Industrielle-Alliance Compagnie

d’Assurance sur la Vie1080, chemin St-LouisC.P. 1907, succursale TerminusSillery (Québec) G1K 7M3Yvon Charest, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie, limitéeaux affaires de réassurance.

NAC Reinsurance Corporation211 Consumers Road, Suite 300North York, Ontario M2J 4G8Denis Shillington, Chief Agent.

Surety, limited to the business ofreinsurance, and Property,Accident and sickness, Aircraft,Automobile, Fidelity, Hail andLiabilit y.

NAC Reinsurance Corporation211, chemin Consumers, Bureau 300North York (Ontario) M2J 4G8Denis Shillington, Agentprincipal.

Caution, limitée aux affaires deréassurance, et biens, accident etmaladie, aériennes, automobile,détournements,grêle etresponsabilité.

National Fidelity Life Insurance Company19 Celina Street, Suite 104Oshawa, Ontario L1H 4M9J. Terence Hogan, Chief Agent.

Life, Personal accident andSickness

National Fidelity Life Insurance Company19, rue Celina, Bureau 104Oshawa (Ontario) L1H 4M9J. Terence Hogan, Agentprincipal.

Vie, accidents corporels etmaladie.

The National Life Assurance Companyof Canada

522 University Ave.Toronto, Ontario M5G 1Y7Vincent Tonna, President and Chief

Operating Officer.

Life, Personal accident andSickness.

La Nationale du Canada, Compagnied’Assurance-Vie

522, av. UniversityToronto (Ontario) M5G 1Y7Vincent Tonna, Président et chef

des opérations.

Vie, accidents corporels etmaladie.

National Reinsurance Corporation1 First Canadian PlaceSuite 5705, P.O. Box 471Toronto, Ontario M5X 1E4Gerald A. Wolfe, Chief Agent.

Property, Automobile, Boiler andmachinery, Hail and Liability,limited to the business ofreinsurance.

National Reinsurance Corporation1 First Canadian PlaceBureau 5705, C.P. 471Toronto (Ontario) M5X 1E4Gerald A. Wolfe, Agentprincipal.

Biens, automobile, chaudières etmachines,grêle et responsabilité,limitée aux affaires deréassurance.

Nationwide Mutual Insurance Companyc/o John Milnes & Associates2nd Floor, 68 Scollard StreetToronto, Ontario M5R 1G2John R. Milnes, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Hail,Liabilit y and Surety.

Nationwide Mutual Insurance Companya/s John Milnes & Associates2e étage, 68, rue ScollardToronto (Ontario) M5R 1G2John R. Milnes, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,accidents d’aviation, automobile,chaudières et machines, abus deconfiance,grêle, responsabilité etcaution.

Nederlandse Reassurantie Groep N.V.995 Dupont StreetToronto, Ontario M6H 1Z5Robert De Marco, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Automobile, Fidelity, Hail,Liabilit y and Surety, limited tothe business of reinsurance, andlimited to the servicing ofexisting policies; on thecondition that if in thetransaction of its business inCanada the Company uses ananglicized name, that name shallbe “Netherlands ReinsuranceGroup N.V.”.

Nederlandse Reassurantie Groep N.V.995, rue DupontToronto (Ontario) M6H 1Z5Robert De Marco, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,automobile, abus de confiance,grêle, responsabilité et caution,limitée aux affaires deréassurance et limitée àl’administration despolicesexistantes, à la conditionquelorsque la compagnie utilise unnom anglais dans l’exercice deses activités au Canada, ce nomsoit « Netherlands ReinsuranceGroup N.V. ».

New Hampshire Insurance Company145 Wellington St. WestToronto, Ontario M5J 1H8Gary A. McMillan, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Liability andSurety.

New Hampshire Insurance Company145, rue Wellington OuestToronto (Ontario) M5J 1H8Gary A. McMillan, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,accidents d’aviation, automobile,chaudières et machines, abus deconfiance, responsabilité etcaution.

Page 61: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 29

The New India Assurance Company,Limitedc/o M. Schwab Accounting Services

Limited278 Bloor Street East, Suite 401Toronto, Ontario M4W 3M4Fernao Ferreira, Chief Agent.

Fire, Accident, Automobile, Boilerexcluding machinery, Inlandtransportation, Personalproperty,Plateglass, Realproperty, Theftand additional classes 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9 and 10 (SeeNote(B)), limited to the servicing ofexisting policies.

The New India Assurance Company,Limiteda/s M. Schwab Accounting Services

Limited278, rue Bloor Est, Bureau 401Toronto (Ontario) M4W 3M4Fernao Ferreira, Agentprincipal.

Incendie, accidents, automobile,biens immeubles, biens meubles,brise desglaces, chaudières (lesmachines non comprises),transports terrestres, vol etcatégories additionnelles 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 (VoirRemarque (B)), limitée àl’administration despolicesexistantes.

New York Life Insurance CompanyScotia Plaza, Suite 210040 King Street WestToronto, Ontario M5H 3C2J. Brian Reeve, Chief Agent.

Life, Accident and sickness, on thecondition that if in thetransaction of its business inCanada the Company uses aFrench name, that name shall be“Compagnie d’assurances NewYork Life”.

Voir-Compagnie d’assurancesNew York Life

Niagara Fire Insurance Companyc/o CAS Accounting for Insurance Inc.Unit 2, 1145 Nicholson RoadNewmarket, Ontario L3Y 7V1Colleen Anne Sexsmith, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Credit, Fidelity, Hail,Liabilit y and Surety.

Niagara Fire Insurance Companya/s CAS Accounting for Insurance Inc.1145, chemin Nicholson, Unité 2Newmarket (Ontario) L3Y 7V1Colleen Anne Sexsmith, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,aériennes, automobile,chaudières et machines, crédit,détournements,grêle,responsabilité et caution.

The Nippon Fire & Marine InsuranceCompany Limited

c/o The General Accident AssuranceCompany of Canada

2206 Eglinton Ave. East, Suite 500Scarborough, Ontario M1L 4S8Normand W. McIntyre, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Liability andSurety.

The Nippon Fire & Marine InsuranceCompany Limited

a/s General Accident, Compagnied’Assurance du Canada

2206, av. Eglinton Est, Bureau 500Scarborough (Ontario) M1L 4S8Normand W. McIntyre, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,accidents d’aviation, automobile,chaudières et machines, abus deconfiance, responsabilité etcaution.

NN Life Insurance Company of CanadaOne Concorde GateDon Mills, Ontario M3C 3N6Claude Dussault, President and Chief

Executive Officer.

Life, Accident and sickness. NN Compagnie d’Assurance-Vie du CanadaOne Concorde GateDon Mills (Ontario) M3C 3N6Claude Dussault, Président et chef

de la direction.

Vie, accidents et maladie.

See-First North American InsuranceCompany.

La Nord-américaine,première compagnied’assurance

5650, rue YongeNorth York (Ontario) M2M 4G4Dominic D’Alessandro, Président et

chef de la direction.

Biens, limitée à l’assurance contrela perte de revenus, l’assurancebagages, l’assurance réparationet remplacement demarchandises et l’assurance descartes de crédit résultantd’initiatives de marketing demasse, accidents et maladie etautomobile, limitée audédommagement des détenteursd’une carte de crédit assurés envertu d’une assurance collectiveaccordant des droitsd’exonération.

The Nordic Insurance Company of CanadaP.O. Box 4096, Station AToronto, Ontario M5W 1N1Henry J. Curtis, President

and Chief Executive Officer.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Credit, Fidelity,Legal expense, Liability andSurety.

La Nordique compagnie d’assurancedu Canada

C.P. 4096, Succursale AToronto (Ontario) M5W 1N1Henry J. Curtis, Président et chef

de la direction.

Biens, accidents et maladie,aériennes, automobile,chaudières et machines, crédit,détournements, fraisjuridiques,responsabilité et caution.

Nordisk Reinsurance Company A/Sc/o M. Schwab Accounting Services

Limited278 Bloor Street East, Suite 401Toronto, Ontario M4W 3M4Fernao Ferreira, Chief Agent.

Property, Automobile andLiabilit y, limited to the businessof reinsurance, and to theservicing of existing policies.

Nordisk Reinsurance Company A/Sa/s M. Schwab Accounting Services

Limited278, rue Bloor Est, Bureau 401Toronto (Ontario) M4W 3M4Fernao Ferreira, Agentprincipal.

Biens, automobile etresponsabilité, limitée auxaffaires de réassurance et àl’administration despolicesexistantes.

The North Waterloo Farmers MutualInsurance Company

100 Erb St. EastWaterloo, Ontario N2J 2L5Robert Monte, General Manager.

Property, Automobile, Boiler andmachinery, Hail, Fidelity andLiabilit y.

The North Waterloo Farmers MutualInsurance Company

100, rue Erb EstWaterloo (Ontario) N2J 2L5Robert Monte, Directeurgénéral.

Biens, automobile, chaudières etmachines,grêle, détournementset responsabilité.

The North West Life Assurance Companyof Canada

2165 Broadway West, P.O. Box 5900Vancouver, British Columbia V6B 5H6Douglas A. Carrothers, Vice-President,

General Counsel and Secretary.

Life, Personal accident andSickness.

Voir-La Compagnie d’Assurance-VieNorth West du Canada

Page 62: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

30 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

Northern Indemnity, Inc.2 Bloor Street West, Suite 1500Toronto, Ontario M4W 3E2Robert Lamendola, President.

Property, Liability, Fidelity andSurety

Voir-La Compagnie d’Indemnité du Nord,Inc.

Norwich Union Life Insurance Company(Canada)

60 Yonge St.Toronto, Ontario M5E 1H5Guy S. Pentelow, President and Chief

Executive Officer.

Life, Accident and sickness. Norwich Union du Canada, Compagnied’assurance-vie

60, rue YongeToronto (Ontario) M5E 1H5Guy S. Pentelow, Président et chef

de la direction.

Vie, accidents et maladie.

NRG Victory Reinsurance Limited995 Dupont StreetToronto, Ontario M6H 1Z5Robert De Marco, Chief Agent.

Property, Automobile, Fidelity,Liabilit y and Surety, limited tothe business of reinsurance, andto the servicing of existingpolicies.

NRG Victory Reinsurance Limited995, rue DupontToronto (Ontario) M6H 1Z5Robert De Marco, Agentprincipal.

Biens, automobile, abus deconfiance, responsabilité etcaution, limitée aux affaires deréassurance, et à l’administrationdespolices existantes.

NW Reinsurance Corporation Limitedc/o D. M. Williams & Associates Ltd.3650 Victoria Park Ave., Suite 201North York, Ontario M2H 3P7V. Lorraine Williams, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Hail,Liabilit y and Surety, limited tothe business of reinsurance, andlimited to the servicing ofexisting policies.

NW Reinsurance Corporation Limiteda/s D. M. Williams & Associates Ltd.3650, av. Victoria Park, Bureau 201North York (Ontario) M2H 3P7V. Lorraine Williams, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,automobile, chaudières etmachines, détournements,grêle,responsabilité et caution, limitéeaux affaires de réassurance, etlimitées à l’écoulement despolices émises.

Odyssey America Reinsurance Corporationc/o Canadian Insurance Consultants Inc.133 Richmond St. West, Suite 600Toronto, Ontario M5H 2L3Donald G. Smith, Chief Agent

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Hail, Legal expenseand Liability, limited to thebusiness of reinsurance and onthe condition that if in thetransaction of its business inCanada the company uses aFrench name, that name shall be“Odyssey America Compagniede Réassurance”.

Odyssey America Compagnie deRéassurancea/s Canadian Insurance Consultants Inc.133, rue Richmond Ouest, Bureau 600Toronto (Ontario) M5H 2L3Donald G. Smith, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,aériennes, automobile,chaudières et machines,grêle,frais juridiques et responsabilité,limitée aux affaires deréassurance etpourvuque, si lasociété utilise une dénominationsociale française dans le cadre del’exercice de son activité auCanada, ce soit « OdysseyAmerica Compagnie deRéassurance ».

Odyssey Reinsurance Company of Canada55 University Ave., Suite 1600Toronto, Ontario M5J 2H7Robert H. Ysseldyk, President.

Property, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Hail,Liabilit y and Surety, limited tothe business of reinsurance withsurety insurance also limited tothe servicing of existing policies.

Odyssey, société canadienne de réassurance55, av. University, Bureau 1600Toronto (Ontario) M5J 2H7Robert H. Ysseldyk, Président.

Biens, automobile, chaudières etmachines, détournements,grêle,responsabilité et caution, limitéeaux affaires de réassurance et,pour caution, limitée àl’écoulement despolicesexistantes.

Old Republic Insurance Company of Canada100 King St. West, P.O. Box 557Hamilton, Ontario L8N 3K9Frank Szirt, President and Chief

Executive Officer.

Property, Aircraft, Automobile andLiabilit y.

Voir-L’Ancienne République, Compagnied’Assurance du Canada.

See-Peopleplus Insurance Company. Omnimonde, Compagnie d’assurances400, av. UniversityToronto (Ontario) M5G 1S7Barry Gilway, Président et chef

de la direction.

Biens, accidents et maladie,aériennes, automobile,chaudières et machines,détournements,grêle,responsabilité et caution.

The Paul Revere Life Insurance Company5420 North Service Road, P.O. Box 5044Burlington, Ontario L7R 4C1George A. Shell, Chief Agent.

Life, Accident and sickness andthe Company may use in thetransaction of its business inCanada its name in English “ThePaul Revere Life InsuranceCompany” or its name in French“Paul Revere Compagnied’Assurance-Vie”, or both ofsuch names.

Paul Revere Compagnie d’Assurance-Vie5420, chemin North Service, C.P. 5044Burlington (Ontario) L7R 4C1George A. Shell, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie et laCompagnie peut utiliser dans lesaffaires au Canada son nom enanglais « The Paul Revere LifeInsurance Company » ou sonnom en français « Paul RevereCompagnie d’Assurance-Vie »ou tous deux à la fois.

Pearl Assurance Public Limited Companyc/o Focus Group Inc.36 King Street East, Suite 500Toronto, Ontario M5C 1E5P. H. Cook, Chief Agent.

Property and Liability, limited tothe servicing of existing policies.

Pearl Assurance Public Limited Companya/s Focus Group Inc.36, rue King Est, Bureau 500Toronto (Ontario) M5C 1E5P. H. Cook, Agentprincipal.

Biens et responsabilité, limitée àl’administration despolicesexistantes.

Penncorp Life Insurance Company90 Dundas Street West, Suite 400Mississauga, Ontario L5B 2T5J. Paul Edmondson, President and Chief

Executive Officer.

Life, Accident and sickness. Voir-La Compagnie D’Assurance-ViePenncorp.

Page 63: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 31

Pennsylvania Life Insurance Company90 Dundas Street West, Suite 400Mississauga, Ontario L5B 2T5J. Paul Edmondson, Chief Agent.

Life, Accident and sickness. Pennsylvania Life Insurance Company90, rue Dundas Ouest, Bureau 400Mississauga (Ontario) L5B 2T5J. Paul Edmondson, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie.

Peopleplus Insurance Company400 University Ave.Toronto, Ontario M5G 1S7Barry Gilway, President and Chief

Executive Officer.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Hail,Liabilit y and Surety.

Voir-Omnimonde, Compagnie d’assurances.

The Personal Insurance Company of Canada3 Robert Speck ParkwaySuite 500, P.O. Box 7065Mississauga, Ontario L5A 4K7Dwight Lacey, Chief Executive Officer.

Property, Accident and sickness,Automobile, Aircraft, Boiler andmachinery, Fidelity, Liability andSurety.

La Personnelle, compagnie d’assurancedu Canada

3, promenade Robert SpeckBureau 500, C.P. 7065Mississauga (Ontario) L5A 4K7Dwight Lacey, Chef de la direction.

Biens, accidents et maladie,automobile, accidents d’aviation,chaudières et machines, abus deconfiance, responsabilité etcaution.

Perth Insurance Company111 Westmount Road SouthP.O. Box 2000Waterloo, Ontario N2J 4S4Noel G. Walpole, President and Chief

Executive Officer.

Property, Automobile, andLiabilit y.

Perth, Compagnie d’Assurance111, chemin Westmount Sud, C.P. 2000Waterloo (Ontario) N2J 4S4Noel G. Walpole, Président et chef

de la direction.

Biens, automobile, etresponsabilité.

Philadelphia Reinsurance Corporation995 Dupont StreetToronto, Ontario M6H 1Z5Robert DeMarco, Chief Agent.

Property, Aircraft, Automobile,Boiler and machinery, Fidelity,Hail, Liability and Surety,limited to the business ofreinsurance, and to the servicingof existing policies.

Philadelphia Reinsurance Corporation995, rue DupontToronto (Ontario) M6H 1Z5Robert DeMarco, Agentprincipal.

Biens, accidents d’aviation,automobile, chaudières etmachines, abus de confiance,grêle, responsabilité et caution,limitée aux affaires deréassurance, et à l’administrationdespolices existantes.

Phoenix Home Life Mutual InsuranceCompany

40 King Street WestScotia Plaza, Suite 2100Toronto, Ontario M5H 3C2J. Brian Reeve, Chief Agent.

Life, Accident and sickness. Phoenix Home Life Mutual InsuranceCompany

40, rue King OuestScotia Plaza, Bureau 2100Toronto (Ontario) M5H 3C2J. Brian Reeve, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie.

The Phoenix Insurance Company36 Toronto Street, Suite 1070Toronto, Ontario M5C 2C5Brian E. Divell, Chief Agent.

Fire, Accident, Aircraft excludinginsurance against liability forloss or damage topersons causedby an aircraft or the use oroperation thereof, Automobile,Boiler, Earthquake, Explosion,Forgery, Guarantee, Inlandtransportation, Machinery,Personalproperty, Plateglass,Realproperty, Theft andadditional classes 3, 4, 5, 7, 8, 9and 10. (SeeNote (B))

The Phoenix Insurance Company36, rue Toronto, Bureau 1070Toronto (Ontario) M5C 2C5Brian E. Divell, Agentprincipal.

Incendie, accidents, aéronefs saufl’assurance responsabilité contrela perte et les dommages causésauxpersonnespar un aéronef oupar l’utilisation ou lefonctionnement d’un aéronef,automobile, biens immeubles,biens meubles, brise desglaces,chaudières, explosions, faux,garantie, machines, transportsterrestres, tremblements de terre,vol et catégories additionnelles 3,4, 5, 7, 8, 9 et 10. (VoirRemarque (B))

Pictou County Farmers’ Mutual FireInsurance Company

P.O. Box 130Pictou, Nova Scotia B0K 1H0Heather Smith, Secretary-Treasurer.

Property and Liability, restricted tothe Province of Nova Scotia.

Pictou County Farmers’ Mutual FireInsurance Company

C.P. 130Pictou (Nouvelle-Écosse) B0K 1H0Heather Smith, Secrétaire-trésorier.

Biens et responsabilité, limitée à laprovince de la Nouvelle-Écosse.

Pierce National Life Insurance Company1145 Nicholson Road, Unit 2Newmarket, Ontario L3Y 7V1Colleen Sexsmith, Chief Agent.

Life. Pierce National Life Insurance Company1145, chemin Nicholson, Unité 2Newmarket (Ontario) L3Y 7V1Colleen Sexsmith, Agentprincipal.

Vie.

Pohjola Group Insurance Corporation1801 McGill College Avenue, Suite 710Montréal, Quebec H3A 3P5René Lapierre, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Liability andSurety, limited to the business ofreinsurance and to the servicingof existing policies.

Pohjola Group Insurance Corporation1801, av. McGill College, Bureau 710Montréal (Québec) H3A 3P5René Lapierre, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,automobile, chaudières etmachines, détournements,responsabilité et caution,limitées aux affaires deréassurance et limitées àl’écoulement despolicesexistantes.

Pool Insurance Company220 Portage Ave., Suite 1007Royal Bank BuildingWinnipeg, Manitoba R3C 0A5Charles H. Swanson, President.

Property. Pool Insurance Company220, av. Portage, Bureau 1007Édifice Royal BankWinnipeg (Manitoba) R3C 0A5Charles H. Swanson, Président.

Biens.

Page 64: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

32 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

The Portage la Prairie Mutual InsuranceCompany

P.O. Box 340749 Saskatchewan Avenue EastPortage la Prairie, Manitoba R1N 3B8H. G. Owens, President.

Property, Automobile, Legalexpense and Liability.

The Portage la Prairie Mutual InsuranceCompany

C.P. 340, 749, av. Saskatchewan EstPortage la Prairie (Manitoba) R1N 3B8H. G. Owens, Président.

Biens, automobile, fraisjuridiqueset responsabilité.

Primerica Life Insurance Companyof Canada

2000 Argentia Road,Plaza V, Suite 300Mississauga, Ontario L5N 2R7Glenn J. Williams, Executive Vice-

President and Chief Executive Officer.

Life, Accident and sickness. Voir-La Compagnie d’Assurance-ViePrimerica du Canada.

Principal Life Insurance Company68 Scollard Street, 2nd FloorToronto, Ontario M5R 1G2John Milnes, Chief Agent.

Life, Accident and sickness, on thecondition that if in thetransaction of its business inCanada the foreign companyuses a French name, that nameshall be “Compagnied’assurance-vie Principal”.

Voir-Compagnie d’assurance-vie Principal

Progressive Casualty Insurance Company200 Yorkland Blvd., 5th FloorWillowdale, Ontario M2J 5C1Ms. Anderson, Chief Agent.

Property, Automobile, Liabilityand Surety.

Progressive Casualty Insurance Company200, boul. Yorkland, 5e étageWillowdale (Ontario) M2J 5C1Ms. Anderson, Agentprincipal.

Biens, automobile, responsabilitéet caution.

Progressive Casualty Insurance Companyof Canada

200 Yorkland Blvd., 5th FloorWillowdale, Ontario M2J 5C1William J. Conner III,President.

Property, Liability, Automobileand Surety.

Progressive du Canada Compagnied’Assurance Générale

200, boul. Yorkland, 5e étageWillowdale (Ontario) M2J 5C1William J. Conner III,Président.

Biens, responsabilité, automobileet caution.

Protective Insurance Company68 Scollard Street, 2nd FloorToronto, Ontario M5R 1G2John R. Milnes, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Automobile and Liability.

La Protectrice, société d’assurance68, rue Scollard, 2e étageToronto (Ontario) M5R 1G2John R. Milnes, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,automobile et responsabilité.

Providence Washington Insurance Company155 University Avenue, Suite 1703Toronto, Ontario M5H 3B7Jack Gorman Dovey, Chief Agent.

Property, Automobile andLiabilit y.

Providence Washington Insurance Company155, av. University, Bureau 1703Toronto (Ontario) M5H 3B7Jack Gorman Dovey, Agentprincipal.

Biens, automobile etresponsabilité.

Provident Life and Accident InsuranceCompany

5420 North Service RoadP.O. Box 5044Burlington, Ontario L7R 4C1George A. Shell, Chief Agent.

Life, Accident and sickness. Provident Compagnie d’Assurance-vieet Accident

5420, chemin North ServiceC.P. 5044Burlington (Ontario) L7R 4C1George A. Shell, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie.

The Prudential Assurance Company Limited(of England)

c/o Stikeman, ElliottSuite 5300, Commerce Court WestToronto, Ontario M5L 1B9W. Brian Rose, Chief Agent.

Life, Accident and sickness,limited to the servicing ofpolicies issuedprior toFebruary 28, 1995.

The Prudential Assurance Company Limited(of England)

a/s Stikeman, ElliottBureau 5300, Commerce Court WestToronto (Ontario) M5L 1B9W. Brian Rose, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie, limitée àla gestion despolices émisesavant le 28 février 1995.

The Prudential Insurance Companyof America

300 Consilium Place, Suite 1200Toronto, Ontario M1H 3G2Brian G. Barbeau, Chief Agent.

Life, Accident and sickness, on thecondition that if, in thetransaction of its business inCanada, the Company uses aFrench name, that name shall be“La Prudentielle d’Amérique,Compagnie d’Assurance”.

La Prudentielle d’Amérique, Compagnied’Assurance

300,place Consilium, Bureau 1200Toronto (Ontario) M1H 3G2Brian G. Barbeau, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie, à laconditionque, si la Compagnieutilise un nom français dans sesaffaires au Canada, ce nom serait« La Prudentielle d’Amérique,Compagnie d’Assurance ».

Prudential of America Life InsuranceCompany (Canada)

200 Front Street West, Suite 2300Toronto, Ontario M5V 3K6Ronald Meredith-Jones, President and

Chief Executive Officer.

Life, Accident and sickness. La Prudentielle d’Amérique, Compagnied’Assurance-Vie (Canada)

200, rue Front Ouest, Bureau 2300Toronto (Ontario) M5V 3K6Ronald Meredith-Jones, Président et chef

de la direction.

Vie, accidents et maladie.

Quebec Assurance Company3500 de Maisonneuve Blvd. West2 place Alexis-Nihon, Suite 800Montréal, Quebec H3Z 3C1Robert John Gunn, President.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Liability andSurety.

Voir-Compagnie d’Assurance du Québec

Page 65: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 33

RBC General Insurance Company55 City Centre Drive, Suite 1100Mississauga, Ontario L5B 1M3Andrew Rogacki, President and Chief

Executive Officer

Property, Accident and sickness,Automobile and Liability.

Voir-Compagnie d’assurancegénérale RBC

RBC Life Insurance Company55 City Centre Drive, Suite 1100Mississauga, Ontario L5B 1M3W. Grant Hardy, President and

Chief Executive Officer.

Life, Accident and sickness. Voir-Compagnie d’assurance vie RBC

Reliable Life Insurance CompanyP.O. Box 557, 100 King St. WestHamilton, Ontario L8N 3K9Richard A. Hine, President and

Chief Executive Officer.

Life, Accident and sickness. La Reliable, Compagnie d’Assurance-VieC.P. 557, 100, rue King OuestHamilton (Ontario) L8N 3K9Richard A. Hine, Président et

chef de la direction.

Vie, accidents et maladie.

Reliance Insurance Company200 King St. WestSuite 1906, P.O. Box 61Toronto, Ontario M5H 3T4Arthur Denis Joseph Morin, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Liability andSurety.

Reliance Insurance Company200, rue King OuestBureau 1906, C.P. 61Toronto (Ontario) M5H 3T4Arthur Denis Joseph Morin, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,accidents d’aviation, automobile,chaudières et machines, abus deconfiance, responsabilité etcaution.

ReliaStar Life Insurance Company3650 Victoria Park Ave., Suite 201North York, Ontario M2H 3P7V. Lorraine Williams, Chief Agent.

Life, Accident and sickness,limited to the business ofreinsurance, except that theforeign company may alsoprovide insurance on the lives ofresidents of Canada insuredundergroup policies issued inthe United States, and on thecondition that if the foreigncompany uses a French name,the name shall be “CompagnieD’Assurance-Vie ReliaStar”.

Voir-Compagnie D’Assurance-Vie ReliaStar.

RGA Life Reinsurance Company of Canada55 University Avenue, Suite 1200Toronto, Ontario M5J 2H7André St-Amour, President and Chief

Executive Officer.

Life, Accident and sickness,limited to the business ofreinsurance.

RGA Compagnie de réassurance-vie duCanada

55, av. University, Bureau 1200Toronto (Ontario) M5J 2H7André St-Amour, Président et chef

de la direction.

Vie, accidents et maladie, limitéeaux affaires de réassurance.

Rhine Reinsurance Company Limited55 University AvenueSuite 900, P.O. Box 6Toronto, Ontario M5J 2H7Patrick J. King, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Hail,Liabilit y and Surety, limited tothe business of reinsurance.

Rhin Réassurance S.A.55, avenue UniversityBureau 900, C.P. 6Toronto (Ontario) M5J 2H7Patrick J. King, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,automobile, chaudières etmachines, détournements,grêle,responsabilité et caution, limitéeaux affaires de réassurance.

Royal & Sun Alliance Life InsuranceCompany of Canada

277 Lakeshore Road East, Suite 300Oakville, Ontario L6J 1H9Clive S. Smith, President and Chief

Executive Officer.

Life, Accident and sickness. Royal & Sun Alliance du Canada, sociétéd’assurance-vie.

277, chemin Lakeshore Est, Bureau 300Oakville (Ontario) L6J 1H9Clive S. Smith, Président et chef

de la direction.

Vie, accidents et maladie.

Royal & Sun Alliance InsuranceCompany of Canada

10 Wellington St. EastToronto, Ontario M5E 1L5Robert John Gunn, President.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Hail, Legal,Liabilit y and Surety.

Royal & Sun Alliance du Canada,société d’assurances

10, rue Wellington EstToronto (Ontario) M5E 1L5Robert John Gunn, Président.

Biens, accidents et maladie,aériennes, automobile,chaudières et machines,détournements,grêle, fraisjuridiques, responsabilité etcaution.

Royal Maccabees Life Insurance Company176 University Avenue West, Suite 600Windsor, Ontario N9A 5P1Frederic G. Farrell, Q.C., Chief Agent.

Life, Accident and sickness,limited to the servicing ofpolicies issuedprior toJune 1, 1992.

Royal Maccabees Life Insurance Company176, av. University Ouest, Bureau 600Windsor (Ontario) N9A 5P1Frederic G. Farrell, C.R., Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie, sousréserve de la restrictionque lesaffaires de la compagnie soientlimitées à l’écoulement despolices émises avant le1er juin 1992.

Royale Belge425 de Maisonneuve Blvd. WestSuite 1200Montréal, Quebec H3A 3G5Harvey Campbell, Chief Agent.

Life, limited to the business ofreinsurance.

Royale Belge425, boul. de Maisonneuve OuestBureau 1200Montréal (Québec) H3A 3G5Harvey Campbell, Agentprincipal.

Vie, limitée aux affaires deréassurance.

Page 66: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

34 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

SAFECO Insurance Company of Americac/o Fasken, Campbell, GodfreyToronto-Dominion BankTowerToronto-Dominion Centre, P.O. Box 20Toronto, Ontario M5K 1N6Robert M. Sutherland, Q.C., Chief Agent.

Property, Automobile, Fidelity,Liabilit y and Surety, limited tothe servicing of existing policies.

SAFECO Insurance Company of Americaa/s Fasken, Campbell, GodfreyToronto-Dominion BankTowerToronto-Dominion Centre, C.P. 20,Toronto (Ontario) M5K 1N6Robert M. Sutherland, C.R., Agent

principal.

Biens, automobile, abus deconfiance, responsabilité etcaution, limitée àl’administration despolicesexistantes.

SAFR PartnerRe130 King Street WestSuite 2300, P.O. Box 166Toronto, Ontario M5X 1C7P. Lacourte, Chief Agent.

Life, Property, Accident andsickness, Aircraft, Automobile,Boiler and machinery, Credit,Fidelity, Hail, Liability andSurety, limited to the business ofreinsurance.

SAFR PartnerRe130, rue King OuestBureau 2300, C.P. 166Toronto (Ontario) M5X 1C7P. Lacourte, Agentprincipal.

Vie, biens, accidents et maladie,aériennes, automobile,chaudières et machines, crédit,détournements,grêle,responsabilité et caution,limitées aux affaires deréassurance.

Saskatchewan Mutual Insurance Company279–3rd Avenue NorthSaskatoon, Saskatchewan S7K 2H8Randy W. Trost, President.

Property, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity and Liability.

Saskatchewan Mutual Insurance Company279, 3e Avenue NordSaskatoon (Saskatchewan) S7K 2H8Randy W. Trost, Président.

Biens, automobile, chaudières etmachines, détournements etresponsabilité.

SCOR Canada Reinsurance CompanyBCE Place, 161 Bay Street, Suite 5000Toronto, Ontario M5J 2T7Dominique Lavallee, President and Chief

Executive Officer.

Property, Accident and sickness,Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Hail,Liabilit y and Surety, limited tothe business of reinsurance.

SCOR Canada Compagnie de RéassurancePlace BCE, 161, rue Bay, Bureau 5000Toronto (Ontario) M5J 2T7Dominique Lavallee, Président et chef

de la direction.

Biens, accidents et maladie,automobile, chaudières etmachines, détournements,grêle,responsabilité et caution, limitéeaux affaires de réassurance.

SCOR Reinsurance CompanyBCE Place, 161 Bay Street, Suite 5000Toronto, Ontario M5J 2T7Jaya Narayan, Chief Agent.

Property, Automobile, Aircraft,Fidelity, Liability and Surety,limited to the business ofreinsurance.

SCOR, Compagnie de RéassurancePlace BCE, 161, rue Bay, Bureau 5000Toronto (Ontario) M5J 2T7Jaya Narayan, Agentprincipal.

Biens, automobile, aériennes,détournements, responsabilité etcaution, limitée aux affaires deréassurance.

SCOR Vie1250 René-Lévesque blvd. WestSuite 4510Montreal, Quebec H3B 4W8Jacques Sabourin, Chief Agent.

Life, Accident and sickness,limited to the business ofreinsurance.

SCOR Vie1250, boul. René-Lévesque OuestBureau 4510Montréal (Québec) H3B 4W8Jacques Sabourin, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie, limitéeaux affaires de réassurance.

Scotia General Insurance Company100 Yonge St., Suite 400Toronto, Ontario M5H 1H1O. Zimmerman, President and Chief

Executive Officer.

Property, Accident and sickness,Automobile and Legal expense.

Scotia Générale, compagnie d’assurance100, rue Yonge, Bureau 400Toronto (Ontario) M5H 1H1O. Zimmerman, Président et chef

de la direction.

Biens, accidents et maladie,automobile et fraisjuridiques.

Scotia Life Insurance CompanyScotia Plaza, 44 King Street WestToronto, Ontario M5H 1H1Oscar Zimmerman, President and

Chief Executive Officer.

Life, Accident and sickness. Scotia-Vie compagnie d’assuranceScotia Plaza, 44, rue King OuestToronto (Ontario) M5H 1H1Oscar Zimmerman, Président et chef

de la direction.

Vie, accidents et maladie.

Seaboard Life Insurance Company2165 Broadway West, P.O. Box 5900Vancouver, British Columbia V6B 5H6Robert T. Smith, President and Chief

Executive Officer.

Life, Accident and sickness,limited to the servicing ofpolicies issuedprior toMay 31, 1999.

Voir-Compagnie d’Assurance-vie Seaboard

Security Insurance Company of Hartford155 University Avenue, Suite 702Toronto, Ontario M5H 3B7Peter Needra, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Automobile and Liability.

Security Insurance Company of Hartford155, av. University, Bureau 702Toronto (Ontario) M5H 3B7Peter Needra, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,automobile et responsabilité.

Security National Insurance Company50 Place Crémazie, 12th FloorMontréal, Quebec H2P 1B6Alain Thibault, President and Chief

Operating Officer.

Property, Accident and sickness,Automobile and Liability.

Sécurité Nationale Compagnie d’Assurance50,place Crémazie, 12e étageMontréal (Québec) H2P 1B6Alain Thibault, Président et chef

de l’exploitation.

Biens, accidents et maladie,automobile et responsabilité.

Sentry Insurance a Mutual Company133 Richmond St. West, Suite 600Toronto, Ontario M5H 2L3Donald G. Smith, Chief Agent.

Property, Aircraft, restricted to theservicing of business assumedfrom Middlesex InsuranceCompany, Automobile, Boilerand machinery, Fidelity, Liabilityand Surety.

Sentry Insurance a Mutual Company133, rue Richmond Ouest, Bureau 600Toronto (Ontario) M5H 2L3Donald G. Smith, Agentprincipal.

Biens, accidents d’aviation limitéeau maintien des affairesassuméespar MiddlesexInsurance Company, automobile,chaudières et machines, abus deconfiance, responsabilité etcaution.

Skandia Insurance Company Ltd.c/o D. M. Williams & Associates Ltd.3650 Victoria Park Ave., Suite 201North York, Ontario M2H 3P7V. Lorraine Williams, Chief Agent.

Property, Aircraft, Automobile,Boiler and machinery, Fidelity,Liabilit y and Surety, limited tothe servicing of existing policies.

Skandia Société Anonyme d’Assurancesa/s D. M. Williams & Associates Ltd.3650, av. Victoria Park, Bureau 201North York (Ontario) M2H 3P7V. Lorraine Williams, Agentprincipal.

Biens, aériennes, automobile,chaudières et machines,détournements, responsabilité etcaution, limitée à l’écoulementdespolices existantes.

Page 67: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 35

See-CUNA Mutual Insurance Society La Société d’Assurance CUNA Mutuelle151, chemin North ServiceC.P. 5065Burlington (Ontario) L7R 4C2T. Michael Porter, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie, limitée àla souscription d’assurance desmembres des coopératives decrédit, et la Compagnie peututiliser dans les affaires auCanada son nom en anglais« CUNA Mutual InsuranceSociety » ou son nom en français« La Société d’Assurance CUNAMutuelle », ou tous deux à lafois.

See-Ecclesiastical Insurance Office PublicLimited Company

Société des AssurancesÉcclésiastiquesC.P. 2401, Bureau 502, 2300, rue YongeToronto (Ontario) M4P 1E4Stephen Malcolm Oxley, Agentprincipal.

Biens, automobile, chaudières etmachines, abus de confiance etresponsabilité à la conditionquesi la compagnie utilise un nomfrançais dans les affaires auCanada, ce nom serait « Sociétédes AssurancesÉcclésiastiques ».

See-Employers Insurance of Wausaua Mutual Company

Société d’assurance mutuelle desemployeurs de Wausau

a/s D. M. Williams & Associates Ltd.3650, av. Victoria Park, Bureau 201North York (Ontario) M2H 3P7V. Lorraine Williams, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,accidents d’aviation, automobile,chaudières et machines, abus deconfiance, responsabilité etcaution à la conditionque, si lacompagnie utilise un nomfrançais dans les affaires auCanada, ce nom serait « Sociétéd’assurance mutuelle desemployeurs de Wausau ».

See-TIG Insurance Company Société d’Assurance TIGa/s Canadian Insurance Consultants Inc.133, rue Richmond Ouest, Bureau 600Toronto (Ontario) M5H 2L3Donald G. Smith, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,automobile, chaudières etmachines, détournements,responsabilité et caution.

See-CompCorp Life Insurance Company Société d’assurance vie SIAP1, rue Queen Est, Bureau 1700Toronto (Ontario) M5C 2X9Gordon M. Dunning, Président et

chef de la direction.

Vie, accidents et maladie, dans lamesure autoriséepar son acteconstitutif.

See-Manulife Financial Corporation. Société Financière Manuvie200, rue Bloor EstToronto (Ontario) M4W 1E5Dominic D’Alessandro, Président

et chef de la direction.

Vie.

Sorema North America ReinsuranceCompany

70 York Street, Suite 1520Toronto, Ontario M5J 1S9Angus Ross, Chief Agent

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Hail,Liabilit y and Surety, limited tothe business of reinsurance.

Sorema North America ReinsuranceCompany

70, rue York, Bureau 1520Toronto (Ontario) M5J 1S9Angus Ross, Agentprincipal

Biens, accidents et maladie,aériennes, automobile,chaudières et machines,détournements,grêle,responsabilité et caution, limitéeaux affaires de réassurances.

See-Lloyd’s Underwriters. Les Souscripteurs du Lloyd’s1155, rue Metcalfe, Bureau 1540Montréal (Québec) H3B 2V6Mark J. Oppenheim, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,aériennes, automobile,chaudières et machines, crédit,détournements,grêle, fraisjuridiques, responsabilité etcaution.

The Sovereign General Insurance Company855–2nd Avenue S.W., Suite 2200Calgary, Alberta T2P 4J8G. T. Squire, President.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Credit, Fidelity, Hail,Liabilit y and Surety.

La Souveraine, Compagnie d’AssuranceGénérale

855, 2e Avenue Sud-ouest, Bureau 2200Calgary (Alberta) T2P 4J8G. T. Squire, Président.

Biens, accidents et maladie,accidents d’aviation, automobile,crédit, chaudières et machines,abus de confiance,grêle,responsabilité et caution.

Page 68: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

36 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

The Sovereign Life Insurance CompanySuite 1200, Bow Valley Square II205-5th Avenue S.W.Calgary, Alberta T2P 4B9Robert O. Sanderson, President,

KPMG Inc.Agent for the Superintendent ofFinancial Institutions, ProvisionalLiquidator.

Life, Accident and sickness.On December 21, 1992 theSuperintendent of FinancialInstitutions took control of TheSovereign Life InsuranceCompany and the courtgranted awinding-up order appointing theSuperintendent asprovisionalliquidator of the company.KPMG Inc. acting as agent forthe liquidator, isproceeding withthe winding up of the company’saffairs.

La Souveraine, Compagnie d’Assurance-VieBureau 1200, Bow Valley Square II205, 5e Avenue Sud-ouestCalgary (Alberta) T2P 4B9Robert O. Sanderson, Président,

KPMG Inc.Mandataire du surintendant desinstitutions financières, liquidateurprovisoire.

Vie, accidents et maladie.Le 21 décembre 1992, lesurintendant des institutionsfinancières apris le contrôle deLa Souveraine, Compagnied’Assurance-Vie et la couraccordait une ordonnance deliquidation nommant lesurintendant au titre deliquidateurprovisoire de lasociété. Le cabinet KPMG Inc.,le mandataire du liquidateur, secharge desprocédures deliquidation de la société.

St. Paul Fire and Marine Insurance Company121 King Street WestSuite 1200, P.O. Box 93Toronto, Ontario M5H 3T9Wayne McKellar Edmondson, Chief

Agent.

Property, Aircraft, Automobile,Boiler and machinery, Fidelity,Liabilit y and Surety, on thecondition that if in thetransaction of its business inCanada, the Company uses aFrench name, that name shall be“La Compagnie d’AssuranceSaint Paul”.

Voir-La Compagnie d’Assurance Saint Paul

The Standard Life Assurance Company1245 Sherbrooke St. WestMontréal, Quebec H3G 1G3Claude A. Garcia, Chief Agent.

Life, Accident and sickness andthe Company may use in itstransaction of its business inCanada its name in English “TheStandard Life AssuranceCompany” or its name in French“Compagnie d’assuranceStandard Life”, or both suchnames.

Voir-Compagnie d’assurance Standard Life

The Standard Life Assurance Companyof Canada

1245 Sherbrooke St. WestMontréal, Quebec H3G 1G3Claude A. Garcia, President and

Chief Operating Officer.

Life. Voir-Compagnie d’assurance Standard Lifedu Canada

State Farm Fire and Casualty Company100 Consilium Place, Suite 102Scarborough, Ontario M1H 3G9Robert J. Cooke, Chief Agent.

Property, Aircraft, Automobile,Boiler and machinery, Fidelity,Liabilit y and Surety.

State Farm Fire and Casualty Company100,place Consilium, Bureau 102Scarborough (Ontario) M1H 3G9Robert J. Cooke, Agentprincipal.

Biens, aériennes, détournements,automobile, caution, chaudièreset machines et responsabilité.

State Farm Life Insurance Company100 Consilium Place, Suite 102Scarborough, Ontario M1H 3G9Robert J. Cooke, Chief Agent.

Life. State Farm Life Insurance Company100,place Consilium, Bureau 102Scarborough (Ontario) M1H 3G9Robert J. Cooke, Agentprincipal.

Vie.

State Farm Mutual Automobile InsuranceCompany

100 Consilium Place, Suite 102Scarborough, Ontario M1H 3G9Robert J. Cooke, Chief Agent.

Automobile and Personal accident. State Farm Mutual Automobile InsuranceCompany

100,place Consilium, Bureau 102Scarborough (Ontario) M1H 3G9Robert J. Cooke, Agentprincipal.

Accidents corporels et automobile.

Stewart Title Guaranty Companyc/o Encon Insurance Managers Inc.350 Albert Street, Suite 700Ottawa, Ontario K1R 1A4Denis Shillington, Chief Agent.

Title. Stewart Title Guaranty Companya/s Encon Insurance Managers Inc.350, rue Albert, Bureau 700Ottawa (Ontario) K1R 1A4Denis Shillington, Agentprincipal.

Titres.

Suecia Reinsurance Company18 King St. East, Suite 1402Toronto, Ontario M5C 1C4J. Leo Daly, President.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Hail,Liabilit y and Surety, limited tothe business of reinsurance, andto the servicing of existingpolicies.

Voir-Compagnie de réassurance Suecia

See-Swiss Re Life & Health Canada Suisse de Réassurances Vie etSanté Canada.

161, rue Bay, Bureau 3000Canada Trust TowerToronto (Ontario) M5J 2T6Ann F. Godbehere, Chef de

la direction.

Vie, accidents et maladie, limitéeaux affaires de réassurance.

Page 69: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 37

The Sumitomo Marine and Fire InsuranceCompany, Limited

1 Adelaide Street EastToronto, Ontario M5C 2V9Janice M. Tomlinson, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Liability andSurety.

The Sumitomo Marine and Fire InsuranceCompany, Limited

1, rue Adelaide EstToronto (Ontario) M5C 2V9Janice M. Tomlinson, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,automobile, chaudières etmachines, abus de confiance,responsabilité et caution.

Sun Life Assurance Company of Canada150 King St. WestToronto, Ontario M5H 1J9John D. McNeil, Chairman and

Chief Executive Officer.

Life, Personal accident andSickness.

Sun Life du Canada, compagnied’assurance-vie

150, rue King OuestToronto (Ontario) M5H 1J9John D. McNeil, Président du conseil

et chef de la direction.

Vie, accidents corporels etmaladie.

Sun Life Financial Services of Canada Inc.150 King St. WestToronto, Ontario M5H 1J9Donald A. Stewart, Chairman and

Chief Executive Officer.

Life. Voir-Financière Sun Life du Canada inc.

Sun Life of Canada Group AssuranceCompany

225 King Street WestToronto, Ontario M5V 3C5Marcel Gingras, President.

Life, Accident and sickness,limited to the servicing ofpolicies issuedprior toJanuary 1, 1995.

Sun Life du Canada, compagnie d’assurancegroupe

225, rue King OuestToronto (Ontario) M5V 3C5Marcel Gingras, Président.

Vie, accidents et maladie, limitée àla gestion despolices émisesavant le 1er janvier 1995.

Superior Life Insurance Company6205 Airport RoadSuite 100, Building BMississauga, Ontario L4V 1E1Lee Mayer, Chief Agent.

Life, on the condition that in thetransaction of its business inCanada the company uses thename “Superior Life InsuranceCompany”, the name assumed byLincoln Heritage Life InsuranceCompany to transact business inCanada.

Superior Life Insurance Company6205, chemin AirportBureau 100,Édifice BMississauga (Ontario)L4V 1E1Lee Mayer, Agentprincipal.

Vie, pourvuque la société utilise ladénomination « Superior LifeInsurance Company », le nomadopté par Lincoln Heritage LifeInsurance Company dans lecadre de l’exercice de sonactivité au Canada.

Swiss Re Italia S.p.A.1801 McGill College Avenue,Suite 710Montréal, Quebec H3A 3P5René Lapierre, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Automobile, Fidelity, Hail,Liabilit y and Surety, limited tothe business of reinsurance.

Swiss Re Italia S.p.A.1801, av. McGill College, Bureau 710Montréal (Québec) H3A 3P5René Lapierre, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,automobile, détournements,grêle, responsabilité et caution,limitée aux affaires deréassurance.

Swiss Re Life & Health America Inc.161 Bay Street, Suite 3000Canada Trust TowerToronto, Ontario M5J 2T6Ann F. Godbehere, Chief Agent.

Life, Accident and sickness,limited to the servicing ofreinsurance contracts.

Swiss Re Life & Health America Inc.161, rue Bay, Bureau 3000Canada Trust TowerToronto (Ontario) M5J 2T6Ann F. Godbehere, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie, limitée àl’administration des contrats deréassurance.

Swiss Re Life & Health Canada161 Bay Street, Suite 3000Canada Trust TowerToronto, Ontario M5J 2T6Ann F. Godbehere, Chief

Executive Officer.

Life, Accident and sickness,limited to the business ofreinsurance.

Voir-Suisse de Réassurances Vie et SantéCanada.

Swiss Reinsurance CompanyLife Branch

161 Bay Street, Suite 3000Canada Trust TowerToronto, Ontario M5J 2T6Ann F. Godbehere, Chief Agent.

Property and Casualty Branch150 King Street WestP.O. Box 50, Suite 2200Toronto, Ontario M5H 1J9Patrick Mailoux, Chief Agent.

Life, Property, Accident andsickness, Aircraft, Automobile,Boiler and machinery, Credit,Fidelity, Hail, Legal expense,Liabilit y and Surety, limited tothe business of reinsurance.

Swiss Reinsurance CompanyVie

161, rue Bay, Bureau 3000Canada Trust TowerToronto (Ontario) M5J 2T6Ann F. Godbehere, Agentprincipal.

Biens et risques divers150, rue King OuestC. P. 50, Bureau 2200Toronto (Ontario) M5H 1J9Patrick Mailoux, Agentprincipal.

Vie, biens, accidents et maladie,accidents d’aviation, automobile,chaudières et machines, crédit,abus de confiance,grêle, fraisjuridiques, responsabilité etcaution, limitée aux affaires deréassurance.

Swiss Reinsurance Company Canada150 King Street WestP.O. Box 50, Suite 2200Toronto, Ontario M5H 1J9Patrick Mailoux, President and Chief

Executive Officer.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Credit, Fidelity, Hail,Legal expense, Liability,Mortgage and Surety, limited tothe business of reinsurance.

Voir-Compagnie Suisse de RéassuranceCanada.

TBD Life Insurance Company200 Bloor Street EastToronto, Ontario M4W 1E5Peter S. Hutchison, Vice-President and

Chief Financial Officer.

Life, Accident and sickness,limited to the servicing ofpolicies issuedprior toJanuary 1, 1995.

TBD Compagnie d’Assurance Vie200, rue Bloor EstToronto (Ontario) M4W 1E5Peter S. Hutchison, Vice-président et

chef des services financiers.

Vie, accidents et maladie, limitée àla gestion despolices émisesavant le 1er janvier 1995.

Page 70: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

38 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

Temple Insurance Company390 Bay Street, Suite 2300Toronto, Ontario M5H 2Y2John P. Phelan, President and

Chief Executive Officer.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Credit, Fidelity, Hail,Legal expense, Liability andSurety.

Voir-La compagnie d’assurance Temple

Terra Nova Insurance Company Limitedc/o Cassels, Brock & BlackwellScotia Plaza, Suite 210040 King St. WestToronto, Ontario M5H 3C2J. Brian Reeve, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Liability,Hail and Surety, limited to thebusiness of reinsurance.

Terra Nova Insurance Company Limiteda/s Cassels, Brock & BlackwellScotia Plaza, Bureau 210040, rue King OuestToronto (Ontario) M5H 3C2J. Brian Reeve, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,automobile, chaudières etmachines, détournements,responsabilité,grêle et caution,limitée aux affaires deréassurance.

TIG Insurance Companyc/o Canadian Insurance Consultants Inc.133 Richmond St. West, Suite 600Toronto, Ontario M5H 2L3Donald G. Smith, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Liability andSurety.

Voir-Société d’Assurance TIG

The Toa Reinsurance Company of AmericaOne Queen Street East, Suite 2606,Toronto, Ontario M5C 2W5David E. Wilmot, Chief Agent

Property, Accident and sickness,Automobile, Boiler andmachinery, Credit, Fidelity, Hail,Liabilit y and Surety, limited tothe business of reinsurance, andon the condition that, if in thetransaction of its business inCanada, the company uses aFrench form of name, that nameshall be “La Compagnie deréassurance Toa d’Amérique”.

Voir-La Compagnie de réassurance Toad’Amérique.

The Tokio Marine and Fire InsuranceCompany, Limited

105 Adelaide Street West, 3rd FloorToronto, Ontario M5H 1P9Byron G. Messier, Chief Agent.

Property, Automobile, Aircraft,Boiler and machinery, Fidelity,Liabilit y and Surety.

The Tokio Marine and Fire InsuranceCompany, Limited

105, rue Adelaide Ouest, 3e étageToronto (Ontario) M5H 1P9Byron G. Messier, Agentprincipal.

Biens, automobile, aérienneschaudières et machines,détournements, responsabilité etcaution.

Toronto Dominion General InsuranceCompany

P.O. Box 1, Toronto Dominion Centre55 King Street West, 12th FloorToronto, Ontario M5K 1A2Nick Stitt, President and Chief

Executive Officer.

Property, Automobile andLiabilit y.

Toronto Dominion Compagnie d’AssuranceGénérale

C.P. 1, Centre Toronto Dominion55, rue King Ouest, 12e étageToronto (Ontario) M5K 1A2Nick Stitt, Président et chef

de la direction.

Biens, automobile etresponsabilité.

Toronto Dominion Life Insurance CompanyCommercial Union Tower,28th FloorToronto, Ontario M5K 1A2H. Dunbar Russel, President and Chief

Executive Officer.

Life, Accident and sickness. Toronto Dominion, Compagnied’assurance-vie

Tour Commercial Union, 28e étageToronto (Ontario) M5K 1A2H. Dunbar Russel, Président et chef

de la direction.

Vie, accident et maladie.

Toronto Mutual Life Insurance Company112 St. Clair Ave. WestToronto, Ontario M4V 2Y3Van M. Campbell, President and Chief

Executive Officer.

Life, Accident and sickness. Toronto Mutual Life Insurance Company112, av. St. Clair OuestToronto (Ontario) M4V 2Y3Van M. Campbell, Président et chef

de la direction.

Vie, accident et maladie.

Trade Indemnity P.L.C.320 March Road, Suite 103Kanata, Ontario K2K 2D3Ian Douglas Miller, Chief Agent.

Credit, limited to the servicing ofexisting policies.

Voir-Assurances Trade Indemnity

Traders General Insurance Company2206 Eglinton Ave. East, Suite 500Scarborough, Ontario M1L 4S8Mark Webb, Executive Vice President and

Chief Operating Officer.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Hail, Legalexpense, Liability and Surety.

Voir-Compagnie d’Assurance TradersGénérale

Trafalgar Insurance Company of Canada10 York Mills Road, Suite 700Toronto, Ontario M2P 2G5Robert E. Maynard, President and

Chief Executive Officer.

Property, Accident and sickness,Automobile, Boiler andmachinery and Liability.

Voir-Compagnie d’Assurance Trafalgardu Canada

Transamerica Life Insurance Companyof Canada

300 Consilium PlaceScarborough, Ontario M1H 3G2George A. Foegele, President and

Chief Executive Officer.

Life, Accident and sickness. Voir-Compagnie d’Assurance-VieTransamerica du Canada

Page 71: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 39

Transatlantic Reinsurance Company145 Wellington St. WestToronto, Ontario M5J 1H8Gary A. McMillan, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Hail,Liabilit y and Surety, limited tothe business of reinsurance.

Transatlantic Reinsurance Company145, rue Wellington OuestToronto (Ontario) M5J 1H8Gary A. McMillan, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,accidents d’aviation, automobile,chaudières et machines, abus deconfiance,grêle, responsabilité etcaution, limitée aux affaires deréassurances.

Transit Insurance Company5310 Explorer Drive, Suite 201Mississauga, Ontario L4W 5H9William Star, President.

Property, Automobile andLiabilit y, limited to the servicingof existing policies.

Voir-La Compagnie d’Assurance Transit

Travelers Casualty & Surety Companyof Canada

36 Toronto Street, Suite 1070Toronto, Ontario M5C 2C5Brian E. Divell, President and

Chief Executive Officer.

Property, Aircraft, Automobile,Boiler and machinery, Fidelity,Liabilit y and Surety.

Travelers, Compagnie d’assurancedommages et de cautionnementdu Canada

36, rue Toronto, Bureau 1070Toronto (Ontario) M5C 2C5Brian E. Divell, Président et

chef de la direction.

Biens, aériennes, automobile,chaudières et machines,détournements, responsabilité etcaution.

The Travelers Indemnity Company36 Toronto Street, Suite 1070Toronto, Ontario M5C 2C5Brian E. Divell, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Hail,Liabilit y and Surety.

The Travelers Indemnity Company36, rue Toronto, Bureau 1070Toronto (Ontario) M5C 2C5Brian E. Divell, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,accidents d’aviation, automobile,chaudières et machines, abus deconfiance,grêle, responsabilité etcaution.

The Travelers Insurance Company1145 Nicholson Road, Unit 2Newmarket, Ontario L3Y 7V1Colleen Sexsmith, Chief Agent.

Life, Accident and sickness. The Travelers Insurance Company1145, chemin Nicholson, Unité 2Newmarket (Ontario) L3Y 7V1Colleen Sexsmith, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie.

UAP-NewRotterdam InsuranceCompany N.V.

649 North Service Road WestBurlington, Ontario L7R 4L5John Conway Stradwick, Chief Agent.

Property, Automobile, Fidelity,Hail, Liability and Surety,limited to the servicing ofexisting policies.

UAP-NewRotterdam InsuranceCompany N.V.

649, chemin North Service OuestBurlington (Ontario) L7R 4L5John Conway Stradwick, Agentprincipal.

Biens, automobile, détournements,grêle, responsabilité et caution,limitée à l’écoulement despolices existantes.

Underwriters Insurance Companyc/o Fasken Campbell GodfreyToronto-Dominion CentreP.O. Box 20Toronto, Ontario M5K 1N6Robert W. McDowell, Chief Agent.

Property, Aircraft, Automobile,Boiler and machinery, Fidelity,Liabilit y and Surety.

Underwriters Insurance Companya/s Fasken Campbell GodfreyToronto-Dominion Centre, C.P. 20Toronto (Ontario) M5K 1N6Robert W. McDowell, Agentprincipal.

Biens, accidents d’aviation,automobile, chaudières etmachines, abus de confiance,responsabilité et caution.

Unifund Assurance Company95 Elizabeth Ave.St. John’s, Newfoundland A1B 1R7Paul Johnson, Chief Executive Officer.

Property, Accident and sickness,Automobile and Liability.

Unifund, Compagnie d’Assurance95, av. ElizabethSt. John’s (Terre-Neuve) A1B 1R7Paul Johnson, Administrateurprincipal.

Biens, accidents et maladie,automobile et responsabilité.

Unigard Security Insurance Companyc/o Price Waterhouse & Company601 West Hastings St.Vancouver, British Columbia V6B 5A5John D. Sapinsky, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Liability andSurety, limited to the servicing ofexisting policies.

Unigard Security Insurance Companya/s Price Waterhouse & Company601, rue West HastingsVancouver (Colombie-Britannique)V6B 5A5John D. Sapinsky, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,accidents d’aviation, automobile,chaudières et machines, abus deconfiance, responsabilité etcaution, limitée àl’administration despolicesexistantes.

Union Fidelity Life Insurance Company200 Wellington St. WestP.O. Box 166, Suite 400Toronto, Ontario M5V 3C7Alan K. Ryder, Chief Agent.

Life, Accident and sickness,limited to the servicing ofpolicies issuedprior toJanuary 1, 1999.

Voir-Compagnie d’Assurance-Vie UnionFidelity

United American Insurance Company145 King St. WestToronto, Ontario M5H 3X6Connie Vaccaro, Chief Agent.

Life, Personal accident andSickness.

United American Insurance Company145, rue King OuestToronto (Ontario) M5H 3X6Connie Vaccaro, Agentprincipal.

Vie, accidents corporels etmaladie.

United States Fidelity and GuarantyCompany

c/o John Milnes & Associates68 Scollard St., 2nd FloorToronto, Ontario M5R 1G2John Milnes, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Hail,Liabilit y and Surety, limited tothe servicing of existing policies.

United States Fidelity and GuarantyCompany

a/s John Milnes & Associates68, rue Scollard, 2e étageToronto (Ontario) M5R 1G2John Milnes, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,accidents d’aviation automobile,chaudières et machines, abus deconfiance,grêle, responsabilité etcaution, limitée àl’administration despolicesexistantes.

Page 72: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

40 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

UNUM Life I nsurance Company of America5420 North Service RoadP.O. Box 5044Burlington, Ontario L7R 4C1George A. Shell, Chief Agent.

Life, Accident and sickness, on thecondition that if in thetransaction of its business inCanada the Company uses aFrench name, that name shall be“L’UNUM d’Améri que,Compagnie d’Assurance-vie”.

L’UNUM d’Améri que, Compagnied’Assurance-vie

5420, chemin North ServiceC.P. 5044Burlington (Ontario) L7R 4C1George A. Shell, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie, à laconditionque lorsque lacompagnie utilise un nomfrançais dans l’exercice de sesactivités au Canada, ce nom soit« L’UNUM d’Améri que,Compagnie d’Assurance-vie ».

Utica Mutual Insurance Companyc/o CAS Accounting for Insurance Inc.Unit 2, 1145 Nicholson RoadNewmarket, Ontario L3Y 7V1Colleen Anne Sexsmith, Chief Agent.

Property, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity and Liability.

Utica Mutual Insurance Companya/s CAS Accounting for Insurance Inc.1145, chemin Nicholson, Unité 2Newmarket (Ontario) L3Y 7V1Colleen Anne Sexsmith, Agentprincipal.

Biens, automobile, chaudières etmachines, abus de confiance etresponsabilité.

Virginia Surety Company, Inc.7300 Warden Avenue, Suite 300Markham, Ontario L3R 0X3Dan C. Evans, Chief Agent.

Property, Automobile, Boiler andmachinery and Liabilityinsurance, on the condition thatif in the transaction of itsbusiness in Canada the companyuses a French form of name, thatname shall be “Compagnie desûreté Virginia Inc.”.

Voir-Compagnie de sûreté Virginia Inc.

Voyageur Insurance Company44 Peel Centre Dr., Suite 300Brampton, Ontario L6T 4M8Walter Schutte, President and Chief

Operating Officer.

Property, Accident and sickness. Voir-Compagnie d’Assurance Voyageur

Waterloo Insurance Company111 Westmount Rd. South, P.O. Box 2000Waterloo, Ontario N2J 4S4Noel G. Walpole, President and Chief

Executive Officer.

Property, Aircraft, Automobile,Boiler and machinery, Fidelity,Liabilit y and Surety.

Waterloo, Compagnie d’Assurance111, chemin Westmount SudC.P. 2000, Waterloo (Ontario) N2J 4S4Noel G. Walpole, Président et chef

de la direction.

Biens, aériennes, automobile,chaudières et machines,détournements, responsabilité etcaution.

The Wawanesa Mutual Insurance Company191 BroadwayWinnipeg, Manitoba R3C 3P1G. J. Hanson, President and Chief

Executive Officer.

Property, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Hail,Liabilit y and Surety.

The Wawanesa Mutual Insurance Company191, BroadwayWinnipeg (Manitoba) R3C 3P1G. J. Hanson, Président et chef

de la direction.

Biens, automobile, chaudières etmachines, abus de confiance,grêle, responsabilité et caution.

The Wawanesa Life Insurance Company191 BroadwayWinnipeg, Manitoba R3C 3P1G. J. Hanson, President and Chief

Executive Officer.

Life, Accident and sickness. Voir-La Compagnie d’Assurance-vieWawanesa

Wellington Insurance CompanyOne Concord GateDon Mills, Ontario M3C 3N6Yves Brouillette, President and Chief

Executive Officer.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Hail, Loss ofemployment, Liability andSurety.

Voir-Compagnie d’Assurance Wellington

Westbury Canadian Life Insurance CompanyP.O. Box 2918, 21 King St. WestHamilton, Ontario L8N 3R5W. Grant Hardy, President and

Chief Executive Officer.

Life, Accident and sickness. Westbury Canadienne, Compagnied’Assurance-Vie

C.P. 2918, 21, rue King OuestHamilton (Ontario) L8N 3R5W. Grant Hardy, Président et chef

de la direction.

Vie, accidents et maladie.

Western Assurance Company10 Wellington St. EastToronto, Ontario M5E 1L5Robert John Gunn, President.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Hail,Liabilit y and Surety.

Western Assurance Company10, rue Wellington EstToronto (Ontario) M5E 1L5Robert John Gunn, Président.

Biens, accidents et maladie,accidents d’aviation, automobile,chaudières et machines, abus deconfiance,grêle, responsabilité etcaution.

The Western Life Assurance Company112 St. Clair Ave. WestToronto, Ontario M4V 2Y3Van M. Campbell, President and Chief

Executive Officer.

Life, Accident and sickness limitedto the servicing of policies issuedprior to January 31, 1975.

Western Compagnie d’Assurance-Vie112, av. St. Clair OuestToronto (Ontario) M4V 2Y3Van M. Campbell, Président et chef

de la direction.

Vie, accidents et maladie limitéeau service despolices délivréesavant le 31janvier 1975.

Western Surety CompanyP.O. Box 527, 1874 Scarth Street20th FloorRegina, Saskatchewan S4P 2G8L. C. Ell, President.

Fidelity and Surety. Voir-La Compagnie de Sûreté de l’Ouest

Page 73: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 41

Winterthur Life Insurance Company1075 Bay St.Toronto, Ontario M5S 2W5Ernst Notz, Chief Agent.

Life, limited to the servicing ofreinsurance contracts enteredinto prior to January 15, 1996, onthe condition that if in thetransaction of its business inCanada the company uses ananglicized name, that name shallbe “Winterthur Life InsuranceCompany”.

Winterthur Société d’Assurance sur la Vie1075, rue BayToronto (Ontario) M5S 2W5Ernst Notz, Agentprincipal.

Vie, limitée à l’administration descontrats de réassurance conclusavant le 15janvier 1996, à laconditionque si la compagnieutilise un nom anglais dans lesaffaires au Canada, ce nom serait« Winterthur Life InsuranceCompany ».

The Yasuda Fire and Marine InsuranceCompany, Limited

Exchange Tower, 2 First Canadian Place12th Floor, P.O. Box 185Toronto, Ontario M5X 1A8Cynthia Santiago, Chief Agent.

Property, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Liability andSurety.

The Yasuda Fire and Marine InsuranceCompany, Limited

2 First Canadian PlaceExchange Tower, C.P. 185, 12e étageToronto (Ontario) M5X 1A8Cynthia Santiago, Agentprincipal.

Biens, automobile, chaudières etmachines, détournements,responsabilité et caution.

Zenith Insurance Companyc/o Lombard Canada Ltd.105 Adelaide Street WestToronto, Ontario M5H 1P9Byron G. Messier, President and Chief

Executive Officer.

Property, Automobile, andLiabilit y.

Voir-Compagnie d’assurance Zenith

Zurich Insurance Company(Zurich Versicherungs-Gesellschaft)

400 University Ave.Toronto, Ontario M5G 1S7Barry Gilway, Chief Agent.

Property, Accident and sickness,Aircraft, Automobile, Boiler andmachinery, Fidelity, Liability andSurety, and the company mayuse in the transacting of itsbusiness in Canada its name inEnglish “Zurich InsuranceCompany” or its name in French“Zurich Compagnied’Assurances”.

Zurich Compagnie d’Assurances(« Zurich » Versicherungs-Gesellschaft)

400, av. UniversityToronto (Ontario) M5G 1S7Barry Gilway, Agentprincipal.

Biens, accidents et maladie,aériennes, automobile,détournements, caution,chaudières et machines etresponsabilité, et la compagniepeut utiliser dans les affaires auCanada son nom en anglais« Zurich Insurance Company »ou son nom en français « ZurichCompagnie d’Assurances ».

Zurich Life Insurance Company of Canada400 University Ave., Suite 2500Toronto, Ontario M5G 1S7Barry J. Gilway, President and

Chief Executive Officer.

Life, Accident and sickness. Zurich du Canada compagnied’assurance-vie

400, av. University, Bureau 2500Toronto (Ontario) M5G 1S7Barry J. Gilway, Président et chef

de la direction.

Vie, accidents et maladie.

ACA ASSURANCE898 Sainte-Julie St.Trois-Rivières, Quebec G9A 1Y2Diane Lachance, Chief Agent.

Life, Accident and sickness, to theextent authorized by its Articlesof incorporation, Constitutionand Laws.

ACA ASSURANCE898, rue Sainte-JulieTrois-Rivières (Québec) G9A 1Y2Diane Lachance, Agentprincipal.

Vie, accident et maladie dans lamesure autoriséepar sa loiconstitutive, sa constitution etses règlements.

ACTRA Fraternal Benefit Society1000 Yonge St.Toronto, Ontario M4W 2K2Robert M. Underwood, President and

Chief Executive Officer.

Life, Accident and sickness to theextent authorized by itsinstrument of incorporation andby-laws.

Voir-La Société Fraternelle ACTRA

See-Sons of Scotland BenevolentAssociation

Association Bénévole des Fils de l’Écosse90, av. Eglinton Est, 7e étageToronto (Ontario) M4P 2Y3Mme Effie MacFie, Grand secrétaire-

trésorière.

Vie et maladie dans la mesureautoriséepar sa loi constitutive,sa constitution et ses règlements.

Canadian Professional Sales Association145 Wellington Street West, Suite 310Toronto, Ontario M5J 1H8T. J. Ruffell, President.

Life insurance to the extentauthorized by its Act ofincorporation, Constitution andLaws.

L’Association Canadienne desprofessionnels de la vente

145, rue Wellington Ouest, Bureau 310Toronto (Ontario) M5J 1H8T. J. Ruffell, Président.

Vie dans la mesure autoriséepar saloi constitutive, sa constitution etses règlements.

Canadian Slovak Benefit Society55 Barron StreetWelland, Ontario L3C 2K4Joseph Mamros, Secretary.

Life, Personal accident andSickness to the extent authorizedby its Act of incorporation,Constitution and Laws.

Voir-Société de Secours Mutuels desSlovaques du Canada

Canadian Slovak League1736 Dundas St. WestToronto, Ontario M6K 1V5Branislav Galat, Secretary.

Life to the extent authorized by itsAct of incorporation,Constitution and Laws.

Canadian Slovak League1736, rue Dundas OuestToronto (Ontario) M6K 1V5Branislav Galat, Secrétaire.

Vie dans la mesure autoriséepar saloi constitutive, sa constitution etses règlements.

Croatian Catholic Union of U.S.A.and Canada

3009 Dundas Street WestToronto, Ontario M6P 1Z4Ante M. Nikolic, Chief Agent.

Life, Accident and sickness to theextent authorized by its Articlesof incorporation, Constitutionand By-Laws.

Croatian Catholic Union of U.S.A.and Canada

3009, rue Dundas OuestToronto (Ontario) M6P 1Z4Ante M. Nikolic, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie dans lamesure autoriséepar sa loiconstitutive, sa constitution etses règlements.

Page 74: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

42 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

Croatian Fraternal Union of Americac/o Deloitte and Touche181 Bay Street, Suite 1400Toronto, Ontario M5J 2V1P. Wayne Musselman, Chief Agent.

Life, Accident and sickness to theextent authorized by its Articlesof incorporation, Constitutionand Laws.

Croatian Fraternal Union of Americaa/s Deloitte & Touche181, rue Bay, Bureau 1400Toronto (Ontario) M5J 2V1P. Wayne Musselman, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie dans lamesure autoriséepar sa loiconstitutive, sa constitution etses règlements.

The First Catholic Slovak LadiesAssociation of the United Statesof America

c/o John Milnes and Associates68 Scollard St., 2nd FloorToronto, Ontario M5R 1G2John R. Milnes, Chief Agent.

Life insurance to the extentauthorized by its Articles ofincorporation, Constitution andBy-Laws, limited to the servicingof policies issuedprior toJanuary 1, 1999.

The First Catholic Slovak LadiesAssociation of the United Statesof America

a/s John Milnes and Associates68, rue Scollard, 2e étageToronto (Ontario) M5R 1G2John R. Milnes, Agentprincipal.

Vie dans la mesure autoriséepar saloi constitutive, sa constitution etses règlements, limitée à lagestion despolices émises avantle 1er janvier 1999.

The First Catholic Slovak Union of theUnited States of America and Canada

c/o John Milnes and Associates68 Scollard St., 2nd FloorToronto, Ontario M5R 1G2John R. Milnes, Chief Agent.

Life insurance to the extentauthorized by its Articles ofincorporation, Constitution andLaws.

The First Catholic Slovak Union of theUnited States of America and Canada

a/s John Milnes and Associates68, rue Scollard, 2e étageToronto (Ontario) M5R 1G2John R. Milnes, Agentprincipal.

Vie dans la mesure autoriséepar saloi constitutive, sa constitution etses règlements.

The Grand Orange Lodge of British America94 Sheppard Ave. WestWillowdale, Ontario M2N 1M5D. A. Griffin, Secretary-Treasurer.

Life and Sickness to the extentauthorized by its Act ofincorporation, Constitution andLaws.

The Grand Orange Lodge of British America94, av. Sheppard OuestWillowdale (Ontario) M2N 1M5D. A. Griffin, Secrétaire-trésorier.

Vie et maladie dans la mesureautoriséepar sa loi constitutive,sa constitution et ses règlements.

The Independent Order of Foresters789 Don Mills Rd.Don Mills, Ontario M3C 1T9William J. Valiquette, Senior Vice-

President - Corporate Governance.

Life, Accident and sickness to theextent authorized by itsinstrument of incorporation,Constitution and Laws.

Voir-L’Ordre Indépendant des Forestiers

Knights of Columbus257 Pinnacle StreetBelleville, Ontario K8N 3B2Kerry J. Soden, Chief Agent.

Life insurance to the extentauthorized by its Act ofincorporation, Constitution andLaws.

Knights of Columbus257, rue PinnacleBelleville (Ontario) K8N 3B2Kerry J. Soden, Agentprincipal.

Vie dans la mesure autoriséepar saloi constitutive, sa constitution etses règlements.

Lutheran Life Insurance Society of Canada470 Weber St. NorthWaterloo, Ontario N2J 4G4James R. Widdecombe, Secretary.

Life, Accident and sickness to theextent authorized by itsinstrument of incorporation andby-laws.

Lutheran Life Insurance Society of Canada470, rue Weber NordWaterloo (Ontario) N2J 4G4James R. Widdecombe, Secrétaire.

Vie, accidents et maladie dans lamesure autoriséepar son acte deconstitution en corporation et sesrèglements.

The North West Commercial Travellers’Association of Canada

28 Main Street South, 2nd FloorP.O. Box 336Winnipeg, Manitoba R3C 2H6Terry D. Carruthers, General Manager

and Secretary.

Life insurance to the extentauthorized by its Act ofincorporation, Constitution andLaws.

The North West Commercial Travellers’Association of Canada

28, rue Main Sud, 2e étage, C.P. 336Winnipeg (Manitoba) R3C 2H6Terry D. Carruthers, Directeurgénéral

et secrétaire.

Vie dans la mesure autoriséepar saloi constitutive, sa constitution etses règlements.

The Order of Italo-Canadians5613 Arthur Chevrier St.Montréal North, Quebec H1G 1P7L. A. Bortolotti, Director.

Life and Sickness to the extentauthorized by its Act ofincorporation, Constitution andLaws.

The Order of Italo-Canadians5613, rue Arthur ChevrierMontréal-Nord (Québec) H1G 1P7L. A. Bortolotti, Administrateur.

Vie et maladie dans la mesureautoriséepar sa loi constitutive,sa constitution et ses règlements.

The Order of United Commercial Travelersof America

901 Centre St. North, Room 300Calgary, Alberta T2E 2P6Lindsay B. Maxwell, Chief Agent.

Life, Accident and sicknessinsurance to the extentauthorized by its Articles ofIncorporation, constitution andby-laws.

The Order of United Commercial Travelersof America

901, rue Centre Nord, Pièce 300Calgary (Alberta) T2E 2P6Lindsay B. Maxwell, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie dans lamesure autoriséepar sa loiconstitutive, sa constitution etses règlements.

See-The Independent Order of Foresters L’Ordre Indépendant des Forestiers789, chemin Don MillsDon Mills (Ontario) M3C 1T9William J. Valiquette, Vice-président

principal, Régie d’entreprise.

Vie, accidents et maladie dans lamesure autoriséepar son acte deconstitution en corporation, saconstitution et ses règlements.

Serb National Federationc/o John Milnes and Associates68 Scollard St., 2nd FloorToronto, Ontario M5R 1G2John R. Milnes, Chief Agent.

Life, Accident and Sickness to theextent authorized by its Articlesof incorporation, Constitutionand Laws, and is limited to theservicing of policies issuedpriorto July 15, 1998.

Serb National Federationa/s John Milnes and Associates68, rue Scollard, 2e étageToronto (Ontario) M5R 1G2John R. Milnes, Agentprincipal.

Vie, accidents et maladie dans lamesure autoriséepar sa loiconstitutive, sa constitution etses règlements, et limitée à lagestion despolices émises avantle 15juillet 1998.

See-ACTRA Fraternal Benefit Society La Société Fraternelle ACTRA1000, rue YongeToronto (Ontario) M4W 2K2Robert M. Underwood, Président et

chef de la direction.

Vie, accidents et maladie dans lamesure autoriséepar son acte deconstitution et ses règlements.

Page 75: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Name, Address and Official Representativeof the Company in Canada

Classes of Insurance for whichRegistered

Nom, adresse et mandataire officielde la société au Canada

Catégories d’assurance prévues àl’enregistrement

Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 43

See-Canadian Slovak Benefit Society Société de Secours Mutuels des Slovaquesdu Canada

55, rue BarronWelland (Ontario) L3C 2K4Joseph Mamros, Secrétaire.

Vie, accidents corporels et maladiedans la mesure autoriséepar saloi constitutive, sa constitution etses règlements.

Sons of Norwayc/o Deloitte & Touche2500 Scotia Centre700-2nd Street S.W.Calgary, Alberta T2P 0S7R. Ross Nelson, Chief Agent.

Life, Disability and Sickness to theextent authorized by its Articlesof incorporation, Constitutionand Laws.

Sons of Norwaya/s Deloitte & Touche2500 Scotia Centre700, 2e Rue Sud-ouestCalgary (Alberta) T2P 0S7R. Ross Nelson, Agentprincipal.

Vie, invalidité et maladie dans lamesure autoriséepar sa loiconstitutive, sa constitution etses règlements.

Sons of Scotland Benevolent Association90 Eglinton Ave. East, 7th FloorToronto, Ontario M4P 2Y3Mrs. Effie MacFie, Grand Secretary-

Treasurer.

Life and Sickness to the extentauthorized by its Act ofincorporation, Constitution andLaws.

Voir-Association Bénévole des Filsde l’Écosse

Supreme Council of the Royal Arcanum1030 Standard Life Bldg.120 King St. West, P.O. Box 990Hamilton, Ontario L8N 3R1J. B. Simpson, Chief Agent.

Life, Personal accident andSickness to the extent authorizedby its Certificate ofincorporation. Constitution andBy-Laws.

Supreme Council of the Royal Arcanum1030 Standard Life Building120, rue King Ouest, C.P. 990Hamilton (Ontario) L8N 3R1J. B. Simpson, Agentprincipal.

Vie, accidents corporels et maladiedans la mesure autoriséepar saloi constitutive, sa constitution etses règlements.

Ukrainian Fraternal Association(of America)

2800-14th Avenue, Suite 406Markham, Ontario L3R 0E4Bohdan M. Mocherniak, Chief Agent.

Life, to the extent authorized by itsArticles of Association,constitution and laws, and on thecondition that the words “ofAmerica” will be used inconspicuous relation to the name“Ukrainian FraternalAssociation” wherever it appearsin the Association’s contracts,application forms,advertisements or otherpublished material used inCanada.

Ukrainian Fraternal Association(of America)

2800, 14e Avenue, Bureau 406Markham (Ontario) L3R 0E4Bohdan M. Mocherniak, Agentprincipal.

Vie, dans la mesure autoriséeparsa loi constitutive, sa constitutionet ses règlements, et à laconditionque les mots « ofAmerica » figurent bienvisiblementprès du nom« Ukrainian FraternalAssociation »partout oùparaît lenom de l’Association dans lescontrats, les formules dedemande depolice, lapublicitéou les autres documentsimprimés utilisés au Canada.

Ukrainian Fraternal Society of Canada235 McGregor St.Winnipeg, Manitoba R2W 4W5M. J. Bugera, President.

Life, Personal accident andSickness to the extent authorizedby its Act of incorporation andby-laws and by The Canadianand British Insurance CompaniesAct, 1932.

Ukrainian Fraternal Society of Canada235, rue McGregorWinnipeg (Manitoba) R2W 4W5M. J. Bugera, Président.

Vie, accidents corporels et maladiedans la mesure autoriséepar saloi constitutive et ses règlementset par la loi sur les compagniesd’assurance canadiennes etbritanniques 1932.

Ukrainian Mutual Benefit Association ofSaint Nicholas of Canada

804 Selkirk Ave.Winnipeg, Manitoba R2W 2N6Gene Hazen, Manager.

Life, Disability and Sickness to theextent authorized by its Act ofincorporation, Constitution andLaws.

Ukrainian Mutual Benefit Association ofSaint Nicholas of Canada

804, av. SelkirkWinnipeg (Manitoba) R2W 2N6Gene Hazen, Directeur.

Vie, invalidité et maladie dans lamesure autoriséepar sa loiconstitutive, sa constitution etses règlements.

Ukrainian National Aid Associationof America

83 Christie StreetToronto, Ontario M6G 3B1Irene Mycak, Chief Agent.

Life insurance to the extentauthorized by its charter,Constitution and By-laws. Theforeign company is limited to theservicing of policies issuedpriorto May 25, 1999.

Ukrainian National Aid Associationof America

83, rue ChristieToronto (Ontario) M6G 3B1Irene Mycak, Agentprincipal.

Vie dans la mesure autoriséepar sacharte, sa constitution et sesrèglements. La société étrangèreest limitée à lagestion despolices émises avant le25 mai 1999.

Ukrainian National Association2800-14th Avenue, Suite 406Markham, Ontario L3R 0E4Bohdan M. Mochernial, Chief Agent.

Life, Personal accident andSickness to the extent authorizedby its Certificate ofincorporation, Constitution andBy-laws.

Ukrainian National Association2800, 14e Avenue, Bureau 406Markham (Ontario) L3R 0E4Bohdan M. Mochernial, Agentprincipal.

Vie, accidents corporels et maladiedans la mesure autoriséepar saloi constitutive, sa constitution etses règlements.

Woman’s Life Insurance Society1455 Lakeshore Road, P.O. Box 234Sarnia, Ontario N7T 7H9Joseph Haselmayer, Chief Agent.

Life insurance to the extentauthorized by its Articles ofIncorporation and Laws.

Woman’s Life Insurance Society1455, chemin Lakeshore, C.P. 234Sarnia (Ontario) N7T 7H9Joseph Haselmayer, Agentprincipal.

Vie dans la mesure autoriséepar saloi constitutive et ses règlements.

Workers Benevolent Association of Canada595 Pritchard Ave.Winnipeg, Manitoba R2W 2K4Zenovy H. Nykolyshyn, National

President.

Life, Accident and sickness to theextent authorized by its Act ofincorporation and By-Laws.

Workers Benevolent Association of Canada595, av. PritchardWinnipeg (Manitoba) R2W 2K4Zenovy H. Nykolyshyn, Président

national.

Vie, accidents et maladie dans lamesure autoriséepar sa loi et sesrèglements.

Page 76: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

44 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

NOTE (A)— REMARQUE (A)—

Abbey Life Insurance Company of Canada changed its name to ITT Hartford LifeInsurance Company of Canada effective July 1, 1994.

L’Abbaye Compagnie d’Assurance-Vie du Canada a modifié sa dénominationsociale à celle de ITT Hartford du Canada, Compagnie d’Assurance-Vie àcompter du 1er juillet 1994.

Abeille Réassurances amalgamated itsproperty and business with that of AXARéassurance effective April 18, 1996, the continuing or combined companybeing AXA Réassurance.

Abeille Réassurances a fusionné ses biens et son entreprise avec ceux de AXARéassurance depuis le 18 avril 1996, la compagnie issue de la fusion étant AXARéassurance.

Adriatic Insurance Company of Canada amalgamated itsproperty and businesswith that of Canadian Home Assurance Company effective January 1, 1991, thecontinuing or combined company being Canadian Home Assurance Company.

Advocat Général Compagnie d’Assurance du Canada: Un décret a été émis le5 juillet 1989 en vertu de laLoi sur les liquidations.

Advocate General Insurance Company’s certificate of registry was withdrawneffective July 15, 1989, and the company is being wound up under theprovisions of theWinding-up Act.

The Ætna Casualty and Surety Company: les obligations de la compagnie ayantété transférées à Aetna, compagnie d’assurance dommages et de cautionnementdu Canada, la compagnie a cessé d’être enregistrée à compter du 1er mars 1993.

The Ætna Casualty and Surety Company, having transferred its Canadianliabilities to Aetna Casualty & Surety Company of Canada, ceased to beregistered effective March 1, 1993.

Ætna Casualty du Canada, Compagnie d’Assurance a changé son nom en celui deLaurentienne Compagnie d’Assurance de Dommages du Canada à compter du1er novembre 1987.

Aetna Casualty & Surety Company of Canada changed its name to TravelersCasualty and Surety Company of Canada, effective July 1, 1997.

Aetna, compagnie d’assurance dommages et de cautionnement du Canada amodifié sa dénomination sociale à celle de Travelers, Compagnie d’assurancedommages et de cautionnement du Canada à compter du 1er juillet 1997.

Ætna Casualty Company of Canada changed its name to Laurentian CasualtyCompany of Canada effective November 1, 1987.

Aetna, Compagnie d’Assurance-Vie du Canada et La Maritime Compagnied’Assurance-vie ont été fusionnées etprorogées en une société fonctionnantsous la dénomination sociale La Maritime Compagnie d’Assurance-vie àcompter du 1er janvier 2000.

Ætna Insurance Company changed its name to CIGNA Property and CasualtyInsurance Company effective April 29, 1988.

Ætna Insurance Company a changé son nom en celui de CIGNA Property andCasualty Insurance Company à compter du 29 avril 1988.

Aetna Life Insurance Company of Canada and the Maritime Life Assurance Com-pany amalgamated and were continued as one company under the name of TheMaritime Life Assurance Company effective January 1, 2000.

A.G.F. Réassurances, ayant fusionné ses biens et affaires avec les biens et affairesde la Société Anonyme Française de Réassurances en vertu des lois de laFrance, la compagnie a cessé d’être enregistrée à compter du 31 décembre1991.

A.G.F. Réassurances, having amalgamated itsproperty and business with that ofSociété Anonyme Française de Réassurancespursuant to the laws of France,ceased to be registered effective December 31, 1991.

Aktieselskabet Nordisk Gjenforsikrings Selskab a changé son nom en celui deBaltica-Nordisk Reinsurance Company A/S à compter du 8 décembre 1986.

Aktieselskabet Nordisk Gjenforsikrings Selskab changed its name toBaltica-Nordisk Reinsurance Company A/S effective December 8, 1986.

Allendale Mututal Insurance Company a modifié sa dénomination sociale à cellede Factory Mutual Insurance Company à compter du 1er juillet 1999, la date dela fusion de Allendale Mututal Insurance Company, Arkwright MututalInsurance Company et Protection Mututal Insurance Company, en vertu des loisdesÉtats-Unis d’Amérique.

The Albion Insurance Company of Canada changed its name to MetropolitanGeneral Insurance Company effective February 16, 1988.

Allianz Insurance Company : les obligations de la compagnie ayant été transféréesà la Compagnie d’Assurance du Home Canadien, la compagnie a cessé d’êtreenregistrée à compter du 31 mars 1991.

Allendale Mutual Insurance Company changed its name to Factory MutualInsurance Company effective July 1, 1999, the date of the amalgamation ofAllendale Mutual Insurance Company, Arkwright Mutual Insurance Company,and Protection Mutual Insurance Company pursuant to the laws of the UnitedStates of America.

American Credit Indemnity Company of New York a changé son nom en celui deAmerican Credit Indemnity Company à compter du 17 avril 1985.

Allianz Insurance Company, having transferred its Canadian liabilities toCanadian Home Assurance Company, ceased to be registered effectiveMarch 31, 1991.

American Credit Indemnity Company a modifié sa dénomination sociale à celle deEULER American Credit Indemnity Company à compter du 4 octobre 1999.

Allianz Insurance Company of Canada amalgamated itsproperty and businesswith that of Cornhill Insurance Company of Canada effective November 1,1993, the continuing or combined company being Allianz Insurance Companyof Canada.

American Health and Life Insurance Company a cessé d’exercer des opérations auCanada. L’ordonnanceportantgarantie des risques au Canada a été annulée le21 décembre 1993.

American Credit Indemnity Company of New York changed its name to AmericanCredit Indemnity Company effective April 17, 1985.

The American Insurance Company a cessé d’exercer des opérations au Canada le31 décembre 1982; sonpassif canadien a étépris en charge par Fireman’s FundInsurance Company.

American Credit Indemnity Company changed its name to EULER AmericanCredit Indemnity Company effective October 4, 1999.

L’American Insurance Company a obtenu un nouveau certificat d’enregistrementlui permettant de souscrire despolices d’assurance au Canada à compter du8 janvier 1990.

American Health and Life Insurance Company ceased transacting business inCanada. The company’s order to insure in Canada risks was revoked effectiveDecember 21, 1993.

The American Insurance Company a cessé d’exercer des opérations au Canada.L’ordonnanceportantgarantie des risques au Canada a été annulée le 19 mars1997.

The American Insurance Company, having transferred its Canadian liabilities toFireman’s Fund Insurance Company, ceased to be registered effectiveDecember 31, 1982.

American Mutual Liability Insurance Company : le certificat d’enregistrement dela compagnie a été retiré le 30 mai 1989 et la compagnie sera liquidée en vertudes dispositions de laLoi sur les liquidations.

Page 77: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 45

NOTE (A)—Continued REMARQUE (A)—(suite)

The American Insurance Company was re-registered to transact the business ofinsurance in Canada effective January 8, 1990.

American Reserve Insurance Company le certificat d’enregistrement a été retiré le19 juin 1979 et la compagnie est maintenant en voie de liquidation en vertu desdispositions de laLoi sur les liquidations. Le 9 juillet 1984, avec l’approbationde la Cour suprême de l’Ontario, lepassif canadien de la compagnie a étéprisen charge par INA du Canada Compagnie d’assurance.

The American Insurance Company ceased transacting business in Canada. Thecompany’s order to insure in Canada risks was revoked effectiveMarch 19,1997.

AMEX Life Assurance Company a cessé d’exercer des opérations au Canada.L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a été annulée le10 octobre 1997.

American International Assurance Life Company Ltd. changed its name to AIGLife Insurance Company of Canada effective April 1, 1998.

Ancienne Mutuelle Réassurance a adopté une nouvelle raison sociale, Axa Ré, le26 mars 1990.

American Life Insurance Company ceased transacting business in Canada andtransferred its remaining Canadian policies to American InternationalAssurance Life Company Ltd. The company’s order to insure in Canada riskswas revoked effective December 31,1996.

L’Ancienne République, Compagnie d’Assurance : Conformément à la demandede la société, l’ordonnanceportant garantie des risques au CanadaparL’Ancienne République, Compagnie d’Assurance a été annulée le 22 décembre1995.

American Mutual Liability Insurance Company’s certificate of registry waswithdrawn effective May 30, 1989, and the company is being wound up undertheprovisions of theWinding-up Act.

L’Ancienne République, Compagnie d’Assurance-Vie a cessé d’exercer desopérations au Canada. L’ordonnanceportant garantie des risques au Canada aété annulée le 1er septembre 1993.

American Reserve Insurance Company’s certificate of registry was withdrawneffective June 19, 1979, and the company is being wound up under theprovisions of theWinding-up Act. The Supreme Court of Ontario approved thetransfer of the company’s remaining Canadian liabilities to INA InsuranceCompany of Canada effective July 9, 1984.

Argonaut Insurance Company : Conformément à la demande de la compagnie,l’ordonnanceportant garantie des risques au Canadapar Argonaut InsuranceCompany a été annulée le 23 novembre 1993.

AMEX Life Assurance Company ceased transacting business in Canada. Thecompany’s order to insure in Canada risks was revoked effective October 10,1997.

Arkwright-Boston Manufacturers Mutual Insurance Company a fusionné ses bienset opérations avec les biens et opérations de Philadelphia Manufacturers MutualInsurance Company le 7 septembre 1984; la compagnie fusionnée ou lacompagnie prenant suite des opérations est Arkwright-Boston ManufacturersMutual Insurance Company.

Ancienne Mutuelle Réassurance changed its name to Axa Ré effective March 26,1990.

Arkwright-Boston Manufacturers Mutual Insurance Company a changé son nomen celui de Arkwright Mutual Insurance Company à compter du 14 avril 1987.

Argonaut Insurance Company’s order to insure in Canada risks was revoked, atthe company’s request, effective November 23, 1993.

Arkwright Mututal Insurance Company a fusionné ses entreprise avec ceux deAllendale Mututal Insurance Company et ceux de Protection Mututal InsuranceCompany, et en vertu des lois desÉtats-Unis d’Amérique, son certificatd’enregistrement a été retiré le 1er juillet 1999. Les sociétés fusionnées ont étéprorogées en une société mutuelle fonctionnant sous la dénomination FactoryMutual Insurance Company, 1er juillet 1999.

Arkwright-Boston Manufacturers Mutual Insurance Company amalgamated itsproperty and business with Philadelphia Manufacturers Mutual InsuranceCompany effective September 7, 1984, the continuing or combined Companybeing Arkwright-Boston Manufacturers Mutual Insurance Company.

The Associated Canadian Travellers a cessé d’exercer des opérations au Canada.Lettrespatentes de dissolution avec une date d’effet du 16 novembre 1994 ontété émises.

Arkwright-Boston Manufacturers Mutual Insurance Company changed its name toArkwright Mutual Insurance Company effective April 14, 1987.

Association Canado-Américaine a modifié sa dénomination sociale à celle deACA ASSURANCE à compter du 19 décembre 1997.

Arkwright Mutual Insurance Company, having amalgamated itsproperty andbusiness with that ofAllendale Mutual Insurance Company and ProtectionMutual Insurance Company, pursuant to the laws of the United States ofAmerica, ceased to be registered effective July 1, 1999. The foreign companieswere continued as one mutual company under the name Factory MutualInsurance Company, effective July 1, 1999.

Assurances Continental limitée a modifié sa dénomination socialepour celle deCompagnie d’assurance Lombard, à compter du 8 décembre 1995.

The Associated Canadian Travellers ceased transacting business in Canada.Letterspatent of dissolution were issued effectiveNovember 16, 1994.

Assureurs-groupes Compagnie Canadienne d’Assurances a modifié sa dénomina-tion sociale à celle de ING Novex Compagnie d’assurance du Canada à compterdu 31janvier 2000.

Association Canado-Américaine changed its name to ACA ASSURANCEeffective December 19, 1997.

AXA Ré a modifié sa dénomination sociale à AXA Réassurance, le 21 décembre1990.

AXA Ré changed its name to AXA Réassurance effective December 21, 1990. AXA Réassurance a fusionné ses biens et son entreprise avec ceux de AbeilleRéassurances depuis le 18 avril 1996, la compagnie issue de la fusion étantAXA Réassurance.

AXA Réassurance amalgamated itsproperty and business with that of AbeilleRéassurances effective April 18, 1996, the continuing or combined companybeing AXA Réassurance.

La Baloîse, Compagnie d’Assurances a cessé d’exercer des opérations au Canada.Lordonnanceportantgarantie des risques au Canada a été annulée le 1er novem-bre 1999.

The Baloise Insurance Company Limited ceased transacting business in Canada.The company’s order to insure in Canada risks was revoked effective Novem-ber 1, 1999.

Baltica-Nordisk Reinsurance Company A/S a changé son nom en celui de NordiskReinsurance Company A/S à compter du 24 mai 1988.

Baltica-Nordisk Reinsurance Company A/S changed its name to NordiskReinsurance Company A/S effective May 24, 1988.

Beneficial Standard Life Insurance Company a cessé d’exercer des opérations auCanada. L’ordonnanceportantgarantie des risques au Canada a été annulée le10 octobre 1995.

Baltica-Skandinavia Reinsurance Company of Canada changed its name toPrimmum Insurance Company effective July 20, 1988.

Boréal Compagnie d’assurances de dommages a modifié sa dénomination socialepour celle de AXA Pacifique Compagnie d’Assurance, à compter du 23 octobre1995.

Page 78: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

46 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

NOTE (A)—Continued REMARQUE (A)—(suite)

Beneficial Standard Life Insurance Company ceased transacting business inCanada. The company’s order to insure in Canada risks was revoked effectiveOctober 10, 1995.

Le Bouclier Laurentien Compagnie d’Assurances a fusionné ses biens etopérations avec les biens et opérations de Laurentienne Casualty Compagnied’Assurance de Dommages du Canada et avec les biens et opérations de LaLaurentienne du Pacifique Compagnie d’Assurance le 27 février 1992; lacompagnie résultant de cette fusion est la Laurentienne Compagnied’Assurance de Dommages.

Boreal Property & Casualty Insurance Company changed its name to AXA PacificInsurance Company effective October 23, 1995.

Buffalo Insurance Company a changé son nom en Underwriters InsuranceCompany à compter du 9 novembre 1988.

Buffalo Insurance Company changed its name to Underwriters InsuranceCompany effective November 9, 1988.

Business Men’s Assurance Company of America a cessé d’exercer des opérationsau Canada. L’ordonnanceportantgarantie des risques au Canada a été annuléele 12 novembre 1999.

Business Men’s Assurance Company of America ceased transacting business inCanada. The company’s order to insure in Canada risks was revoked effectiveNovember 12, 1999.

CGU, Compagnie D’Assurance du Canada a fusionné ses biens et son entrepriseavec GAN General Insurance Company à compter du 31 décembre 1999. Lacompagnie issue de la fusion est CGU, Compagnie D’Assurance du Canada.

Cabot Insurance Company Limited, formerly a provincial insurer based inNewfoundland, was issued letterspatent continuing it as a company under theInsurance Companies Act, and concurrently amalgamated property andbusiness with Canadian General Insurance Company effective June 16, 1997,the continuing company being Canadian General Insurance Company.

Cabot Insurance Company Limited, société d’assurances constituée sous le régimedes lois de Terre-Neuve, a reçu des lettrespatentes laprorogeant sous le régimede laLoi sur les sociétés d’assuranceset a fusionné ses éléments d’actif et sesactivités avec celles de la Compagnie d’Assurance Canadienne Générale le16 juin 1997. La société issue de la fusion aurapour désignation sociale laCompagnie d’Assurance Canadienne Générale.

The Canada Accident and Fire Insurance Company amalgamated itsproperty andbusiness with that of the Stanstead and Sherbrooke Insurance Company andthat of Commercial Union Assurance Company of Canada effective January 1,1989; the continuing or combined company being Commercial UnionAssurance Company of Canada.

Canada Uni, Compagnie d’Assurance : le certificat d’enregistrement n’apas étérenouvelé le 1er mars 1986 et la compagnie est maintenant en voie deliquidation en vertu des dispositions de laLoi sur les liquidations.

The Canada Life Assurance Company amalgamated itsproperty and business withthat of Crown Life Insurance Company of Canada effective July 1, 1999, thecontinuing company being the Canada Life Assurance Company.

Canners Exchange Subscribers at Warner Inter-Insurance Bureau : les obligationsde la compagnie ayant été transférées à Employers Insurance of Wausau aMutual Company à compter du 31 décembre 1991, la compagnie a cessé d’êtreenregistrée à compter du 5 février 1993.

Canada Security Assurance Company changed its name to Scotia GeneralInsurance Company effective January 10 , 1996.

The Capitol Life Insurance Company a cessé d’exercer des opérations au Canada.L’ordonnanceportant garantie des risques au Canada a été annulée le 16juin1994.

The Canadian Commerce Insurance Company amalgamated itsproperty andbusiness with that of Trafalgar Insurance Company of Canada effectiveJanuary 1, 1993, the continuing or combined company being TrafalgarInsurance Company of Canada.

Central Mutual Insurance Company a cédé sonpassif canadien. Le certificatd’enregistrement de la compagnie n’apas été renouvelé au 31 mars 1986.

Canadian Direct Insurance Incorporated changed its name to HSBC CanadianDirect Insurance Incorporated effective October 1, 1999.

Château Compagnie d’Assurance a fusionné ses biens et son entreprise avec ceuxde La Citadelle, Compagnie d’Assurances Générales et Chateau InsuranceManagement Inc. à compter du 1er octobre 1994, la compagnie issue de lafusion étant La Citadelle, Compagnie d’Assurances Générales.

Canadian Foresters Life Insurance Society, having amalgamated itsproperty andbusiness with that of The Independent Order of Foresters, ceased to beregistered on February 26, 1992.

Christiania General Insurance Corporation a cessé d’exercer des opérations auCanada et tout sonpassif canadien a étépris en charge par FolksamericaReinsurance Company. L’ordonnanceportantgarantie des risques au Canada aété annulée le 6 mai 1997

Canadian General Insurance Company amalgamated itsproperty and businesswith that of USF&G Insurance Company of Canada effective June 30, 1990, thecontinuing or combined company being Canadian General Insurance Company.

CIGNA du Canada Compagnie d’assurance a modifié sa dénomination sociale àcelle d’ Assurance ACE INA à compter du 1er september 1999.

Canadian General Insurance Company amalgamated itsproperty and businesswith that of Toronto General Insurance Company as of January 1, 1994, thecontinuing company being Canadian General Insurance Company.

CIGNA Property and Casualty Insurance Company : les obligations de lacompagnie ayant été transférée à CIGNA Insurance Company of Canada, lacompagnie a cessé d’être enregistrée à compter du 24 décembre 1990.

Canadian General Insurance Company amalgamated itsproperty and businesswith that of Cabot Insurance Company Limited effective June 16, 1997, thecontinuing company being Canadian General Insurance Company.

La Citadelle, Compagnie d’Assurance-Vie a changé son nom en celui de laCompagnie d’assurance-vie Première du Canada à compter du 1er janvier 1994.

Canadian General Insurance Company amalgamated itsproperty and businesswith that of The General Accident Assurance Company of Canada effectiveJanuary 1, 1998, the continuing company being The General AccidentAssurance Company of Canada.

College Retirement Equities Fund a cessé d’exercer des opérations au Canada ettout son passif canadien a étépris en charge par Sun Life du Canada,compagnie d’assurance-vie. L’ordonnanceportant garantie des risques auCanada a été annulée le 6 avril 1998.

Canadian Group Underwriters Insurance Company changed its name to INGNovex Insurance Company of Canada effective January 31, 2000.

Cologne Life Reinsurance Company a modifié sa dénomination sociale à celle deGeneral & Cologne Life Re of America à compter du 25 février 2000.

Canadian Home Assurance Company amalgamated itsproperty and business withthat of The Canadian Provincial Insurance Company effective December 31,1992, the continuing or combined company being Allianz Insurance Companyof Canada.

Colonia Compagnie d’Assurance-Vie a modifié sa dénomination sociale à celle deConcordia compagnie d’assurance-vie à compter du 30 décembre 1998.

The Canadian Indemnity Company amalgamated itsproperty and business withthat of The Casualty Company of Canada and that of The Dominion of CanadaGeneral Insurance Company effective May 31, 1989, the continuing orcombined company being The Dominion of Canada General InsuranceCompany.

The Commercial Travellers’ Association of Canada a changé son nom en celui deL’Association Canadienne desprofessionnels de la vente à compter du 1er juin1991.

Page 79: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 47

NOTE (A)—Continued REMARQUE (A)—(suite)

Canadian Northern Shield Insurance Company changed its French name to LeBouclier du Nord Canadien, Compagnie d’Assurance effective August 11,1986.

Commercial Union Assurance Company plc a modifié sa dénomination sociale àcelle de CGU International Insuranceplc à compter du 1er octobre 1999.

The Canadian Provincial Insurance Company amalgamated itsproperty andbusiness with that of Canadian Home Assurance Company effective Decem-ber 31, 1992, the continuing or combined company being Allianz InsuranceCompany of Canada.

La Compagnie d’Assurances Adriatique du Canada a fusionné ses biens et sonentreprise avec ceux de la Compagnie d’Assurance du Home Canadien àcompter du 1er janvier 1991, la compagnie issue de la fusion étant laCompagnie d’Assurance du Home Canadien.

Canadian Reassurance Company changed its name to Swiss Re Life Canadaeffective June 5, 1995.

La Compagnie d’Assurance Albion du Canada a changé son nom en celui de LaMétropolitaine Générale, Compagnie d’Assurance à compter du 16 février1988.

Canadian Reinsurance Company changed its name to Swiss ReinsuranceCompany Canada effective June 5, 1995.

Compagnie d’Assurance Allianz du Canada a fusionné ses biens et son entrepriseavec ceux de la Compagnie d’Assurance Cornhill du Canada à compter du1er novembre 1993, la compagnie issue de la fusion étant la Compagnied’Assurance Allianz du Canada.

The Canadian Surety Company Amalgamated itsproperty and business with thatof Allianz Insurance Company of Canada effective April 1, 1999, thecontinuing company being Allianz Insurance Company of Canada.

La Compagnie D’Assurance American Life a cessé d’exercer des opérations auCanada et sonpassif canadien a étéprise en charge par La CompagnieD’Assurance-Vie American International Ltée. L’ordonnanceportant garantiedes risques au Canada a été annulée le 31 décembre 1996.

Canners Exchange Subscribers at Warner Inter-Insurance Bureau, havingtransferred its Canadian liabilities to Employers Insurance of Wausau a MutualCompany effective December 31, 1991, ceased to be registered February 5,1993.

La Compagnie d’Assurance Bouclier Canadien Nord a changé son nom en celuide Le Bouclier du Nord Canadien, Compagnie d’Assurance à compter du11 août 1986.

The Capitol Life Insurance Company ceased transacting business in Canada. Thecompany’s order to insure in Canada risks was revoked effectiveJune 16, 1994.

La Compagnie d’Assurance du Canada contre l’Incendie a changé sadénomination sociale à Compagnie d’assurancesgénérales Legacy à compter du1er janvier 1994.

Cardinal Insurance Company’s certificate of registry was withdrawn effectiveFebruary 19, 1982, and the company is being wound up under theprovisions oftheWinding-up Act.

La Compagnie D’Assurance Canada Security a modifié sa dénomination sociale àcelle de Scotia Générale, compagnie d’assurance à compter du 10janvier 1996.

The Casualty Company of Canada amalgamated itsproperty and business withthat of The Canadian Indemnity Company and that of The Dominion of CanadaGeneral Insurance Company effective May 31, 1989, the continuing orcombined company being The Dominion of Canada General InsuranceCompany.

Compagnie D’Assurances Canadian Surety a fusionné ses biens et son entrepriseavec Compagnie d’Assurance Allianz du Canada, à compter du 1er avril 1999.La compagnie issue de la fusion est Compagnie d’Assurance Allianz duCanada.

Central Mutual Insurance Company, having disposed of its liabilities in Canada,ceased to be registered effective March 31, 1986.

Compagnie d’Assurance Canadienne Commerce a fusionné ses biens et sonentreprise avec ceux de la Compagnie d’Assurance Trafalgar du Canada àcompter du 1er janvier 1993, la compagnie issue de la fusion étant laCompagnie d’Assurance Trafalgar du Canada.

Century Insurance Company of Canada: An order was issued December 1, 1989,whereby the property and business of Century Insurance Company of Canadawas to be wound up into the Dominion Insurance Corporation.

La Compagnie d’Assurances Canadienne Directe Incorporée a modifié sadénomination sociale à celle de La Compagnie d’Assurances HSBCCanadienne Directe Incorporée à compter du 1er octobre 1999.

CGU Insurance Company of Canada amalgamated itsproperty and business withthat of GAN General Insurance Company effective December 31, 1999, thecontinuing company being CGU Insurance Company of Canada

La Compagnie d’Assurance Canadienne Générale a fusionné avec la Compagnied’Assurance USF&G du Canada le 30juin 1990; les activités sepoursuiventsous la raison sociale Compagnie d’Assurance Canadienne Générale.

Chateau Insurance Company amalgamated itsproperty and business with that ofThe Citadel General Assurance Company and Chateau Insurance ManagementInc. effective October 1, 1994, the continuing company being The CitadelGeneral Assurance Company.

Compagnie d’Assurance Canadienne Générale a fusionné ses biens et sonentreprise avec ceux de la Compagnie d’Assurance Toronto Générale à compterdu 1er janvier 1994, la compagnie issue de la fusion étant la Compagnied’Assurance Canadienne Générale.

Chequers Insurance Company, having transferred its Canadian liabilities toMarkel Insurance Company of Canada, ceased to be registered effectiveMay 31, 1992.

Compagnie d’Assurance Canadienne Générale a fusionné ses biens et sonentreprise avec Cabot Insurance Company Limited, à compter du 16juin 1997.La compagnie issue de la fusion est Compagnie d’Assurance CanadienneGénérale.

Christiania General Insurance Corporation ceased transacting business in Canadaand transferred its remaining Canadianpolicies to Folksamerica ReinsuranceCompany. The company’s order to insure in Canada risks was revoked effectiveMay 6, 1997.

Compagnie d’Assurance Canadienne Générale a fusionné ses biens et sonentreprise avec General Accident, Compagnie d’Assurance du Canada, àcompter du 1er janvier 1998. La compagnie issue de la fusion est GeneralAccident, Compagnie d’Assurance du Canada.

CIBC General Group Insurance Company Limited amalgamated itsproperty andbusiness with that of CIBC General Insurance Company Limited effectiveNovember 1, 1994, the continuing or combined company being CIBC GeneralInsurance Company Limited.

La Compagnie d’Assurance Canadienne Provinciale a fusionné ses biens et sonentreprise avec ceux de la Compagnie d’Assurance du Home Canadien àcompter du 31 décembre 1992, la compagnie issue de la fusion étant laCompagnie d’Assurance Allianz du Canada.

CIGNA Insurance Company of Canada changed its name to ACE INA Insuranceeffective September 1, 1999.

La Compagnie d’Assurance Cardinal le certificat d’enregistrement a été retiré le19 février 1982 et la compagnie est maintenant en voie de liquidation en vertudes dispositions de laLoi sur les liquidations.

CIGNA Property and Casualty Insurance Company, having transferred itsliabilities to CIGNA Insurance Company of Canada, ceased to be registeredeffective December 24, 1990.

La Compagnie d’assurance Casualty du Canada a fusionné ses biens et sonentreprise avec ceux de L’Indemnité Compagnie Canadienne et ceux de laCompagnie d’assurancegénérale Dominion du Canada à compter du 31 mai1989, la compagnie issue de la fusion étant la Compagnie d’assurancegénéraleDominion du Canada.

Page 80: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

48 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

NOTE (A)—Continued REMARQUE (A)—(suite)

The Citadel Life Assurance Company changed its name to Canadian Premier LifeInsurance Company effective January 1, 1994.

Les biens et opérations de la Compagnie d’Assurance Century du Canada ont étécédés à La Dominion Corporation d’Assurance et un décret a été émis en vertude la Loi sur les liquidationspour la Compagnie d’Assurance Century duCanada au 1er décembre 1989.

College Retirement Equities Fund ceased transacting business in Canada andtransferred its Canadianpolicies to Sun Life Assurance Company of Canada.The company’s order to insure in Canada risks was revoked effective April 6,1998.

Les obligations de La Compagnie d’Assurance Chequers ayant été transférées à laMarkel Compagnie d’Assurance du Canada, la Compagnie a cessé d’êtreenregistrée à compter du 31 mai 1992.

Cologne Life Reinsurance Company changed its name to General & Cologne LifeRe of America effective February 25, 2000.

La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie a fusionné ses biens et sonentreprise avec Crown, compagnie d’assurance vie du Canada, à compter du1er juillet 1999. La compagnie issue de la fusion est La Compagnie d’Assurancedu Canada sur la Vie.

Colonia Life Insurance Company changed its name to Concordia Life InsuranceCompany effective December 30, 1998.

La Compagnie d’Assurance Consolidated Générale a modifié sa dénominationsocialepour celle de Compagnie d’assurance GE Capital Casualty, Canada, àcompter du 17juillet 1996.

The Commercial Travellers’ Association of Canada changed its name to CanadianProfessional Sales Association effective June 1, 1991.

La Compagnie d’Assurance Continental du Canada a cessé ses opérations sous laLoi sur les sociétés d’assurances, et a reçu un certificat deprorogation en vertude la Loi sur les sociétés par actions, en date du 6 septembre 1995, sous ladénomination sociale CICAN I Investment Holding Corp.

Commercial Union Assurance Company plc changed its name to CGUInternational Insuranceplc effective October 1, 1999.

La compagnie d’assurances Continental du Canada inc. a modifié sa dénominationsocialepour celle de Compagnie canadienne d’assurancesgénérales Lombard, àcompter du 8 décembre 1995.

Commercial Union Assurance Company of Canada amalgamated itsproperty andbusiness with that of CGU Insurance Company of Canada, effective October 1,1999. The continuing or combined company is CGU Insurance Company ofCanada.

La Compagnie d’Assurance contre les Accidents et l’Incendie du Canada afusionné ses biens et opérations avec les biens et opérations de la Compagnied’Assurance Stanstead & Sherbrooke et avec les biens et opérations de laCompagnie d’Assurance Union Commerciale du Canada le 1er janvier 1989; lacompagnie fusionnée ou la compagnie prenant suite des opérations est LaCompagnie d’Assurance Union Commerciale du Canada.

Compagnie Transcontinentale de Réassurance ceased transacting business inCanada. The company’s order to insure in Canada risks was revoked effectiveDecember 16, 1998.

Compagnie d’Assurance Cornhill du Canada a fusionné ses biens et son entrepriseavec ceux de la Compagnie d’Assurance Allianz du Canada à compter du1er novembre 1993, la compagnie issue de la fusion étant la Compagnied’Assurance Allianz du Canada.

Consolidated General Insurance Company Limited changed its name to GECapital Casualty Company, Canada effective July 17, 1996.

Compagnie d’Assurances Dominion a cessé ses opérations sous laLoi sur lessociétés d’assurances, et a reçu un certificat deprorogation en vertu de laLoisur les sociétés par actions, en date du 6 septembre 1995, sous la dénominationsociale CICAN II Investment Holding Corp.

Consolidated Life Assurance Company Limited ceased transacting business inCanada and transferred its Canadianpolicies to American Bankers LifeAssurance Company of Florida. The company’s order to insure in Canada riskswas revoked effective October 13,1995.

La Compagnie d’Assurance Eaton: un décret a été émis en vertu de laLoi sur lesliquidationspour la compagnie le 19 décembre 1989.

The Continental Insurance Company of Canada was discontinued under theInsurance Companies Actand was issued a certificate of continuance under theCanada Business Corporations Acton September 6, 1995 under the nameCICAN I Investment Holding Corp.

Compagnie d’assurance Fidélité du Canada a changé son nom en celui deCompagnie d’Assurance USF&G du Canada à compter du 1er juin 1985.

The Continental Insurance Company of Canada Inc. changed its name to LombardGeneral Insurance Company of Canada effective December 8, 1995.

La Compagnie d’assurance Forteresse d’Amérique : les obligations de lacompagnie ayant été transférées à Marine Indemnity Insurance Company ofAmerica, la compagnie a cessé d’être enregistrée à compter du 10 décembre1993.

Continental Insurance Limited changed its name to Lombard Insurance Companyeffective December 8, 1995.

Compagnie d’assurancegénérale de la Banque Royale du Canada a modifié sadénomination sociale à celle de Compagnie d’assurancegénérale RBC àcompter du 16 août 1999.

The Contingency Insurance Company Limited, having transferred its Canadianliabilities to Gan Canada Insurance Company, ceased to be registered effectiveJanuary 1, 1988.

Compagnie d’Assurancegénérale degroupes CIBC Limitée a fusionné ses bienset son entreprise avec ceux de la Compagnie d’assurancegénérale CIBCLimitée à compter du 1er novembre 1994, la compagnie issue de la fusion étantla Compagnie d’assurancegénérale CIBC Limitée.

Cornhill Insurance Company of Canada amalgamated itsproperty and businesswith that of Allianz Insurance Company of Canada effective November 1, 1993,the continuing or combined company being Allianz Insurance Company ofCanada.

La Compagnie d’Assurance Générale Kansa International S.A. : le 8 mars 1995, lacour a demandé la liquidation de Kansa General International InsuranceCompany Limited sous lesprovisions de laLoi sur les liquidations, nommantFerdinand Alfieri, 1,place Ville Marie, Bureau 2115, Montréal (Québec) H3B2C6, au titre de liquidateur provisoire de la société, de se charger desprocédures canadiennes de liquidation de la société.

The Credit Life Insurance Company changed its name to Union Fidelity LifeInsurance Company effective June 13, 1994.

La Compagnie d’Assurance Générale Kent a fusionné ses biens et son entrepriseavec La Citadelle, Compagnie d’Assurances Générales, à compter du30 novembre 1997. La compagnie issue de la fusion est La Citadelle,Compagnie d’Assurances Générales.

Crown Life Insurance Company of Canada and The Canada Life AssuranceCompany amalgamated and were continued as one mutual company under thename The Canada Life Assurance Company effective July 1, 1999 at 12:01 a.m.

La Compagnie d’Assurance Générale Strathcona a fusionné ses biens et opéra-tions avec les biens et opérations de Northumberland, Compagnie Généraled’Assurances le 31 août 1983; la compagnie fusionnée ou la compagnie prenantsuite des opérations est la Northumberland, Compagnie Générale d’Assurances.

Page 81: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 49

NOTE (A)—Continued REMARQUE (A)—(suite)

CUMIS Insurance Society, Inc. ceased transacting business in Canada. The Com-pany’s order to insure in Canada risks was revoked effective January 1, 2000.

La Compagnie d’Assurance Great Eastern a fusionné ses biens et opérations avecles biens et opérations de London-Canada Insurance Company le 31 décembre1987; la compagnie fusionnée ou la Compagnie prenant suite des opérations estCompagnie d’Assurance Hartford du Canada.

The Dominion Insurance Corporation was discontinued under theInsuranceCompanies Actand was issued a certificate of continuance under theCanadaBusiness Corporations Acton September 6, 1995 under the name CICAN IIInvestment Holding Corp.

Compagnie d’Assurance Guardian du Canada a modifié sa dénomination sociale àcelle de La Nordique compagnie d’assurance du Canada à compter du1er février, 1999.

Eaton Insurance Company: An order was issued December 19, 1989 winding upEaton Insurance Company.

La Compagnie d’Assurances Herald : Conformément à la demande de lacompagnie, l’ordonnance d’autorisation de fonctionnement de La Compagnied’Assurances Herald a été annulée le 17 décembre 1992.

Electrical Workers’ Benefit Association ceased to exist as at December 31, 1991. La Compagnie d’Assurance du Home Canadien a fusionné ses biens et sonentreprise avec ceux de La Compagnie d’Assurance Canadienne Provinciale àcompter du 31 décembre 1992, la compagnie issue de la fusion étant laCompagnie d’Assurance Allianz du Canada.

Emmco Insurance Company changed its name to Associates Insurance Companyeffective October 30, 1986.

Compagnie d’Assurance Longroup a modifié sa dénomination sociale à celle deCompagnie d’Assurance London Garantie à compter du 12juin 1995.

English & American Insurance Company Limited’s order to insure in Canadarisks was revoked effective October 6,1993, and the company is being woundup under theprovisions of theWinding-Up Act.

La Compagnie d’Assurance Missisquoi et Rouville a modifié sa raison sociale le 6novembre 1989 et se nomme maintenant La compagnie d’AssuranceMissisquoi.

Ennia Insurance Company (U.K.) Limited changed its name to Aegon InsuranceCompany (U.K.) Limited effective May 3, 1985.

Compagnie d’assurances New York Life du Canada et La Compagnie d’Assurancedu Canada sur la Vie ont été fusionnées etprorogées en une sociétéfonctionnant sous la dénomination sociale de La Compagnie d’Assurance duCanada sur la Vie le 1er avril 1994.

Federated Mutual Insurance Company’s order to insure in Canada risks wasrevoked, at the company’s request, December 31, 1992.

La Compagnie D’Assurance OTIP/RAEO Inc. a modifié sa dénomination sociale àcelle de La Compagnie d’Assurance Everest du Canada à compter du31 décembre 1996.

Fidelity Insurance Company of Canada changed its name to USF&G InsuranceCompany of Canada effective June 1, 1985.

La Compagnie d’Assurance Pohjola Ltée. (Vakuutusosakeyhtio Pohjola) a modifiésa dénomination sociale à celle de Pohjola Group Insurance Corporation àcompter du 31 août 1998.

The Fire Insurance Company of Canada changed its name to Legacy GeneralInsurance Company effective January 1, 1994.

La Compagnie d’Assurance Stanstead & Sherbrooke a fusionné ses biens etopérations avec les biens et opérations de la Compagnie d’Assurance contre lesAccidents et l’Incendie du Canada et avec les biens et opérations de laCompagnie d’Assurance Union Commerciale du Canada le 1er janvier 1989; lacompagnie fusionnée ou la compagnie prenant suite des opérations est LaCompagnie d’Assurance Union Commerciale du Canada.

Fireman’s Fund Insurance Company of Canada changed its name to WellingtonInsurance Company effective March 1, 1985.

La Compagnie d’Assurance Sun Alliance & London (Canada) a modifié sadénomination sociale à celle de TBD Compagnie d’Assurance Vie à compter du1er août 1995.

Fireman’s Fund Insurance Company ceased transacting business in Canada. Thecompany’s order to insure in Canada risks was revoked effective March 19,1997.

Compagnie d’Assurance Toronto Générale a fusionné ses biens et son entrepriseavec ceux de la Compagnie d’Assurance Canadienne Générale à compter du1er janvier 1994, la compagnie issue de la fusion étant la Compagnied’Assurance Canadienne Générale.

Folksamerica National Reinsurance Company ceased transacting business inCanada. The Company’s order to insure in Canada risks was revoked effectiveDecember 31, 1996.

Compagnie d’Assurance Traders Générale a fusionné ses biens et son entrepriseavec GAN Canada Compagnie d’Assurances à compter du 31 décembre 1999.La compagnie issue de la fusion est Compagnie d’Assurance Traders Générale.

Foremost Insurance Company Grand Rapids, Michigan’s order to insure inCanada risks was revoked, at the company’s request, effective August 31, 1995.

Compagnie d’Assurance Trafalgar du Canada a fusionné ses biens et sonentreprise avec ceux de la Compagnie d’Assurance Canadienne Commerce àcompter du 1er janvier 1993, la compagnie issue de la fusion étant laCompagnie d’Assurance Trafalgar du Canada.

Fortress Insurance Company of America, having transferred its Canadianliabilities to Marine Indemnity Insurance Company of America, ceased to beregistered effective December 10, 1993.

La Compagnie d’Assurance Union Commerciale du Canada a fusionné ses bienset son entreprise avec ceux de CGU, Compagnie D’Assurance du Canada àcompter du 1er octobre 1999, la compagnie issue de la fusion étant CGU,Compagnie D’Assurance du Canada.

The Franklin Life Insurance Company ceased transacting business in Canada andtransferred its remaining Canadianpolicies to Colonia Life Insurance Company.The company’s order to insure in Canada risks was revoked effective Decem-ber 31, 1996.

La Compagnie d’Assurance USF&G du Canada a fusionné avec la Compagnied’Assurance Canadienne Générale le 30juin 1990; les activités sepoursuiventsous la raison sociale Compagnie d’Assurance Canadienne Générale.

Frankona Rückversicherungs-Aktien-Gesellschaft changed its name to ERCFrankona Rückversicherungs-Aktien-Gesellschaft effective April 1, 1999.

Compagnie d’Assurances Victoria du Canada a fusionné ses biens et sonentreprise avec Compagnie d’Assurance Traders Générale, à compter du1er janvier 1996. La compagnie issue de la fusion est la Compagnied’Assurance Traders Générale.

GAN Canada Insurance Company amalgamated itsproperty and business withthat of Traders General Insurance Company effective December 31, 1999, thecontinuing company being Traders General Insurance Company.

La Compagnie d’Assurance-Vie American International Ltée a modifié sadénomination sociale à celle de La Compagnie d’Assurance-Vie AIG duCanada à compter du 1er avril 1998.

Page 82: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

50 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

NOTE (A)—Continued REMARQUE (A)—(suite)

GAN General Insurance Company, formerly a provincial insurer based in Ontario,was issued letterspatent continuing it as a company under theInsurance Com-panies Act,and concurrently amalgamated itsproperty and business with CGUInsurance Company of Canada effective December 31, 1999, the continuingcompany being CGU Insurance Company of Canada

Compagnie d’assurance-vie de la Banque Royale du Canada a modifié sadénomination sociale à celle de Compagnie d’assurance vie RBC à compter du4 octobre 1999.

Gan Incendie Accidents Compagnie Française, having transferred its Canadianliabilities to Gan Canada Insurance Company, ceased to be registered effectiveJanuary 1, 1988.

La Compagnie d’Assurance-Vie Glacier National a modifié sa dénominationsociale à celle de Scotia-Vie compagnie d’assurance à compter du 16 décembre1994.

The General Accident Assurance Company of Canada changed its name to CGUInsurance Company of Canada effective March 31,1999.

Compagnie d’Assurance-Vie Laurier et L’Impériale, compagnie d’assurance-vieont été fusionnées etprorogées en une société fonctionnant sous ladénomination sociale de L’Impériale, compagnie d’assurance-vie le 1er janvier1998.

General Accident Indemnity Company amalgamated itsproperty and businesswith that of Prudasco Assurance Company effective January 1, 1994, thecontinuing or combined company being General Accident Indemnity Company.

Compagnie d’assurances-vie La Métropolitaine du Canada et La Mutuelle duCanada, compagnie d’assurance sur la vie ont été fusionnées etprorogées enune société mutuelle fonctionnant sous la dénomination sociale de La Mutuelledu Canada, compagnie d’assurance sur la vie le 31 décembre 1998 à 23 h 59.

The General Accident Indemnity Company amalgamated itsproperty and businesswith that of The General Accident Assurance Company of Canada effectiveDecember 31, 1994, the continuing or combined company being The GeneralAccident Assurance Company of Canada.

La Compagnie d’Assurance-Vie Primerica a cessé d’exercer des opérations auCanada et tout sonpassif canadien a étépris en charge par La Compagnied’Assurance-Vie Primerica du Canada. L’ordonnanceportant garantie desrisques au Canada a été annulée le 19 août 1994.

General American Life Reinsurance Company of Canada changed its name toRGA Life Reinsurance Company of Canada effective September 18, 1995.

La Compagnie d’assurance-vie Transamerica Occidental a cessé d’exercer desopérations au Canada et tout sonpassif canadien a étépris en charge par laCompagnie d’Assurance-Vie Transamerica du Canada. L’ordonnanceportantgarantie des risques au Canada a été annulée le 12 avril 1995.

General Insurance Company of Royal Bank of Canada changed its name to RBCGeneral Insurance Company effective August 16, 1999.

La Compagnie d’Assurance Wellington a changé son nom en celui de Compagnied’Assurance Wellington à compter du 11 août 1986.

General Reassurance Corporation changed its name to Life ReassuranceCorporation of America effective August 3, 1989.

La Compagnie Canadienne de Réassurance a modifié sa dénomination sociale àcelle de Suisse de Réassurance Vie Canada à compter du 5juin 1995.

General Security Assurance Corporation of New York changed its name to SCORReinsurance Company effective March 31, 1994.

Compagnie de Garantie Seaboard du Canada a fusionné ses biens et son entrepriseavec La Compagnie d’Indemnité du Nord, Inc. à compter du 1er janvier 2000.La compagnie issue de la fusion est La Compagnie d’Indemnité du Nord, Inc.

General Security Insurance Company of Canada, following the passage of aSpecial Act by the Senate of Canada, was continued by Letters Patent ofContinuation as an insurance company under the laws of the Province ofQuebec effective December 1, 1994, under the name General SecurityInsurance Company of Canada Inc.

La Compagnie d’Indemnité du Nord, Inc. a fusionné ses biens et son entrepriseavec Compagnie de Garantie Seaboard du Canada à compter du 1er janvier2000. La compagnie issue de la fusion est La Compagnie d’Indemnité du Nord,Inc.

Glacier National Life Assurance Company changed its name to Scotia LifeInsurance Company effective December 16, 1994.

La Compagnie Mutuelle d’Assurance-vie Wawanesa a changé son nom en celui deLa Compagnie d’Assurance-vie Wawanesa à compter du 1er octobre 1993.

Globe Life Insurance Company ceased transacting business in Canada. Thecompany’s order to insure in Canada risks was revoked effective May 19, 1995.

La Compagnie de Réassurances Baltica-Skandinavia du Canada a changé son nomen celui de Primmum Compagnie d’Assurance à compter du 20juillet 1988.

The Great Eastern Insurance Company amalgamated itsproperty and businesswith that of London-Canada Insurance Company effective December 31, 1987,the continuing or combined company being Hartford Insurance Company ofCanada.

La Compagnie de Réassurance Kanata a changé son nom en celui de Trygg-HansaReinsurance Company of Canada le 28janvier 1991.

The Great Lakes Reinsurance Company changed its name to Temple InsuranceCompany, effective April 2, 1998.

La Compagnie de Réassurance Mercantile et Générale du Canada a fusionné sesbiens et son entreprise avec Compagnie Suisse de Réassurance Canada, àcompter du 1er juillet 1997. La compagnie issue de la fusion est CompagnieSuisse de Réassurance Canada.

Guardian Insurance Company of Canada changed its name to The NordicInsurance Company of Canada effective February 1, 1999.

La Compagnie de Réassurance Sphère du Canada a modifié sa dénominationsocialepour La Compagnie d’Assurance Chequers au 31 août 1989.

Guildhall Insurance Company’s order to insure in Canada risks was revoked, atthe company’s request, effective October 23, 1995.

La Compagnie de Réassurance TIG a modifié sa dénomination sociale à celle deOdyssey America Reinsurance Corporation à compter du 26janvier 2000.

Hartford Life Insurance Company of Canada and AIG Life Insurance Company ofCanada amalgamated and were continued as one company under the name AIGLife Insurance Company of Canada effective September 30, 1999.

La Compagnie de Réassurance Vie Mercantile et Générale du Canada et Suisse deRéassurances Vie et Santé Canada ont été fusionnées etprorogées en unesociété fonctionnant sous la dénomination sociale de Suisse de RéassurancesVie et Santé Canada le 1er juillet 1997.

The Hartford Steam Boiler Inspection and Insurance Company, having transferredit Canadian liabilities to The Boiler Inspection and Insurance Company ofCanada, ceased to be registered effective December 31, 1988.

Compagnie Transcontinentale de Réassurance a cessé d’exercer des opérations auCanada. L’ordonnanceportantgarantie des risques au Canada a été annulée le16 décembre 1998.

Helvetia Swiss Fire Insurance Company, Limited changed its name to HelvetiaSwiss Insurance Company, Limited effective June 19, 1989.

Consolidated Life Assurance Company Limited a cessé d’exercer des opérationsau Canada et tout sonpassif canadien a étépris en charge par AmericanBankers Compagnie d’Assurances-Vie de la Floride. L’ordonnanceportantgarantie des risques au Canada a été annulée le 13 octobre 1995.

Herald Insurance Company’s order to commence and carry on business of HeraldInsurance Company was revoked, at the request of the company, effectiveDecember 17, 1992.

The Contingency Insurance Company Limited a cessé d’exercer des opérations auCanada et tout sonpassif canadien a étépris en charge par GAN CanadaCompagnie d’Assurances le 1er janvier 1988.

Page 83: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 51

NOTE (A)—Continued REMARQUE (A)—(suite)

The Hungarian Reformed Federation of America ceased transacting business inCanada and transferred its Canadianpolicies to Toronto Mutual Life InsuranceCompany. The society’s order to insure in Canada risks was revoked effectiveMay 28, 1996.

Corporation de Garantie RoyNat le certificat d’enregistrement a été retiré le21 juin 1984, conformément à la demande de la compagnie.

Ideal Mutual Insurance Company’s certificate of registry was withdrawn effectiveFebruary 15, 1985, and the company is being wound up under theprovisions oftheWinding-Up Act.

The Credit Life Insurance Company a modifié sa dénomination sociale à celle deUnion Fidelity Life Insurance Company à compter du 13juin 1994.

The Imperial Life Assurance Company of Canada and its wholly-ownedsubsidiary, Laurentian Life Insurance Company of Canada, amalgamated andwere continued as one company under the name The Imperial Life AssuranceCompany of Canada effective January 1, 1993.

Crown, compagnie d’assurance vie du Canada et La Compagnie d’Assurance duCanada sur la Vie ont été fusionnées etprorogées en une société mutuellefonctionnant sous la dénomination sociale de La Compagnie d’Assurance duCanada sur la Vie le 1er juillet 1999 à 00 h 01.

INA Insurance Company of Canada changed its name to CIGNA InsuranceCompany of Canada effective September 1, 1985.

CUMIS Insurance Society, Inc. a cessé d’exercer des opérations au Canada.L’ordonnanceportantgarantie des risques au Canada a été annulée le 1er janvier2000.

Industrial Credit Insurance Company: At the request of the company, its certificateof registry was discontinued effective October 5, 1984.

Electrical Workers’ Benefit Association a cessé d’exister le 31 décembre 1991.

Insurance Company of North America, having transferred its Canadian liabilitiesto CIGNA Insurance Company of Canada, ceased to be registered effectiveFebruary 28, 1993.

Emmco Insurance Company a changé son nom en celui de Associates InsuranceCompany à compter du 30 octobre 1986.

The Insurance Corporation of Ireland Limited changed its name to ICAROMPublic Limited Company effective December 20, 1991.

La English & American Insurance Company Limited s’est vue annuler sonOrdonnanceportant garantie des risques au Canada le 6 octobre 1993 et lacompagnie est maintenant en voie de liquidation en vertu des dispositions de laLoi sur les liquidations.

ITT Hartford Life Insurance Company of Canada changed its name to HartfordLife Insurance Company of Canada effective October 1, 1997.

Ennia Insurance Company (U.K.) Limited a changé son nom en celui de AegonInsurance Company (U.K.) Limited à compter du 3 mai 1985.

John Deere Insurance Company of Canada changed its name to Echelon GeneralInsurance Company, effective March 5, 1998.

La Federated, Compagnie Mutuelle d’Assurances : Conformément à la demandede la compagnie, l’ordonnanceportant garantie des risques au Canadapar LaFederated, Compagnie Mutuelle d’Assurances a été annulée le 31 décembre1992.

John Hancock Mutual Life Insurance Company changed its name to John HancockLife Insurance Company effective February 1, 2000.

Fireman’s Fund du Canada Compagnie d’Assurance a changé son nom en celui deLa Compagnie d’Assurance Wellington à compter du 1er mars 1985.

Kanata Reinsurance Company changed its name to Trygg-Hansa ReinsuranceCompany of Canada effective January 28, 1991.

Fireman’s Fund Insurance Company a cessé d’exercer des opérations au Canada.L’ordonnanceportantgarantie des risques au Canada a été annulée le 19 mars1997.

Kansa General Insurance Company Limited changed its name to Kansa GeneralInternational Insurance Company Limited effective March 30, 1990.

Folksamerica National Reinsurance Company a cessé d’exercer des opérations auCanada. L’ordonnanceportantgarantie des risques au Canada a été annulée le31 décembre 1996.

Kansa General International Insurance Company Limited: On March 8, 1995 thecourt ordered the winding-up of Kansa General International InsuranceCompany Limited under theprovisions of theWinding Up Act, appointingFerdinand Alfieri, 1 Place Ville Marie, Suite 2115, Montréal, Quebec H3B 2C6,asprovisional liquidator of the company to proceed with the winding-up of thebusiness in Canada of the company.

Forestiers Canadiens, Société d’Assurance-Vie, ayant fusionné ses biens etaffaires avec les biens et affaires de L’Ordre Indépendant des Forestiers, lasociété a cessé d’être enregistrée le 26 février 1992.

Kemper Reinsurance Company changed its name to GE Reinsurance Corporationeffective May 19, 1999.

Foremost Insurance Company Grand Rapids, Michigan : Conformément à lademande de la société, l’ordonnanceportantgarantie des risques au CanadaparForemost Insurance Company Grand Rapids, Michigan a été annulée le 31 août1995.

Kent General Insurance Corporation amalgamated itsproperty and business withthat of The Citadel General Assurance Company effective November 30, 1997,the continuing company being The Citadel General Assurance Company.

The Franklin Life Insurance Company a cessé d’exercer des opérations au Canadaet son passif canadien a étépris en charge par Colonia Compagnied’Assurance-Vie. L’ordonnanceportant garantie des risques au Canada a étéannulée le 31 décembre 1996.

Laurentian Casualty Company of Canada changed its French name toLaurentienne Casualty Compagnie d’Assurance de Dommages du Canadaeffective February 21, 1990.

Frankona Rückversicherungs-Aktien-Gesellschaft a modifié sa dénominationsociale à celle de ERC Frankona Rückversicherungs-Aktien-Gesellschaft àcompter du 1er avril 1999.

Laurentian Casualty Company of Canada amalgamated itsproperty and businesswith that of Laurentian Pacific Insurance Company and that of The LaurentianShield Insurance Company effective February 27, 1992, the continuing orcombined company being Laurentian P&C Insurance Company.

GAN Canada Compagnie d’Assurances a fusionné ses biens et son entreprise avecCompagnie d’Assurance Traders Générale à compter du 31 décembre 1999. Lacompagnie issue de la fusion est Compagnie d’Assurance Traders Générale.

Laurentian P&C Insurance Company changed its name to Boreal Property &Casualty Insurance Company effective December 9, 1993.

GAN General Insurance Company, société d’assurances constituée sous le régimedes lois de l’Ontario, a reçu des lettrespatentes laprorogeant sous le régime dela Loi sur les sociétés d’assuranceset a fusionné ses éléments d’actif et ses ac-tivités avec celles de CGU, Compagnie D’Assurance du Canada le 31 décembre1999. La société issue de la fusion aurapour désignation sociale CGU, Compa-gnie D’Assurance du Canada.

Laurentian Pacific Insurance Company amalgamated itsproperty and businesswith that of Laurentian Casualty Company of Canada and that of TheLaurentian Shield Insurance Company effective February 27, 1992, thecontinuing or combined company being Laurentian P&C Insurance Company.

Gan Incendie Accidents Compagnie Française a cessé d’exercer des opérations auCanada et tout sonpassif canadien a étépris en charge par Gan CanadaCompagnie d’Assurances le 1er janvier 1988.

Page 84: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

52 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

NOTE (A)—Continued REMARQUE (A)—(suite)

The Laurentian Shield Insurance Company amalgamated itsproperty and businesswith that of Laurentian Casualty Company of Canada and that of LaurentianPacific Insurance Company effective February 27, 1992, the continuing orcombined company being Laurentian P&C Insurance Company.

General Accident, Compagnie d’Assurance du Canada a modifié sa dénominationsociale à celle de CGU, Compagnie D’Assurance du Canada à compter du31 mars 1999.

Laurier Life Insurance Company and The Imperial Life Assurance Company ofCanada amalgamated and were continued as one company under the name TheImperial Life Assurance Company of Canada effective January 1, 1998.

Général Accident Indemnité Compagnie d’Assurance a fusionné ses biens et sonentreprise avec ceux de La Prudasco, Compagnie d’Assurance à compter du1er janvier 1994, la compagnie issue de la fusion étant la Général AccidentIndemnité Compagnie d’Assurance.

Life Insurance Company of Royal Bank of Canada changed its name to RBC LifeInsurance Company effective October 4, 1999.

Général Accident Indemnité Compagnie d’Assurance a fusionné ses biens et sonentreprise avec ceux de la General Accident, Compagnie d’Assurance duCanada à compter du 31 décembre 1994, la compagnie issue de la fusion étantGeneral Accident, Compagnie d’Assurance du Canada.

The London Assurance ceased transacting business in Canada. The company’sorder to insure in Canada risks was revoked effective December 1,1997.

General American, Compagnie de réassurance-vie du Canada a modifié sadénomination sociale à celle de RGA Compagnie de réassurance-vie du Canadaà compter du 18 septembre 1995.

London-Canada Insurance Company amalgamated itsproperty and business withthat of The Great Eastern Insurance Company effective December 31, 1987, thecontinuing or combined company being Hartford Insurance Company ofCanada.

General Reassurance Corporation a changé son nom en celui de Life ReassuranceCorporation of America à compter du 3 août 1989.

Longroup Insurance Company changed its name to London Guarantee InsuranceCompany effective June 12, 1995.

General Security Assurance Corporation of New York a changé sa raison sociale àSCOR, Compagnie de Réassurance à compter du 31 mars 1994.

Marine Indemnity Insurance Company of America ceased transacting business inCanada. The company’s order to insure in Canada risks was revoked effectiveDecember 31, 1997.

Globe Life Insurance Company a cessé d’exercer des opérations au Canada.L’ordonnanceportant garantie des risques au Canada a été annulée le 19 mai1995.

The Maritime Life Assurance Company, a company incorporated underTheMaritime Life Assurance Company Act, Statutes of Nova Scotia, 1986, c.96wascontinued as a company under theInsurance Companies Acteffective Decem-ber 24, 1999.

Les Grands Lacs, Compagnie de Réassurance a modifié sa dénomination sociale àcelle de La compagnie d’assurance Temple à compter du 2 avril 1998.

Massachusetts General Life Insurance Company ceased transacting business inCanada. The company’s order to insure in Canada risks was revoked effectiveOctober 18, 1993.

Guildhall Insurance Company : Conformément à la demande de la société,l’ordonnanceportant garantie des risques au Canadapar Guildhall InsuranceCompany a été annulée le 23 octobre 1995.

Massachusetts Indemnity and Life Insurance Company changed its name toPrimerica Life Insurance Company effective July 1, 1992.

Hartford du Canada, Compagnie d’Assurance-Vie et La Compagnie d’Assurance-Vie AIG du Canada ont été fusionnées etprorogées en une société fonctionnantsous la dénomination sociale de La Compagnie d’Assurance-Vie AIG du Cana-da le 30 septembre 1999.

The Mercantile and General Life Reassurance Company of Canada and Swiss ReLife & Health Canada amalgamated and were continued as one company underthe name Swiss Re Life & Health Canada effective July 1, 1997.

The Hartford Steam Boiler and Inspection Company a cessé d’exercer desopérations au Canada et tout sonpassif canadien a étépris en charge par LaCompagnie d’Inspection et d’Assurance Chaudières et Machinerie le31 décembre 1988.

The Mercantile and General Reinsurance Company of Canada amalgamated itsproperty and business with that of Swiss Reinsurance Company Canadaeffective July 1, 1997, the continuing company being Swiss ReinsuranceCompany Canada.

Helvetia Swiss Fire Insurance Company, Limited a changé son nompour HelvetiaCompagnie Suisse d’Assurances à compter du 19juin 1989.

The Mercantile and General Reinsurance Company plc: At the company’s request,its order to insure in Canada risk was revoked effective December 31,1992.

The Hungarian Reformed Federation of America a cessé d’exercer des opérationsau Canada et tout sonpassif canadien a étépris en charge par Toronto MutualLife Insurance Company. L’ordonnanceportantgarantie des risques au Canadaa été annulée le 28 mai 1996.

Metropolitan General Insurance Company, following the passage of a Special Actby the Senate of Canada, was continued by Letters Patent of Continuation as aninsurance company under the laws of the Province of Quebec effectiveDecember 19, 1991.

Ideal Mutual Insurance Company le certificat d’enregistrement a été retiré le15 février et la compagnie est maintenant en voie de liquidation en vertu desdispositions de laLoi sur les liquidations.

Metropolitan Insurance Company amalgamated itsproperty and business with thatof Metropolitan Life Insurance Company of Canada effective December 30,1992, the continuing or continued company being Metropolitan Life InsuranceCompany of Canada.

L’Im périale, compagnie d’assurance-vie et sa filiale enpropriété exclusive,Laurentienne-Vie du Canada, Compagnie d’Assurance, ont été fusionnées etprorogées en une société fonctionnant sous la dénomination sociale deL’Im périale, compagnie d’assurance-vie le 1er janvier 1993.

Metropolitan Life Insurance Company of Canada and The Mutual Life AssuranceCompany of Canada amalgamated and were continued as one mutual companyunder the name The Mutual Life Assurance Company of Canada effectiveDecember 31, 1998 at 11:59p.m.

INA du Canada Compagnie d’Assurance a changé son nom en celui de CIGNA duCanada Compagnie d’assurance à compter du 1er septembre 1985.

Midland Insurance Company’s certificate of registry was withdrawn effectiveApril 10, 1986, and the company is being wound up under theprovisions of theWinding Up Act.

L’Indemnité Compagnie Canadienne a fusionné ses biens et son entreprise avecceux de la Compagnie d’assurance Casualty du Canada et ceux de laCompagnie d’assurancegénérale Dominion du Canada à compter du 31 mai1989, la compagnie issue de la fusion étant la Compagnie d’assurancegénéraleDominion du Canada.

The Minnesota Mutual Life Insurance Company changed its name to MinnesotaLife Insurance Company effective April 30, 1999.

Les obligations de Insurance Company of North America ayant été transférées àCIGNA du Canada Compagnie d’assurance, la compagnie a cessé d’êtreenregistrée à compter du 28 février 1993.

Page 85: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 53

NOTE (A)—Continued REMARQUE (A)—(suite)

Mission American Insurance Company, having disposed of its liabilities inCanada, ceased to be registered effective March 31, 1991.

The Insurance Corporation of Ireland Limited a changé son nom en celui deICAROM Public Limited Company à compter du 20 décembre 1991.

The Missisquoi and Rouville Insurance Company changed its name to theMissisquoi Insurance Company effective November 6, 1989.

ITT Hartford du Canada, Compagnie d’Assurance-Vie a modifié sa dénominationsociale à celle de Hartford du Canada, Compagnie d’Assurance-Vie à compterdu 1er octobre 1997.

MONY Reinsurance Corporation changed its name to Folksamerica NationalReinsurance Company effective September 24, 1992.

John Deere, Compagnie D’Assurance du Canada a modifié sa dénominationsociale à celle deÉchelon, Compagnie D’Assurances Générale à compter du5 mars 1998.

The Mutual Life Assurance Company of Canada changed its name to Clarica LifeInsurance Company, effective July 21, 1999 at 12:01 a.m., aspart of theconversion of the company into a company with common shares.

John Hancock Mutual Life Insurance Company a modifié sa dénomination socialeà celle de John Hancock Life Insurance Company à compter du 1er février 2000.

Mutuelle Générale Française Accidents changed its name to Les Mutuelles duMans I.A.R.D. effective March 4, 1988.

La Kansa General Insurance Company Limited a changé sa raison sociale le30 mars 1990.Elle s’appelle maintenant la Compagnie d’Assurance GénéraleKansa International S.A.

Les Mutuelles du Mans I.A.R.D. changed its name to La Mutuelle Du MansAssurances I.A.R.D. effective March 5, 1991.

Kemper Reinsurance Company a modifié sa dénomination sociale à celle de GEReinsurance Corporation à compter du 19 mai 1999.

National Employers’ Mutual General Insurance Association, Limited’s certificateof registry was withdrawn effective December 11, 1990, and the company isbeing wound up under theprovisions of theWinding Up Act.

La Laurentienne, Compagnie d’Assurance de Dommages du Canada a modifié saraison sociale le 21 février 1990; elle s’appelle maintenant LaurentienneCasualty, Compagnie d’Assurance de Dommages du Canada.

National Fraternal Society of the Deaf ceased transacting business in Canada. Thesociety’s order to insure in Canada risks was revoked effective April 30, 1996.Policies were either surrendered or transferred to Croatian Fraternal Union ofAmerica.

Laurentienne Casualty Compagnie d’Assurance de Dommages du Canada afusionné ses biens et opérations avec les biens et opérations de La Laurentiennedu Pacifique Compagnie d’Assurance et avec les biens et opérations de LeBouclier Laurentien Compagnie d’Assurances le 27 février 1992; la compagnierésultant de cette fusion est la Laurentienne Compagnie d’Assurance deDommages.

The National Reinsurance Company of Canada was discontinued under theInsurance Companies Actand was issued a certificate of continuance under theCanada Business Corporations Acteffective December 22, 1994 under thename 3100715 Canada Inc.

Laurentienne Compagnie d’Assurance de Dommages a changé sa dénominationsociale à Boréal Compagnie d’assurances de dommages à compter du9 décembre 1993.

New England Insurance Company (formerly New England ReinsuranceCorporation), having transferred its Canadianpolicies to New EnglandReinsurance Corporation, formerly Tower Insurance Company of Connecticut,as of January 1, 1984.

La Laurentienne du Pacifique Compagnie d’Assurance a fusionné ses biens etopérations avec les biens et opérations de Laurentienne Casualty Compagnied’Assurance de Dommages du Canada et avec les biens et opérations de LeBouclier Laurentien Compagnie d’Assurances le 27 février 1992; la compagnierésultant de cette fusion est la Laurentienne Compagnie d’Assurance deDommages.

New England Mutual Life Insurance Company ceased transacting business inCanada. The company’s order to insure in Canada risks was revoked effectiveNovember 1, 1995.

The London Assurance a cessé d’exercer des opérations au Canada. L’ordonnanceportantgarantie des risques au Canada a été annulée le 31 décembre 1997.

New England Reinsurance Corporation changed its name to New EnglandInsurance Company effective February 29, 1984.

London-Canada Insurance Company a fusionné ses biens et opérations avec lesbiens et opérations de La Compagnie d’Assurance Great Eastern le31 décembre 1987; la compagnie fusionnée ou la compagnie prenant suite desopérations est la Compagnie d’Assurance Hartford du Canada.

New England Reinsurance Corporation, having transferred its Canadian liabilitiesto The Hartford Fire Insurance Company, ceased to be registered effectiveDecember 31, 1988.

Marine Indemnity Insurance Company of America a cessé d’exercer desopérations au Canada. L’ordonnanceportant garantie des risques au Canada aété annulée le 31 décembre 1997.

New Rotterdam Insurance Company changed its name to UAP-NewRotterdamInsurance Company N.V. effective October 28, 1997.

La Maritime Compagnie d’Assurance-vie, une société constituée aux termes deThe Maritime Life Assurance Company Act, Statutes of Nova Scotia, 1986,c.96, a étéprorogée comme une société sous le régime de laLoi sur les sociétésd’assurancesà compter du 24 décembre 1999.

New York Life Insurance Company of Canada and The Canada Life AssuranceCompany amalgamated and were continued as one company under the nameThe Canada Life Assurance Company effective April 1, 1994.

Massachusetts General Life Insurance Company a cessé d’exercer des opérationsau Canada. L’ordonnanceportantgarantie des risques au Canada a été annuléele 18 octobre 1993.

The New Zealand Insurance Company Limited, having transferred its Canadianliabilities to Christiania General Insurance Corporation, ceased to be registeredeffective March 31, 1991.

Massachusetts Indemnity and Life Insurance Company a changé son nom en celuide La Compagnie d’Assurance-Vie Primerica à compter du 1er juillet 1992.

The Non-Marine Underwriters, Members of Lloyd’s, London, England changed itsname to Lloyd’s Underwriters effective October 1, 1999.

The Mercantile and General Reinsurance Company plc a cessé d’exercer desopérations au Canada et a cédé sonpassif canadien. L’ordonnanceportantgarantie des risques au Canada a été annulée le 31 décembre 1992.

Norman Insurance Company Limited: At the company’s request, the order toinsure in Canada risks of Norman Insurance Company Limited was revokedeffective December 31, 1992.

Metropolitan Insurance Company a fusionné ses biens et opérations avec les bienset opérations de la Compagnie d’assurances-vie La Métropolitaine du Canada le30 décembre 1992; la compagnie fusionné ou la compagnie prenant suite desopérations est la Compagnie d’assurances-vie La Métropolitaine du Canada.

North American Benefit Association changed its name to Woman’s Life InsuranceSociety effective January 1, 1996.

La Métropolitaine Générale, Compagnie d’Assurance, après l’adoption d’une Loid’intérêt privé par le Sénat du Canada, a étéprorogée par lettrespatentes decontinuation comme compagnie d’assurance de laprovince de Québec, en datedu 19 décembre 1991.

Page 86: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

54 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

NOTE (A)—Continued REMARQUE (A)—(suite)

North American Company for Property and Casualty changed its name to NACReinsurance Corporation effective July 29, 1989.

Midland Insurance Company le certificat d’enregistrement a été retiré le 10 avril1986 et la compagnie est maintenant en voie de liquidation en vertu desdispositions de laLoi sur les liquidations.

The North American General Insurance Company’s certificate of registry waswithdrawn effective December 15, 1966, and the company is being wound upunder theprovisions of theWinding-up Act.

The Minnesota Mutual Life Insurance Company a modifié sa dénominationsociale à celle de Compagnie d’Assurance-vie Minnesota à compter du 30 avril1999.

North American Life and Casualty Company changed its name to Allianz LifeInsurance Company of North America as at March 31, 1993.

Mission American Insurance Company ayant aliéné sonpassif au Canada, elle acessé d’être enregistrée à compter du 31 mars 1991.

North American Life Assurance Company and The Manufacturers Life InsuranceCompany amalgamated and were continued as one mutual company under thename The Manufacturers Life Insurance Company effective January 1, 1996.

MONY Reinsurance Corporation a changé sa dénomination socialepourFolksamerica National Reinsurance Company à compter du 24 septembre 1992.

North American Reassurance Company changed its name to Swiss Re LifeCompany America effective December 19, 1996.

La Mutuelle du Canada, compagnie d’assurance sur la vie a modifié sadénomination sociale à celle de Clarica, compagnie d’assurance sur la vie, àcompter du 21juillet 1999 à 00 h 01, suite à sa transformation en sociétéparactions.

North American Reinsurance Corporation, having transferred its Canadian liabili-ties to Canadian Reinsurance Company, ceased to be registered effective De-cember 27, 1991.

Mutuelle Générale Française Accidents a changé son nom en Les Mutuelles duMans I.A.R.D. à compter du 4 mars 1988.

Northern Indemnity, Inc. amalgamated itsproperty and business with that ofSeaboard Surety Company of Canada effective January 1, 2000, the continuingcompany being Northern Indemnity, Inc.

Les Mutuelles Du Mans I.A.R.D. a changé son nom en celui de La Mutuelle DuMans Assurances I.A.R.D. le 5 mars 1991.

Northumberland General Insurance Company amalgamated its property andbusiness with that of The Strathcona General Insurance Company effectiveAugust 31, 1983, the continuing or combined company being NorthumberlandGeneral Insurance Company.

La National Employers’ Mutual General Insurance Association, Limited s’est vueretirer son certificat d’enregistrement le 11 décembre 1990 et la compagnie estmaintenant en voie de liquidation en vertu des dispositions de laLoi sur lesliquidations.

Northumberland General Insurance Company’s certificate of registry was notrenewed effective July 5, 1985, and the company is being wound up under theprovisions of theWinding-up Act.

National Fraternal Society of the Deaf a cessé d’exercer des opérations au Canada.L’ordonnanceportantgarantie des risques au Canada a été annulée le 30 avril1996. Lespolices ont soit été rachetées ouprises en charge par CroatianFraternal Union of America.

Northwestern National Life Insurance Company changed its name to ReliaStarLife Insurance Company effective August 1, 1996.

La Nationale, Compagnie de Réassurance du Canada a cessé ses opérations sousla Loi sur les sociétés d’assurances, et a reçu un certificat deprorogation envertu de laLoi sur les sociétés par actions, en date du 22 décembre 1994, sousla dénomination sociale 310071-5 CANADA INC.

Norwich Union Fire Insurance Society Limited ceased transacting business inCanada. The company’s order to insure in Canada risks was revoked effectiveJune 24, 1998.

New England Insurance Company, auparavant New England ReinsuranceCorporation, a cessé d’exercer des affaires au Canada. Sonpassif canadien a étépris en charge par New England Reinsurance Corporation, auparavant TowerInsurance Company of Connecticut, le 1er janvier 1984.

The Norwich Union Life Insurance Society ceased transacting business in Canadaand transferred its Canadianpolicies to Norwich Union Life InsuranceCompany (Canada). The company’s order to insure in Canada risks wasrevoked effective September 30, 1997.

New England Mutual Life Insurance Company a cessé d’exercer des opérations auCanada. L’ordonnanceportantgarantie des risques au Canada a été annulée le1er novembre 1995.

Norwich Winterthur Reinsurance Corporation Limited changed its name to NWReinsurance Corporation Limited effective November 5, 1992.

New England Reinsurance Corporation a changé son nom en celui de NewEngland Insurance Company à compter du 29 février 1984.

Nova Scotia General Insurance Company changed its name to Toronto DominionGeneral Insurance Company effective February 7, 1995.

New England Reinsurance Corporation a retiré son certificat d’enregistrement le31 décembre 1988 et tout sonpassif canadien a étépris en charge par TheHartford Fire Insurance Company.

NRG London Reinsurance Company Limited: At the company’s request, its orderto insure in Canada risks was revoked effective December 31,1992.

New Rotterdam Insurance Company a modifié sa dénomination sociale à celle deUAP-NewRotterdam Insurance Company N.V. à compter du 28 octobre 1997.

NRG Victory Reinsurance Limited ceased transacting life insurance and accidentand sickness insurance in Canada effective April 1, 1992.

Les obligations de The New Zealand Insurance Company Limited ayant ététransférées à la Christiania General Insurance Corporation, la compagnie acessé d’être enregistrée à compter du 31 mars 1991.

Old Republic Insurance Company: At the company’s request, the order to insurein Canada risks of Old Republic Insurance Company was revoked effectiveDecember 22, 1995.

The Non-Marine Underwriters, Members of Lloyd’s, London, England a modifiésa dénomination sociale à celle de les Souscripteurs du Lloyd’s à compter du1er octobre 1999.

Old Republic Life Insurance Company ceased transacting business in Canada. Thecompany’s order to insure in Canada risks was revoked effective September 1,1993.

La Nord-américaine, compagnie d’assurance-vie et La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers ont été fusionnées etprorogées en une société mutuellefonctionnant sous la dénomination sociale de La Compagnie d’Assurance-VieManufacturers le 1er janvier 1996.

The Omaha Indemnity Company: At the company’s request, the order to insure inCanada risks of The Omaha Indemnity Company was revoked effectiveJanuary 25, 1994.

Norman Insurance Company Limited : Conformément à la demande de lacompagnie, l’ordonnanceportant garantie des risques au Canadapar NormanInsurance Company Limited a été annulée le 31 décembre 1992.

The Orion Insurance Company Limited changed its name to The Orion InsuranceCompany PLC effective September 11, 1990.

North American Benefit Association a modifié sa dénomination sociale à celle deWoman’s Life Insurance Society à compter du 1er janvier 1996.

Page 87: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 55

NOTE (A)—Continued REMARQUE (A)—(suite)

The Orion Insurance Company PLC: On October 27, 1994 the Superintendent ofFinancial Institutions took control of The Orion Insurance Company PLC andon February 10, 1995 the court ordered the winding-up of The Orion InsuranceCompany PLC under theprovisions of theWinding Up Act, appointing theSuperintendent as liquidator of the company. Deloitte & Touche Inc., acting asagent for the liquidator, isproceeding with the winding up of the company’saffairs.

La North American Company for Property and Casualty a modifié sadénomination socialepour NAC Reinsurance Corporation au 29juillet 1989.

OTIP/RAEO Insurance Company Inc. changed its name to Everest InsuranceCompany of Canada, effective December 31, 1996.

The North American General Insurance Company : le certificat d’enregistrement aété retiré le 15 décembre 1966 et la compagnie est maintenant en voie deliquidation en vertu des dispositions de laLoi sur les liquidations.

Pacific Employers Insurance Company, having transferred its Canadian liabilitiesto CIGNA Insurance Company of Canada, ceased to be registered effectiveOctober 27, 1993.

North American Life and Casualty Company a changé son nom en celui de AllianzLife Insurance Company of North America à compter du 31 mars 1993.

Pafco International Insurance Company changed its name to Granite InsuranceCompany effective June 25, 1991.

North American Reassurance Company a modifié sa dénomination sociale à cellede Swiss Re Life Company America à compter du 19 décembre 1996.

Paragon Insurance Company of Canada changed its name to Laurentian PacificInsurance Company effective May 3, 1984.

Les obligations de North American Reinsurance Corporation ayant été transféréesà la Société Canadienne de Réassurance, la compagnie a cessé d’êtreenregistrée à compter du 27 décembre 1991.

The Patriot Life Insurance Company was the name assumed by Balboa LifeInsurance Company to transact business in Canada. Effective January 9, 1992,the company has been transacting business under its own name.

Northumberland, Compagnie Générale d’Assurances a fusionné ses biens etopérations avec les biens et opérations de la Compagnie d’AssurancesGénérales Strathcona le 31 août 1983; la compagnie fusionnée ou la compagnieprenant suite des opérations est la Northumberland, Compagnie Généraled’Assurances.

The Penn Mutual Life Insurance Company ceased transacting business in Canada.The company’s order to insure in Canada risks was revoked effective July 9,1999.

Northumberland, Compagnie Générale d’Assurances : le certificat d’enregistre-ment n’apas été renouvelé le 5juillet 1985 et la compagnie est maintenant envoie de liquidation en vertu des dispositions de laLoi sur les liquidations.

Philadelphia Manufacturers Mutual Insurance Company amalgamated itspropertyand business with Arkwright-Boston Manufacturers Mutual InsuranceCompany effective September 7, 1984, the continuing or combined companybeing Arkwright-Boston Manufacturers Mutual Insurance Company.

Northwestern National Life Insurance Company a modifié sa dénomination socialeà celle de Compagnie D’Assurance-Vie ReliaStar à compter du 1er août 1996.

The Phoenix Assurance Company Limited changed its name to the PhoenixAssurance Public Limited Company effective December 1, 1989.

Norwich Union Fire Insurance Society Limited a cessé d’exercer des opérations auCanada. L’ordonnanceportantgarantie des risques au Canada a été annulée le24 juin 1998.

Phoenix Assurance Company of Canada: An order was issued December 1, 1989,whereby the property and business of Phoenix Assurance Company of Canadawas to be wound up into the Dominion Insurance Corporation.

Norwich Winterthur Reinsurance Corporation Limited a changé son nom en celuide NW Reinsurance Corporation Limited à compter du 5 novembre 1992.

Phoenix Assurance Public Limited Company, having transferred its Canadianliabilities to SunAlliance Insurance Company, ceased to be registered effectiveDecember 31, 1991.

Nova Scotia General Insurance Company a modifié sa dénomination sociale àcelle de Toronto Dominion Compagnie d’Assurance Générale à compter du7 février 1995.

Phoenix Mutual Life Insurance Company changed its name to Phoenix Home LifeMutual Insurance Company effective July 1, 1992.

NRG London Reinsurance Company Limited a cessé d’exercer des opérations auCanada et a cédé sonpassif canadien. L’ordonnanceportant garantie desrisques au Canada a été annulée le 31 décembre 1992.

Pitts Insurance Company’s certificate of registry was withdrawn effectiveOctober 19, 1981, and the company is being wound up under theprovisions oftheWinding-up Act.

NRG Victory Reinsurance Limited a cesser d’exercer des opérations d’assurance-vie et accidents et maladie à compter du 1er avril 1992.

Pohjola Insurance Company Ltd. (Vakuutusosakeyhtio Pohjola) changed its nameto Pohjola Group Insurance Corporation effective August 31, 1998.

The Omaha Indemnity Company : Conformément à la demande de la compagnie,l’ordonnanceportantgarantie des risques au Canadapar The Omaha IndemnityCompany a été annulée le 25janvier 1994.

Préservatrice Foncière T.I.A.R.D., having transferred its Canadianpolicies toNational Reinsurance Company of Canada, ceased to be registered effectiveJanuary 1, 1988.

The Orion Insurance Company Limited a changé son nom à The Orion InsuranceCompany PLC à compter du 11 septembre 1990.

La Préservatrice Société Anonyme d’Assurances contre les Accidents, l’Incendieet les Risques Divers, having transferred all of its Canadian liabilities toPréservatrice Foncière T.I.A.R.D., ceased transacting business in Canadaeffective August 9, 1982.

The Orion Insurance Company PLC : le 27 octobre 1994, le surintendant desinstitutions financières apris le contrôle de The Orion Insurance Company PLCet le 10 février 1995 la cour a demandé la liquidation de The Orion InsuranceCompany PLC sous lesprovisions de laLoi sur les liquidations, nommant lesurintendant au titre de liquidateur de la société. Deloitte & Touche Inc., lemandataire du liquidateur, se charge desprocédures de liquidation de la société.

Primerica Life Insurance Company ceased transacting business in Canada andtransferred its Canadianpolicies to Primerica Life Insurance Company ofCanada. The company’s order to insure in Canada risks was revoked effectiveAugust 19, 1994.

Les obligations de Pacific Employers Insurance Company ayant été transférées àCIGNA du Canada Compagnie d’assurance, la compagnie a cessé d’êtreenregistrée à compter du 27 octobre 1993.

Primmum Insurance Company changed its name to CT Direct Insurance Companyeffective March 10, 1998.

Pafco Compagnie Internationale d’Assurances a changé son nom à GraniteCompagnie d’Assurances à compter du 25juin 1991.

Principal Mutual Life Insurance Company changed its name to Principal LifeInsurance Company effective March 26, 1999.

Paragon, Compagnie d’Assurance du Canada a changé son nom en celui de laLaurentienne du Pacifique Compagnie d’Assurance à compter du 3 mai 1984.

Page 88: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

56 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

NOTE (A)—Continued REMARQUE (A)—(suite)

Protection Mutual Insurance Company, having amalgamated itsproperty andbusiness with that ofAllendale Mutual Insurance Company and ArkwrightMutual Insurance Company, pursuant to the laws of the United States ofAmerica, ceased to be registered effective July 1, 1999. The foreign companieswere continued to be registered as one mutual company under the name FactoryMutual Insurance Company, effective July 1, 1999.

La Patriote Compagnie d’Assurance-Vie est le nom adopté par La Balboa,compagnie d’assurance-viepour exercer des affaires au Canada. Depuis le9 janvier 1992, la compagnie utilise sonpropre nompour exercer des affaires.

Prudasco Assurance Company amalgamated itsproperty and business with that ofGeneral Accident Indemnity Company effective January 1, 1994, the continuingor combined company being General Accident Indemnity Company.

The Penn Mutual Life Insurance Company a cessé d’exercer des opérations auCanada. L’ordonnanceportantgarantie des risques au Canada a été annulée le9 juillet 1999.

Prudential Assurance Company of England Property and Casualty (Canada)changed its name to General Accident Indemnity Company effective August 31,1993.

Philadelphia Manufacturers Mutual Insurance Company a fusionné ses biens etopérations avec les biens et opérations de Arkwright-Boston ManufacturersMutual Insurance Company le 7 septembre 1984; la compagnie fusionnée ou lacompagnie prenant suite des opérations est Arkwright-Boston ManufacturersMutual Insurance Company.

The Prudential Group Assurance Company of England (Canada) changed its nameto Sun Life of Canada Group Assurance Company effective March 31, 1995.

La Phoenix Assurance Company Limited a modifié sa raison sociale le1er décembre 1989 et se nomme maintenant Phoenix Assurance Public LimitedCompany.

The Prudential Life Assurance Company of England (Canada) and The MutualLife Assurance Company of Canada amalgamated and were continued as onemutual company under the name The Mutual Life Assurance Company ofCanada effective April 1, 1995.

Les obligations de Phoenix Assurance Public Limited Company ayant ététransférées à Sun Alliance Compagnie d’Assurance, la compagnie a cessé d’êtreenregistrée à compter du 31 décembre 1991.

Prudential of America General Insurance Company (Canada) changed its name toLiberty Insurance Company of Canada, effective January 1, 1997.

Les biens et opérations de la Phoenix Compagnie d’Assurance du Canada ont étécédés à La Dominion Corporation d’Assurance et un décret a été émis en vertude la Loi sur les liquidationspour La Dominion Corporation d’Assurance au1er décembre 1989.

Prudential Reinsurance Company (of America) changed its name to EverestReinsurance Company effective May 21, 1996.

Phoenix Mutual Life Insurance Company a changé son nom en celui de PhoenixHome Life Mutual Insurance Company à compter du 1er juillet 1992.

QBE Insurance Limited, having disposed of its liabilities in Canada, ceased to beregistered effective March 31, 1987.

Pitts Compagnie d’Assurance : le certificat d’enregistrement a été retiré le19 octobre 1981 et la compagnie est maintenant en voie de liquidation en vertudes dispositions de laLoi sur les liquidations.

The Reinsurance Corporation of New York changed its name to The InsuranceCorporation of New York effective January 31, 1997.

Préservatrice Foncière T.I.A.R.D. a cessé d’exercer des opérations au Canada ettout sonpassif canadien a étépris en charge par La Nationale, Compagnie deRéassurance du Canada le 1er janvier 1988.

Retail Lumbermen’s Inter-Insurance Exchange having disposed of its liabilities inCanada ceased to be registered as at March 31, 1985.

La Préservatrice Société Anonyme d’Assurances contre les Accidents, l’Incendieet les Risques Divers a cessé d’exercer des opérations au Canada le 9 août1982; sonpassif canadien a étépris en charge par la Préservatrice FoncièreT.I.A.R.D.

Royal Exchange Assurance of America Inc. changed its name to FortressInsurance Company of America effective December 15, 1992.

Primmum Compagnie D’Assurance a modifié sa dénomination sociale à celle deCT assurance directe inc. à compter du 10 mars 1998.

Royal Insurance Company of Canada amalgamated itsproperty and business withthat of Sun Alliance Insurance Company effective January 1, 1994, thecontinuing or combined company being Royal Insurance Company of Canada.

Principal Mutual Life Insurance Company a modifié sa dénomination sociale àcelle de Compagnie d’assurance-vie Principal à compter du 26 mars 1999.

Royal Insurance Company of Canada changed its name to Royal & Sun AllianceInsurance Company of Canada effective March 23, 1998.

Protection Mutual Insurance Company a fusionné ses entreprise avec ceux deAllendale Mututal Insurance Company et ceux de Arkwright Mututal InsuranceCompany, et en vertu des lois desÉtats-Unis d’Amérique, son certificatd’enregistrement a été retiré le 1er juillet 1999. Les sociétés fusionnées ont étéprorogées en une société mutuelle fonctionnant sous la dénomination FactoryMutual Insurance Company, 1er juillet 1999.

Royal Life Insurance Company of Canada ceased transacting business in Canadaand transferred all of itspolicies to Royal Life Insurance Company of CanadaLimited, effective December 31, 1994. Royal Life Insurance Company ofCanada’s order to commence and carry on business was revoked effectiveDecember 31, 1994 and itsproperty was amalgamated with that of RoyalInsurance Company of Canada, the continuing company being Royal InsuranceCompany of Canada.

La Prudasco, Compagnie d’Assurance a fusionné ses biens et son entreprise avecceux de la Général Accident Indemnité Compagnie d’Assurance à compter du1er janvier 1994, la compagnie issue de la fusion étant la Général AccidentIndemnité Compagnie d’Assurance.

Royal Life Insurance Company of Canada Limited changed its name to Royal &Sun Alliance Life Insurance Company of Canada effective March 23, 1998.

Prudential Reinsurance Company (of America) a modifié sa dénomination socialeà celle de Everest Reinsurance Company depuis le 21 mai 1996.

Royal Life Insurance Limited ceased transacting business in Canada and disposedof its liabilities in Canada. The company’s order to insure in Canada risks wasrevoked effective November 24,1992.

Prudentielle d’Amérique, Compagnie d’Assurance Générale (Canada) a modifiésa dénomination sociale à celle de Compagnie d’Assurance Liberté du Canada,à compter du 1er janvier 1997.

Royal Reinsurance Company Limited, having transferred its Canadian liabilities toRoyal Insurance Company of Canada, ceased to be registered effectiveDecember 31, 1993.

La Prudentielle d’Angleterre, Compagnie d’Assurance Générale (Canada) achangé sa dénomination socialepour Général Accident Indemnité Compagnied’Assurance du 31 août 1993.

RoyNat Guarantee Corporation: At the company’s request, the certificate ofregistry of RoyNat Guarantee Corporation was discontinued effective June 21,1984.

La Prudentielle d’Angleterre Compagnie d’Assurance Collective (Canada) amodifié sa dénomination sociale à celle de Sun Life du Canada, compagnied’assurancegroupe à compter du 31 mars 1995.

Page 89: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 57

NOTE (A)—Continued REMARQUE (A)—(suite)

SAFECO Life Insurance Company, having disposed of its liabilities in Canada,ceased to be registered as at December 20, 1991.

La Prudentielle d’Angleterre, Compagnie d’assurance-vie (Canada) et La Mutuelledu Canada, compagnie d’assurance sur la vie ont été fusionnées etprorogées enune société mutuelle fonctionnant sous la dénomination sociale de La Mutuelledu Canada, compagnie d’assurance sur la vie le 1er avril 1995.

SAFR Société Anonyme Française de Réassurances changed its name to SAFReffective April 7, 1998.

QBE Insurance Limited a cédé sonpassif canadien. Le certificat d’enregistrementde la compagnie n’apas été renouvelé au 31 mars 1987.

SAFR changed its name to SAFR PartnerRe effective January 26, 2000. The Reinsurance Corporation of New York a modifié sa dénomination sociale àcelle de The Insurance Corporation of New York à compter du 31janvier 1997.

SCOR Reinsurance Company of Canada amalgamated itsproperty and businesswith that of two non-insurance entities, SCORFIN Inc. and SCOR ServicesCanada Inc., effective December 31, 1995, the continuing or combinedcompany being SCOR Canada Reinsurance Company.

Retail Lumbermen’s Inter-Insurance Exchange a cédé sonpassif canadien. Lecertificat d’enregistrement de la compagnie n’a pas été renouvelé au 31 mars1985.

The Scottish Dominion Insurance Company Limited ceased transacting businessin Canada. The company’s order to insure in Canada risks was revokedeffective December 1, 1998.

Royal Exchange Assurance of America Inc. a changé sa dénomination socialepour Compagnie d’assurance Forteresse d’Amérique à compter du 15 décembre1992.

Seaboard Surety Company: At the company’s request, the order to insure inCanada risks of Seaboard Surety Company was revoked effectiveJune 13,1995.

Royal Life Insurance Limited a cessé d’exercer des opérations au Canada et a cédésonpassif canadien. L’ordonnanceportantgarantie des risques au Canada a étéannulée le 24 novembre 1992.

Seaboard Surety Company of Canada amalgamated itsproperty and business withthat of Northern Indemnity, Inc. effective January 1, 2000, the continuing com-pany being Northern Indemnity, Inc.

Les obligations de Royal Reinsurance Company Limited ayant été transférées à LaRoyale du Canada, Compagnie d’Assurance, la compagnie a cessé d’êtreenregistrée à compter du 31 décembre 1993.

Security National Insurance Company changed the french version of its name toLa Sécurité Nationale Compagnie d’Assurance, effective October 21, 1997.

La Royale du Canada, Compagnie d’Assurance a fusionné ses biens et opérationsavec les biens et opérations de Sun Alliance Compagnie d’Assurance le1er janvier 1994; la compagnie résultant de cette fusion est La Royale duCanada, Compagnie d’Assurance.

Security National Insurance Company changed the french version of its name toSécurité Nationale Compagnie d’Assurance, effective April 6, 1998.

La Royale du Canada, Compagnie d’Assurance a modifié sa dénomination socialeà celle de Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances à compter du23 mars 1998.

Skandia Canada Reinsurance Company changed its name to Odyssey ReinsuranceCompany of Canada, effective November 5, 1996.

La Royale Vie du Canada, Compagnie d’Assurance a cessé d’exercer desopérations au Canada et tout sonpassif canadien a étépris en charge par LaRoyale Vie du Canada, compagnie d’assurance limitée. L’ordonnance defonctionnement de La Royale Vie du Canada, Compagnie d’Assurance a étéannulée le 31 décembre 1994, et ses biens ont été fusionné avec ceux de LaRoyale du Canada, Compagnie d’Assurance, la compagnie issue de la fusionétant La Royale du Canada, Compagnie d’Assurance.

Skandia Group Insurance Company Ltd. changed the name under which it insuresrisks in Canada to Skandia Insurance Company Ltd. effective December 23,1993.

La Royale Vie du Canada, compagnie d’assurance limitée a modifié sadénomination sociale à celle de Royal & Sun Alliance du Canada, sociétéd’assurance-vie à compter du 23 mars 1998.

Skandia Insurance Company changed its name in English to Skandia Group Insur-ance Company Ltd. effective December 17, 1990.

SAFECO Life Insurance Company a cédé sonpassif canadien. Le certificatd’enregistrement de la compagnie a été retiré le 20 décembre 1991.

Skandia International Insurance Corporation ceased transacting business in Can-ada. The company’s order to insure in Canada risks was revoked effectiveMarch 31, 2000.

SAFR a modifié sa dénomination sociale à celle de SAFR PartnerRe à compter du26 janvier 2000.

Société Anonyme Française de Réassurances changed its name to SAFR SociétéAnonyme Française de Réassurances effective June 17, 1996.

SAFR Société Anonyme Française de Réassurances a modifié sa dénominationsociale à celle de SAFR à compter du 7 avril 1998.

Société Commerciale de Réassurance: At the company’s request, the order toinsure in Canada risks of Société Commerciale de Réassurance was revokedeffective December 24, 1992.

SCOR Compagnie de Réassurance du Canada a fusionné ses biens et sonentreprise avec SCORFIN Inc. et Les Services SCOR Canada Inc., à compter du31 décembre 1995. La compagnie issue de la fusion est SCOR CanadaCompagnie de Réassurance.

Société de Réassurance des Assurances Mutuelles Agricoles ceased transactingbusiness in Canada. The company’s order to insure in Canada risks wasrevoked effective July 8, 1998.

The Scottish Dominion Insurance Company Limited a cessé d’exercer desopérations au Canada. L’ordonnanceportant garantie des risques au Canada aété annulée le 1er décembre 1998.

Sphere Reinsurance Company of Canada changed its name to Chequers InsuranceCompany effective August 31, 1989.

Seaboard Surety Company : Conformément à la demande de la compagnie,l’ordonnanceportant garantie des risques au Canadapar Seaboard SuretyCompany a été annulée le 13juin 1995.

The Stanstead and Sherbrooke Insurance Company amalgamated itsproperty andbusiness with that of The Canada Accident and Fire Assurance Company, andthat of Commercial Union Assurance Company of Canada effective January 1,1989, the continuing or combined company being Commercial UnionAssurance Company of Canada.

La Sécurité Nationale Compagnie d’Assurances a modifié la version française desa dénomination sociale à celle de La Sécurité Nationale Compagnied’Assurance à compter du 21 octobre 1997.

State Mutual Life Assurance Company of America changed its name to FirstAllmerica Financial Life Insurance Company effective May 13, 1996.

La Sécurité Nationale Compagnie d’Assurance a modifié la version française de sadénominationa sociale à celle de Sécurité Nationale Compagnie d’Assurance àcompter du 6 avril 1998.

Page 90: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

58 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

NOTE (A)—Continued REMARQUE (A)—(suite)

Stonewall Insurance Company, having disposed of its liabilities in Canada, ceasedto be registered effective March 27, 1990.

La Sécurité, Compagnie d’Assurancesgénérales du Canada, après l’adoptiond’une Loi d’intérêt privé par le Sénat du Canada, a étéprorogée par lettrespatentes de continuation comme compagnie d’assurance de laprovince deQuébec, en date du 1er décembre 1994, sous la dénomination sociale de LASÉCURITÉ, COMPAGNIE D’ASSURANCES GÉNÉRALES DU CANADAINC.

Storebrand International Insurance A/S changed its name to UNI StorebrandInternational Insurance A/S effective October 30, 1991.

Skandia Canada Compagnie de Réassurance a modifié sa dénomination sociale àcelle de Odyssey, société canadienne de réassurance, à compter du 5 novembre1996.

Storebrand Reinsurance Company Ltd. changed its name to StorebrandInternational Insurance A/S effective March 12, 1991.

Skandia Groupe, Société Anonyme d’Assurances a changé sa raison sociale auCanada à Skandia Société Anonyme d’Assurances à compter du 23 décembre1993.

The Strathcona General Insurance Company amalgamated its property andbusiness with that of Northumberland General Insurance Company effectiveAugust 31, 1983, the continuing or combined company being NorthumberlandGeneral Insurance Company;

Skandia Insurance Company a modifié sa dénomination sociale à Skandia Groupe,Société Anonyme d’Assurances, le 17 décembre 1990.

Sun Alliance and London Assurance Company Limited, having transferred itsCanadian liabilities to SunAlliance and London Assurance Company (Canada),had its order to insure in Canada risks revoked effective November 24,1992.

Skandia International Insurance Corporation a cessé d’exercer des opérations auCanada. L’ordonnanceportantgarantie des risques au Canada a été annulée le31 mars 2000.

Sun Alliance and London Assurance Company (Canada) changed its name to TBDLife Insurance Company effective August 1, 1995.

Société Anonyme Française de Réassurances a modifié sa dénomination sociale àcelle de SAFR Société Anonyme Française de Réassurances à compter du17 juin 1996.

Sun Alliance Insurance Company amalgamated itsproperty and business with thatof Royal Insurance Company of Canada effective January 1, 1994, thecontinuing or combined company being Royal Insurance Company of Canada.

Société D’Assurance-Crédit Industriel : le certificat d’enregistrement a été retiré le5 octobre 1984, conformément à la demande de la compagnie.

Swiss Re Life Company America changed its name to Swiss Re Life & HealthAmerica Inc. effective January 27, 1998.

La Société d’Assurance-Vie Norwich Union a cessé d’exercer des opérations auCanada et sonpassif canadien a étépris en charge par Norwich Union duCanada, Compagnie d’assurance-vie. L’ordonnanceportantgarantie des risquesau Canada a été annulée le 30 septembre 1997.

Swiss Re Life Canada changed its name to Swiss Re Life & Health Canadaeffective June 2, 1997.

Société Canadienne de Réassurance a modifié sa dénomination sociale à celle deCompagnie Suisse de Réassurance Canada à compter du 5juin 1995.

Swiss Union General Insurance Company Limited ceased transacting business inCanada. The company’s order to insure in Canada risks was revoked effectiveDecember 22, 1998.

Société Commerciale de Réassurance : Conformément à la demande de lacompagnie, l’ordonnanceportant garantie des risques au Canadapar SociétéCommerciale de Réassurance a été annulée le 24 décembre 1992.

Switzerland General Insurance Company, Limited: At the company’s request, theorder to insure in Canada risks of Switzerland General Insurance Company,Limited was revoked effective November 21,1995.

Société de Réassurance des Assurances Mutuelles Agricoles a cessé d’exercer desopérations au Canada. L’ordonnanceportant garantie des risques au Canada aété annulée le 8juillet 1998.

Symons General Insurance Company changed its name to Pafco InternationalInsurance Company effective December 22, 1988.

State Mutual Life Assurance Company of America a modifié sa dénominationsociale à celle de First Allmerica Financial Life Insurance Company à compterdu 13 mai 1996.

Taisho Marine and Fire Insurance Company, Limited changed its name to MitsuiMarine and Fire Insurance Company, Limited effective May 2, 1991.

Stonewall Insurance Company a aliéné sonpassif au Canada et n’estplusenregistrée depuis le 27 mars 1990.

Teachers Insurance and Annuity Association of America ceased transactingbusiness in Canada and transferred its Canadianpolicies to Sun Life AssuranceCompany of Canada. The company’s order to insure in Canada risks wasrevoked effective April 6, 1998.

Storebrand International Insurance A/S a changé son nom en celui de UNIStorebrand International Insurance A/S à compter du 30 octobre 1991.

TIG Reinsurance Company changed its name to Odyssey America ReinsuranceCorporation effective January 26, 2000.

Storebrand Reinsurance Company Ltd. a changé son nom en celui de StorebrandInternational Insurance A/S à compter du 12 mars 1991.

Toa-Re Insurance Company of America changed its name to The Toa ReinsuranceCompany of America effective August 16, 1999.

Suisse de Réassurance Vie Canada a modifié sa dénomination sociale à celle deSuisse de Réassurances Vie et Santé Canada à compter du 2juin 1997.

Toro Assicurazioni S.P.A., having transferred its Canadian liabilities to SunAlliance Insurance Company, ceased to be registered effective December 21,1990.

Sun Alliance and London Assurance Company Limited a cessé d’exercer desopérations au Canada et tout sonpassif canadien a étépris en charge par LaCompagnie d’Assurance Sun Alliance & London (Canada). L’ordonnanceportantgarantie des risques au Canada a été annulée le 24 novembre 1992.

Toronto General Insurance Company amalgamated itsproperty and business withthat of Canadian General Insurance Company effective January 1, 1994, thecontinuing or combined company being Canadian General Insurance Company.

Sun Alliance Compagnie d’Assurance a fusionné ses biens et opérations avec lesbiens et opérations de La Royale du Canada, Compagnie d’Assurance le1er janvier 1994; la compagnie résultant de cette fusion est La Royale duCanada, Compagnie d’Assurance.

Tower Insurance Company of Connecticut changed its name to New EnglandReinsurance Corporation effective February 29, 1984.

Swiss Re Life Company America a modifié sa dénomination sociale à celle deSwiss Re Life & Health America Inc. à compter du 27janvier 1998.

Traders General Insurance Company amalgamated itsproperty and business withthat of GAN Canada Insurance Company effective December 31, 1999, thecontinuing company being Traders General Insurance Company.

Switzerland General Insurance Company, Limited : Conformément à la demandede la société, l’ordonnanceportant garantie des risques au CanadaparSwitzerland General Insurance Company, Limited a été annulée le 21 novembre1995.

Page 91: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 59

NOTE (A)—Continued REMARQUE (A)—(suite)

Trafalgar Insurance Company of Canada amalgamated itsproperty and businesswith that of The Canadian Commerce Insurance Company effective January 1,1993, the continuing or combined company being Trafalgar Insurance Companyof Canada.

Symons Compagnie d’Assurances Générales a changé son nom en PafcoCompagnie Internationale d’Assurances à compter du 22 décembre 1988.

Trafalgar Insurance Public Limited Company, having transferred its Canadianliabilities to Trafalgar Insurance Company of Canada, ceased to be registeredeffective December 31, 1986.

Taisho Marine and Fire Insurance Company, Limited a changé son nom à MitsuiMarine and Fire Insurance Company, Limited à compter du 2 mai 1991.

Transamerica Insurance Company changed the name under which it insures risksin Canada to TIG Insurance Company effective December 29, 1993.

Teachers Insurance and Annuity Association of America a cessé d’exercer desopérations au Canada et tout sonpassif canadien a étépris en charge par SunLife du Canada, compagnie d’assurance-vie. L’ordonnanceportantgarantie desrisques au Canada a été annulée le 6 avril 1998.

Transamerica Occidental Life Insurance Company ceased transacting business inCanada and transferred its Canadianpolicies to Transamerica Life InsuranceCompany of Canada. The company’s order to insure in Canada risks wasrevoked effective April 12, 1995.

The Toa-Re Insurance Company of America a modifié sa dénomination sociale àcelle de The Toa Reinsurance Company of America à compter du 16 août 1999.

Transport Indemnity Company changed its name to Mission American InsuranceCompany effective June 16, 1986.

Les obligations au Canada de Toro Assicurazioni S.P.A. ayant été transférées àSun Alliance Compagnie d’Assurance, la compagnie a cessé d’être enregistréeà compter du 21 décembre 1990.

Transport Insurance Company: At the company’s request, the order to insure inCanada risks of Transport Insurance Company was revoked effective December31, 1994.

Tower Insurance Company of Connecticut a changé son nom en celui de NewEngland Reinsurance Corporation à compter du 29 février 1984.

Travelers Indemnity Company of Canada changed its name to Zurich IndemnityCompany of Canada effective February 9, 1989.

Trafalgar Insurance Public Limited Company a cessé d’exercer des opérations auCanada le 31 décembre 1986; sonpassif canadien a étépris en charge par laCompagnie d’Assurance Trafalgar du Canada.

Truck Insurance Exchange: At the request of the company, the order to insure inCanada risks of Truck Insurance Exchange was revoked effective December 21,1992.

Transamerica Insurance Company a changé sa raison sociale au Canada à Sociétéd’Assurance TIG à compter du 29 décembre 1993.

Trygg-Hansa Reinsurance Company of Canada changed its name to SueciaReinsurance Company effective January 21, 2000.

Transport Indemnity Company a changé son nom en celui de Mission AmericanInsurance Company à compter du 16juin 1986.

Underwriters National Assurance Company’s certificate of registry was withdrawneffective December 29, 1976. The company’s business in Canada, which wasbeing continued under a compromise arrangement sanctioned by the SupremeCourt of Ontario, was transferred to Life Investors Insurance Company ofAmerica effective July 31, 1991.

Transport Insurance Company : Conformément à la demande de la compagnie,l’ordonnanceportant garantie des risques au Canadapar Transport InsuranceCompany a été annulée le 31 décembre 1994.

Uni Storebrand International Insurance A/S ceased transacting business inCanada. The company’s order to insure in Canada risks was revoked effectiveApril 8, 1997.

Travelers du Canada, Compagnie d’Indemnité a changé son nom en celui deZurich Du Canada, Compagnie d’Indemnité à compter du 9 février 1989.

Unigard Mutual Insurance Company changed its name to Unigard SecurityInsurance Company effective December 20, 1984.

Truck Insurance Exchange : Conformément à la demande de la compagnie,l’ordonnanceportant garantie des risques au Canadapar Truck InsuranceExchange a été annulée le 21 décembre 1992.

Union Reinsurance Company: At the company’s request, the order to insure inCanada risks of Union Reinsurance Company was revoked effectiveJune 15,1994.

Trygg-Hansa Reinsurance Company of Canada a modifié sa dénomination socialeà celle de Compagnie de réassurance Suecia à compter du 21janvier 2000.

Unione Italiana di Riassicurazione S.p.A. changed its name to Swiss Re ItaliaS.p.A. effective August 28, 1998.

Underwriters National Assurance Company : le certificat d’enregistrement a étéretiré le 20 décembre 1976. Les affaires au Canadaqui avaient été continuéesselon uneproposition de concordat sanctionnéepar la Cour Suprême d’Ontarioont été transférées à Life Investors Insurance Company of America le 31juillet1991.

United Canada Insurance Company’s certificate of registry was not renewedeffective March 1, 1986, and the company is being wound-up under theprovisions of theWinding-up Act.

Uni Storebrand International Insurance A/S a cessé d’exercer des opérations auCanada. L’ordonnanceportantgarantie des risques au Canada a été annulée le8 avril 1997.

United States Fire Insurance Company: At the request of the company, the orderto insure in Canada risks of United States Fire Insurance Company was revokedeffective December 10, 1992.

Unigard Mutual Insurance Company a changé son nom en celui de UnigardSecurity Insurance Company à compter du 20 décembre 1984.

United Transportation Union Insurance Association ceased transacting business inCanada. The society’s order to insure in Canada risks was revoked effectiveMarch 14, 1995.

Union Reinsurance Company : Conformément à la demande de la compagnie,l’ordonnanceportant garantie des risques au Canadapar Union ReinsuranceCompany a été annulée le 15juin 1994.

The Unity Fire and General Insurance Company ceased transacting business inCanada. The company’s order to insure in Canada risks was revoked effectiveDecember 31, 1998.

Union Suisse Compagnie Générale d’Assurances a cessé d’exercer des opérationsau Canada. L’ordonnanceportantgarantie des risques au Canada a été annuléele 22 décembre 1998.

UNUM Life I nsurance Company changed its name to UNUM Life InsuranceCompany of America as at December 31, 1991.

Unione Italiana di Riassicurazione S.p.A. a modifié sa dénomination sociale àcelle de Swiss Re Italia S.p.A. à compter du 28 août 1998.

USF&G Insurance Company of Canada amalgamated itsproperty and businesswith that of Canadian General Insurance Company effective June 30, 1990, thecontinuing or combined company being Canadian General Insurance Company.

United States Fire Insurance Company : Conformément à la demande de lacompagnie, l’ordonnanceportant garantie des risques au Canadapar UnitedStates Fire Insurance Company a été annulée le 10 décembre 1992.

Page 92: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

60 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

NOTE (A)—Continued REMARQUE (A)—(suite)

US International Reinsurance Company ceased transacting business in Canada.The company’s order to insure in Canada risks was revoked effectiveOctober 8, 1997.

United Transportation Union Insurance Association a cessé d’exercer desopérations au Canada. L’ordonnanceportant garantie des risques au Canada aété annulée le 14 mars 1995.

Victoria Insurance Company of Canada amalgamated itsproperty and businesswith that of Traders General Insurance Company effective January 1, 1996, thecontinuing or combined company being Traders General Insurance Company.

Unity Fire and General Insurance Company a cessé d’exercer des opérations auCanada. L’ordonnanceportantgarantie des risques au Canada a été annulée le31 décembre 1998.

The Victory Reinsurance Company Limited changed its name to NRG VictoryReinsurance Limited effective December 18, 1991.

L’UNUM Compagnie d’Assurance-vie a changé son nom en celui de L’UNUMd’Amérique, Compagnie d’Assurance-vie à compter du 31 décembre 1991.

Warner Reciprocal Insurers, having disposed of its liabilities in Canada, ceased tobe registered effective March 31, 1986.

US International Reinsurance Company a cessé d’exercer des opérations auCanada. L’ordonnanceportantgarantie des risques au Canada a été annulée le8 octobre 1997.

The Wawanesa Mutual Life Insurance Company changed its name to TheWawanesa Life Insurance Company effective at October 1, 1993.

The Victory Reinsurance Company Limited a changé son nom en celui de NRGVictory Reinsurance Limited à compter du 18 décembre 1991.

Wellington Insurance Company changed its French name to Compagnied’Assurance Wellington effective August 11, 1986.

Warner Reciprocal Insurers a cédé sonpassif canadien. Le certificatd’enregistrement de la compagnie n’apas été renouvelé au 31 mars 1986.

Western General Mutual Insurance Company amalgamated its property andbusiness with that of Economical Mutual Insurance Company effectiveJanuary 1, 1997, the continuing company being Economical Mutual InsuranceCompany.

Western General Mutual Insurance Company a fusionné ses biens et sonentreprise avec Economical, Compagnie Mutuelle d’Assurance, à compter du1er janvier 1997. La compagnie issue de la fusion est Economical, CompagnieMutuelle d’Assurance.

Winterthur Reinsurance Corporation of America ceased transacting business inCanada. The company’s order to insure in Canada risks was revoked effectiveDecember 22, 1999.

Winterthur Reinsurance Corporation of America a cessé d’exercer des opérationsau Canada. L’ordonnanceportantgarantie des risques au Canada a été annuléele 22 décembre 1999.

Woodmen of the World Life Insurance Society ceased transacting business inCanada. The society’s order to insure in Canada risks was revoked effectiveDecember 1, 1994.

Woodmen of the World Life Insurance Society a cessé d’exercer des opérations auCanada. L’ordonnanceportantgarantie des risques au Canada a été annulée le1er décembre 1994.

The Workmen’s Circle ceased transacting business in Canada. The society’s orderto insure in Canada risks was revoked effective December 31,1996.

The Workmen’s Circle a cessé d’exercer des opérations au Canada. L’ordonnanceportantgarantie des risques au Canada a été annulée le 31 décembre 1996.

Zurich Indemnity Company of Canada changed its name to Peopleplus InsuranceCompany effective February 1, 1999.

Zurich du Canada, Compagnie d’Indemnité a modifié sa dénomination sociale àcelle de Omnimonde, Compagnie d’assurances à compter du 1er février 1999.

Zurich Life Insurance Company of Canada and its wholly-owned subsidiary,Zurich Life & Health Insurance Company of Canada, amalgamated and werecontinued as one company under the name Zurich Life Insurance Company ofCanada effective January 1, 1993.

Zurich du Canada Compagnie d’Assurance-Vie et sa filiale enpropriété exclusive,Zurich du Canada, Compagnie d’Assurance-Vie & Santé, ont été fusionnées etprorogées en une société fonctionnant sous la dénomination sociale de Zurichdu Canada Compagnie d’Assurance-Vie le 1er janvier 1993.

NOTE (B)— REMARQUE (B)—

Additional classes referred to in classes of insurance for which registered are asfollows—

Les catégories additionnelles dont il estquestion dans les catégories d’affairesd’assurance enregistrées sont comme il suit :

1. Civil Commotion Insurance 1. L’assurance contre l’agitation civile

2. Earthquake Insurance 2. L’assurance contre les tremblements de terre

3. Falling Aircraft Insurance 3. L’assurance contre la chute d’aéronefs

4. Hail Insurance 4. L’assurance contre lagrêle

5. Impact by Vehicles Insurance 5. L’assurance contre l’impact de véhicules

6. Limited or Inherent Explosion Insurance 6. L’assurance contre les explosions rattachables à l’affectation du risque

7. Sprinkler Leakage Insurance 7. L’assurance contre le coulage des extincteurs automatiques

8. Water Damage Insurance 8. L’assurance contre les dégâts des eaux

9. Weather Insurance 9. L’assurance contre les intempéries

10. Windstorm Insurance 10. L’assurance contre les tempêtes de vent

and are limited to the insurance of the sameproperty as is insured against the riskof fire under apolicy of the company.

et sont limitées à l’assurance des mêmes biensqui sont assurés contre l’incendieen vertu d’unepolice de la compagnie.

Limited Personal Accident Insurance means Personal Accident Insurance,provided in connection with apolicy of automobile insurance insuring againstliabilit y for bodily injuries, limited to expenses incurred arising from bodilyinjuries suffered by driver andpassengers and resulting from the ownership oroperation of an automobile.

L’expression « accidents corporels restreints » désigne l’assurance accident despersonnesqui est fournie de concert avec unepolice d’assurance automobileassurant la responsabilité des blessures corporelles, limitée aux dépenses faitesen conséquence de blessures corporelles subiespar le conducteur et lespassagers,qui découle de lapropriété ou du fonctionnement d’une automobile.

OFFICE OF THE SUPERINTENDENT BUREAU DU SURINTENDANT

OF FINANCIAL INSTITUTIONS, John R. Palmer DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES, Le surintendant

OTTAWA. Superintendent OTTAWA. John R. Palmer

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, represented by theMinister of Public Works and Government Services, 2000

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentéepar leministre des Travauxpublics et des Servicesgouvernementaux, 2000

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2000

Page 93: Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no Canada Gazette du Canada

If undelivered, return COVER ONLY to:Canadian Government PublishingPublic Works and Government Services

CanadaOttawa, Canada K1A 0S9

En cas de non-livraison,retourner cette COUVERTURE SEULEMENT à :Les Éditions du gouvernement du CanadaTravaux publics et Services gouvernementaux

CanadaOttawa, Canada K1A 0S9

Available from Canadian Government PublishingPublic Works and Government Services CanadaOttawa, Canada K1A 0S9

En vente : Les Éditions du gouvernement du CanadaTravaux publics et Services gouvernementaux Canada

Ottawa, Canada K1A 0S9